LOTHIAN ELECTRIC MACHINES LIMITED

LOTHIAN ELECTRIC MACHINES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLOTHIAN ELECTRIC MACHINES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC036737
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LOTHIAN ELECTRIC MACHINES LIMITED ?

    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières

    Où se situe LOTHIAN ELECTRIC MACHINES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hospital Rd
    Haddington
    EH41 3PD East Lothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LOTHIAN ELECTRIC MACHINES LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour LOTHIAN ELECTRIC MACHINES LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au19 mars 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation02 avr. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au19 mars 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour LOTHIAN ELECTRIC MACHINES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Modification des coordonnées du secrétaire Morton Fraser Secretaries Limited le 14 oct. 2024

    1 pagesCH04

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2023

    41 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2022

    39 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2021

    35 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Andrew John Limmer en tant que directeur le 01 déc. 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Morton Fraser Secretaries Limited en tant que secrétaire le 21 déc. 2021

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Andrew John Limmer en tant que secrétaire le 01 déc. 2021

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Andrew Roy Burgess en tant qu'administrateur le 08 nov. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Andrew John Limmer en tant qu'administrateur le 30 sept. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Elizabeth Blunsum en tant que directeur le 30 sept. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2020

    34 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2019

    35 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2018

    36 pagesAA

    Nomination de Mr Andrew John Limmer en tant que secrétaire le 10 juin 2019

    2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Graham John Moore en tant que secrétaire le 12 nov. 2018

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2017

    37 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Graham John Moore en tant que secrétaire le 17 oct. 2017

    2 pagesAP03

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2016

    40 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de LOTHIAN ELECTRIC MACHINES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MFMAC SECRETARIES LIMITED
    9 Haymarket Square
    EH3 8RY Edinburgh
    Level 5,
    Scotland
    Secrétaire
    9 Haymarket Square
    EH3 8RY Edinburgh
    Level 5,
    Scotland
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrementSC262093
    95512800022
    BURGESS, Andrew Roy
    Hospital Rd
    Haddington
    EH41 3PD East Lothian
    Administrateur
    Hospital Rd
    Haddington
    EH41 3PD East Lothian
    ScotlandBritishDirector290764210001
    BELMONT, David Gresford
    4 Glenview Close
    Shipley
    BD18 4AZ Shipley
    .
    West Yorkshire
    Uk
    Secrétaire
    4 Glenview Close
    Shipley
    BD18 4AZ Shipley
    .
    West Yorkshire
    Uk
    British138188230001
    HIGGIN, Roy
    3 Gifford Gate
    EH41 4AS Haddington
    East Lothian
    Scotland
    Secrétaire
    3 Gifford Gate
    EH41 4AS Haddington
    East Lothian
    Scotland
    British544210001
    KENNEDY, Joanne Helen
    11 Spring Hall Close
    HX3 7NE Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    11 Spring Hall Close
    HX3 7NE Halifax
    West Yorkshire
    UkAccountant48723210002
    LIMMER, Andrew John
    Hospital Rd
    Haddington
    EH41 3PD East Lothian
    Secrétaire
    Hospital Rd
    Haddington
    EH41 3PD East Lothian
    259690270001
    MERCER, Brian William
    17 Ben Sayers Park
    EH39 5PT North Berwick
    Secrétaire
    17 Ben Sayers Park
    EH39 5PT North Berwick
    BritishSad279990002
    MOORE, Graham John
    Hospital Rd
    Haddington
    EH41 3PD East Lothian
    Secrétaire
    Hospital Rd
    Haddington
    EH41 3PD East Lothian
    239410750001
    MERCER ASSOCIATES
    3 Argyle Grove
    FK15 9DT Dunblane
    Secrétaire
    3 Argyle Grove
    FK15 9DT Dunblane
    52126660001
    BLUNSUM, Elizabeth
    The Auld Barn
    Dippoul Farm
    ML11 8LJ Carnwarth
    Lanark
    Administrateur
    The Auld Barn
    Dippoul Farm
    ML11 8LJ Carnwarth
    Lanark
    ScotlandScottishDirector98738890002
    CHAPMAN, John Alexander
    1 Wester Broomhouse Cottages
    EH42 1RD Dunbar
    East Lothian
    Administrateur
    1 Wester Broomhouse Cottages
    EH42 1RD Dunbar
    East Lothian
    BritishManufacturing Director544230001
    HAMPSHIRE, Andrew
    11 Gala Green
    EH42 1NQ Dunbar
    East Lothian
    Administrateur
    11 Gala Green
    EH42 1NQ Dunbar
    East Lothian
    BritishCompany Director41703540001
    HENDERSON, William Shields
    Park House 13 Greenhill Park
    EH10 4DW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Park House 13 Greenhill Park
    EH10 4DW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishChartered Accountant55090001
    HIGGIN, Roy
    3 Gifford Gate
    EH41 4AS Haddington
    East Lothian
    Scotland
    Administrateur
    3 Gifford Gate
    EH41 4AS Haddington
    East Lothian
    Scotland
    BritishCompany Secretary/Accountant544210001
    INGHAM, David Arthur
    5 Edinburgh Road
    EH33 1BA Tranent
    East Lothian
    Administrateur
    5 Edinburgh Road
    EH33 1BA Tranent
    East Lothian
    BritishEngineer52127230001
    KENNEDY, Joanne Helen
    11 Spring Hall Close
    HX3 7NE Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    11 Spring Hall Close
    HX3 7NE Halifax
    West Yorkshire
    United KingdomUkDirector48723210002
    LIMMER, Andrew John
    Hospital Rd
    Haddington
    EH41 3PD East Lothian
    Administrateur
    Hospital Rd
    Haddington
    EH41 3PD East Lothian
    United KingdomBritishChartered Accountant287897980001
    MACLEAN, John Kenneth Lindsay
    21 Keppel Road
    EH39 4QG North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    21 Keppel Road
    EH39 4QG North Berwick
    East Lothian
    BritishEngineer52127190001
    MARTIN, David Stuart
    2 Spylaw Avenue
    EH13 0LR Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    2 Spylaw Avenue
    EH13 0LR Edinburgh
    Midlothian
    BritishMechanical Engineer70256380001
    MCCALLUM, John
    56 Grange Loan
    EH9 2EP Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    56 Grange Loan
    EH9 2EP Edinburgh
    Midlothian
    BritishManaging Director545140001
    MERCER, Brian William
    17 Ben Sayers Park
    EH39 5PT North Berwick
    Administrateur
    17 Ben Sayers Park
    EH39 5PT North Berwick
    United KingdomBritishCompany Director279990002
    PARKIN, Anthony
    8 Tor View
    HD7 7BQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    8 Tor View
    HD7 7BQ Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishSales & Marketing Director52127150001
    POULTON, Derek John
    Millside School Lane
    South Cerney
    GL7 5TZ Cirencester
    Administrateur
    Millside School Lane
    South Cerney
    GL7 5TZ Cirencester
    United KingdomBritishDirector34728950001
    RITCHIE, Alastair James
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    BritishCompany Director38770080002
    THOMSON, John
    78 Martin Brae
    Ladywell
    EH54 6UT Livingston
    Administrateur
    78 Martin Brae
    Ladywell
    EH54 6UT Livingston
    BritishEngineer80133540001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LOTHIAN ELECTRIC MACHINES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Hospital Road
    Haddington
    1
    East Lothian
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Hospital Road
    Haddington
    1
    East Lothian
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc382393
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    LOTHIAN ELECTRIC MACHINES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 23 juil. 2009
    Livré le 01 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 août 2009Enregistrement d'une charge (410)
    Fixed charge
    Créé le 21 janv. 2002
    Livré le 31 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All english book debts of the company. For these purposes "english book debts" shall mean any book debts which are receivable by the company in england or which are governed by english law whether now or hereafter existing and whether presently payable or hereafter falling due for payment.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 janv. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 nov. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 06 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Floating charge
    Créé le 21 janv. 2002
    Livré le 31 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 janv. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 20 nov. 1989
    Livré le 29 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    9.104 acres (under exception of .13 hectare) at hospital rd, haddington.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 12 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Letter of offset
    Créé le 17 mai 1984
    Livré le 23 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by industrial solenoids limited and/or others
    Brèves mentions
    Balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in the name of lothian electric machines limited.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 mai 1984Enregistrement d'une charge
    • 03 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 10 mai 1983
    Livré le 26 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Andrew David Michael Ingram and Others
    Transactions
    • 26 mai 1983Enregistrement d'une charge
    Guarantee and debenture
    Créé le 10 mai 1983
    Livré le 31 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £150,000 by the mycalex company
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Co-Operative Insurance Society
    Transactions
    • 31 mai 1983Enregistrement d'une charge
    • 28 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Letter of offset
    Créé le 27 avr. 1983
    Livré le 29 avr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due and others
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of lothian electric machines limited.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 avr. 1983Enregistrement d'une charge
    • 03 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 12 nov. 1976
    Livré le 16 nov. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 nov. 1976Enregistrement d'une charge
    • 20 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0