UA GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéUA GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC037130
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de UA GROUP LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe UA GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de UA GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    UNITED AUCTIONS (SCOTLAND) PUBLIC LIMITED COMPANY29 déc. 196129 déc. 1961

    Quels sont les derniers comptes de UA GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour UA GROUP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour UA GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Avis de fin de l'administration

    13 pages2.23B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    14 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    14 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    14 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    13 pages2.20B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    Avis de pétition pour une ordonnance d'administration

    2.2B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    2.11B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Avis de pétition pour une ordonnance d'administration

    1 pages2.2B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    16 pages2.20B(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    80 pages2.16B(Scot)

    legacy

    1 pages2.18B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.14B(SCOT)

    18 pages2.15B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de * Elphinstone House 295 Fenwick Road, Giffnock Glasgow G46 6UH* le 07 oct. 2010

    2 pagesAD01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2009 au 30 juin 2010

    3 pagesAA01

    Modification des coordonnées du secrétaire John Keith Martin le 01 juin 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Keith Martin le 01 juin 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Kenneth Ross le 01 juin 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Campbell Black le 01 juin 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2008

    7 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de UA GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARTIN, John Keith
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Secrétaire
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    British45302060001
    BLACK, Campbell
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Administrateur
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    United KingdomBritish112031270001
    MARTIN, John Keith
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Administrateur
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    ScotlandBritish45302060001
    ROSS, Kenneth
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Administrateur
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    ScotlandBritish41012110004
    ADAMSON, Conrad Falconer Patterson
    5 Windsor Gardens
    EH21 7LP Musselburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    5 Windsor Gardens
    EH21 7LP Musselburgh
    Midlothian
    British340760001
    BARNETT, William Macnab
    Altnabean
    PH11 8DP Alyth
    Perthshire
    Secrétaire
    Altnabean
    PH11 8DP Alyth
    Perthshire
    British139680001
    MC WILLIAMS, Arthur Colman
    2 Regency Court
    ML3 7EA Hamilton
    Lanarkshire
    Secrétaire
    2 Regency Court
    ML3 7EA Hamilton
    Lanarkshire
    American8209240002
    BURNESS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secrétaire
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    99448920001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secrétaire désigné
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    BARNETT, William Macnab
    Altnabean
    PH11 8DP Alyth
    Perthshire
    Administrateur
    Altnabean
    PH11 8DP Alyth
    Perthshire
    British139680001
    CAMERON, John Bell
    Balbuthie
    KY9 1EX Leven
    Fife
    Administrateur
    Balbuthie
    KY9 1EX Leven
    Fife
    ScotlandBritish203550001
    DANSON, David Laurence George
    19/7 South Gray Street
    EH9 1TE Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    19/7 South Gray Street
    EH9 1TE Edinburgh
    Lothian
    British59367160002
    DAVIDSON, Joanna Rosalind, The Hon
    Easter Leckie
    Gargunnock
    FK8 3BN Stirling
    Administrateur
    Easter Leckie
    Gargunnock
    FK8 3BN Stirling
    British53039790001
    FRASER, Rowland Lovat
    Parkfield House
    PH2 7PG Perth
    Administrateur
    Parkfield House
    PH2 7PG Perth
    British139690001
    GRAHAME, Joan Suzanne
    19 Barclay Place
    FK15 0FB Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    19 Barclay Place
    FK15 0FB Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish75723440003
    HALLEY, Peter
    Lochlane
    PH7 4HT Crieff
    Perthshire
    Administrateur
    Lochlane
    PH7 4HT Crieff
    Perthshire
    British352400002
    IZAT, Alexander John Rennie
    High
    Cocklaw
    TD15 1UZ Berwick-Upon-Tweed
    Administrateur
    High
    Cocklaw
    TD15 1UZ Berwick-Upon-Tweed
    EnglandBritish52978120002
    LEGGAT, Hugh David
    Garry Cottage
    Bankfoot
    PH1 4AT Perth
    Perthshire
    Administrateur
    Garry Cottage
    Bankfoot
    PH1 4AT Perth
    Perthshire
    PerthBritish686400001
    LINDSAY, James Randolph, Earl Of Lindsay
    Lahill House
    Upper Largo
    KY8 6JE Leven
    Fife
    Administrateur
    Lahill House
    Upper Largo
    KY8 6JE Leven
    Fife
    ScotlandBritish65541090001
    MC WILLIAMS, Arthur Colman
    2 Regency Court
    ML3 7EA Hamilton
    Lanarkshire
    Administrateur
    2 Regency Court
    ML3 7EA Hamilton
    Lanarkshire
    American8209240002
    MCGREGOR, Alan James Robley
    Muirhead
    Rhynd
    PH2 8QE Perth
    Administrateur
    Muirhead
    Rhynd
    PH2 8QE Perth
    ScotlandBritish56420760001
    MCKENZIE, Norman Donald
    Dunkirk Park
    Bridge Of Earn
    PH2 9DY Perth
    Administrateur
    Dunkirk Park
    Bridge Of Earn
    PH2 9DY Perth
    British686420001
    MITCHELL, Arthur Nicoll
    Leuchars Castle
    Fife
    Administrateur
    Leuchars Castle
    Fife
    British641370001
    MITCHELL, Colin Henry Whiteford
    Ardtornish
    Strathkinness Road
    KY16 9UB St Andrews
    Fife
    Administrateur
    Ardtornish
    Strathkinness Road
    KY16 9UB St Andrews
    Fife
    British37779160001
    MONCREIFFE, Peregrine David Euan Malcolm, Hon
    Easter Moncreiffe
    PH2 8QA Bridge Of Earn
    Perthshire
    Administrateur
    Easter Moncreiffe
    PH2 8QA Bridge Of Earn
    Perthshire
    British79267610001
    SANDERSON, Charles Russell, Lord
    Beckettsfield
    Bowden
    TD6 0ST Melrose
    Roxburghshire
    Administrateur
    Beckettsfield
    Bowden
    TD6 0ST Melrose
    Roxburghshire
    ScotlandBritish1362030001
    STRACHAN, Arthur Morton
    Avondale
    52 Roman Way
    FK15 9DJ Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    Avondale
    52 Roman Way
    FK15 9DJ Dunblane
    Perthshire
    British74545880001
    TOUGH, Kenneth Liddell
    17 Elphinstone Road
    Giffnock
    G46 6TF Glasgow
    Administrateur
    17 Elphinstone Road
    Giffnock
    G46 6TF Glasgow
    United KingdomBritish33189110001
    WEIR, James
    Netherby
    FK9 4 Bridge Of Allan
    Administrateur
    Netherby
    FK9 4 Bridge Of Allan
    British448970001
    WIGHT, John James
    Midlock
    Crawford
    ML12 6UA Biggar
    Lanarkshire
    Administrateur
    Midlock
    Crawford
    ML12 6UA Biggar
    Lanarkshire
    ScotlandScottish37316580001
    YOUNG, Charles Whiteford
    8 Succoth Place
    EH12 6BL Edinburgh
    Administrateur
    8 Succoth Place
    EH12 6BL Edinburgh
    British4667770001

    UA GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 13 mai 2005
    Livré le 25 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 9 may 2005
    Brèves mentions
    Subjects at polmaise, stirling.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 27 avr. 2005
    Livré le 11 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Kildean auction mart and adjacent premises, stirling.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mai 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 27 avr. 2005
    Livré le 11 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    9.374 hectares at slackbuie, inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mai 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 27 avr. 2005
    Livré le 11 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.761 hectares at slackbuie, inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mai 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 27 avr. 2005
    Livré le 11 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Perth agricultural centre, perth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mai 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 27 avr. 2005
    Livré le 11 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    West haugh, stirling.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mai 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 27 avr. 2005
    Livré le 11 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at woodmarket and abbey row, kelso.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mai 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of land at slackbuie, near inverness comprehending the farms of upper and lower slackbuie.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    7.975 acres at lairg on south east side of public road to from lairg to bonar bridge under exception.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Broxy kennels, redgorton, perth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Denmarkfield, redgorton, perth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    St. Magdalene's, perth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at rosebank, balmoral road, rattray.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at south road, cupar known as bells brae.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2.7 hectares at lairg.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 24 mars 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Auction mart premises at ormlie road, thurso.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 24 mars 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Auction mart premises at norland road, lybster, caithness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 18 mars 2005
    Livré le 01 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond
    Brèves mentions
    Mart field, dalmally (title number ARG1080) and dalmally auction mart, dalmally (title number ARG1081).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 18 mars 2005
    Livré le 01 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond
    Brèves mentions
    Huntly auction mart, huntly (title number ABN71710).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 18 mars 2005
    Livré le 01 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond
    Brèves mentions
    Ground at woodlands terrace/beachan wood, grantown on spey (title number MOR3360).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 18 mars 2005
    Livré le 01 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond
    Brèves mentions
    Farm and lands of milton of banniskirk, near thurso, caithness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 18 mars 2005
    Livré le 01 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond
    Brèves mentions
    Subjects at glenshellach, oban.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 18 mars 2005
    Livré le 01 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond
    Brèves mentions
    Lands of moleigh, oban.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 12 juil. 1994
    Livré le 29 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £150,000
    Brèves mentions
    7.88 acres at torbrex, st. Ninians, stirling lying to the south of torbrex road, stirling bounded to the south or southmost by the farm and lands of coxithill (otherwise coxet hill) owned by the firm of john oswald and son, which area of ground is shown delineated in red on the plan annexed and signed as relative to the standard security recorde 12TH july 1994.
    Personnes ayant droit
    • Wimpey Homes Holdings Limited
    Transactions
    • 29 juil. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 mai 1988
    Livré le 27 mai 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Cattlemarket at caledonia road and elibank street, perth (part of lands of greenyards) 296/302 high street, perth ground immediately to west of 296/302 high street, perth ground at high street, perth (formerly 316/320 high street, perth) "clayholes" at high street/elibank street, perth ground at high street/elibank street, perth.
    Personnes ayant droit
    • Ccl LTD
    Transactions
    • 27 mai 1988Enregistrement d'une charge

    UA GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 sept. 2010Administration started
    01 sept. 2011Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Blair Carnegie Nimmo
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    practitioner
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Gary Steven Fraser
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    practitioner
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    2
    DateType
    24 sept. 2010Administration started
    27 sept. 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gary Steven Fraser
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    practitioner
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Blair Carnegie Nimmo
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    practitioner
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0