COMPCO HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOMPCO HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC037323
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COMPCO HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe COMPCO HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Level 4 Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COMPCO HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COMPCO HOLDINGS PLC08 mars 196208 mars 1962

    Quels sont les derniers comptes de COMPCO HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour COMPCO HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Steven Ross Collins en tant que directeur le 18 sept. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Niki Maxine Cole en tant que directeur le 18 sept. 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Niki Cole en tant qu'administrateur le 30 juin 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Terence Shelby Cole en tant que directeur le 30 juin 2023

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2021

    7 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2018

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Richard Jeremy De Barr en tant que secrétaire le 23 juin 2017

    1 pagesTM02

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de COMPCO HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STEINBERG, Mark Neil
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    Administrateur
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    United KingdomBritishCompany Director59275730001
    DE BARR, Richard Jeremy
    38 Tring Avenue
    W5 3QB London
    Secrétaire
    38 Tring Avenue
    W5 3QB London
    British43885410001
    MCPAKE, Ian Alan Herbert
    66 Queen Street
    EH2 4NE Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    66 Queen Street
    EH2 4NE Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor1087400003
    RANKEN & REID SSC
    7 Albyn Place
    EH2 4NG Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    7 Albyn Place
    EH2 4NG Edinburgh
    Midlothian
    36900001
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Administrateur
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritishDirector73849040001
    BUTTON, John Martin
    Highclere
    Coin Colin, St. Martin
    GY4 6AQ Guernsey
    Channel Islands
    Administrateur
    Highclere
    Coin Colin, St. Martin
    GY4 6AQ Guernsey
    Channel Islands
    BritishBanker8959490001
    COLE, Niki Maxine
    Level 4 Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur
    Level 4 Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    EnglandBritishDirector303564480001
    COLE, Terence Shelby
    Upper Berkeley Street
    W1H 7PE London
    10
    England
    Administrateur
    Upper Berkeley Street
    W1H 7PE London
    10
    England
    United KingdomBritishCompany Director71810060003
    COLLINS, Steven Ross
    Bulstrode Street
    W1U 2JH London
    17
    England
    Administrateur
    Bulstrode Street
    W1U 2JH London
    17
    England
    EnglandBritishCompany Director7128850005
    HOWES, Christopher Kingston, Sir
    Westerly House
    IP15 5EL Aldeburgh
    Suffolk
    Administrateur
    Westerly House
    IP15 5EL Aldeburgh
    Suffolk
    EnglandBritishChartered Surveyor84824340001
    JAYE, Andrew Ian
    Weatheroak
    The Common
    HA7 3HP Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    Weatheroak
    The Common
    HA7 3HP Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritishEstate Agent10174290002
    LEAVER, Brian Ivan
    The Garden House
    72 Paines Lane
    HA5 3BL Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    The Garden House
    72 Paines Lane
    HA5 3BL Pinner
    Middlesex
    EnglandBritishDirector13082210001
    LEHMANN, Colin Ivor
    25 Totteridge Village
    N20 8PN London
    Administrateur
    25 Totteridge Village
    N20 8PN London
    EnglandBritishCompany Director43173670002
    LEWIS, Philip Geoffrey
    1 Parkside
    NW7 2LJ London
    Administrateur
    1 Parkside
    NW7 2LJ London
    EnglandBritishChartered Surveyor6639590001
    MYERS, Bernard Ian
    New Court
    St Swithins Lane
    EC4P 4DU London
    Administrateur
    New Court
    St Swithins Lane
    EC4P 4DU London
    United KingdomBritishConsultant47627350005
    NADLER, John Esmond
    Flat 4 Essex Court
    30 St James Place
    SW1 London
    Administrateur
    Flat 4 Essex Court
    30 St James Place
    SW1 London
    BritishChartered Surveyor1791570001
    NADLER, Robert Arthur
    123 Old Church Street
    SW3 6EA London
    Administrateur
    123 Old Church Street
    SW3 6EA London
    United KingdomBritishChartered Surveyor33752790002
    PICKFORD, David Michael
    Elm Tree Farm
    Mersham
    TN25 7HS Ashford
    Kent
    Administrateur
    Elm Tree Farm
    Mersham
    TN25 7HS Ashford
    Kent
    BritishChartered Surveyor64475900002
    ROSS, Nigel Keith
    60 Cumberland Terrace
    NW1 4HJ London
    Administrateur
    60 Cumberland Terrace
    NW1 4HJ London
    United KingdomBritishDirector47878830001
    RUBENS, Kenneth David
    61 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    Administrateur
    61 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    United KingdomBritishChartered Surveyor35531750001
    WOLFSON OF SUNNINGDALE, David, Lord
    1 Portobello Studios
    Haydens Place
    W11 1LY London
    Administrateur
    1 Portobello Studios
    Haydens Place
    W11 1LY London
    EnglandBritishDirector92063640001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COMPCO HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    City & General Securities Ltd
    Upper Berkeley Street
    W1H 7PE London
    10
    England
    06 avr. 2016
    Upper Berkeley Street
    W1H 7PE London
    10
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    COMPCO HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of amendment and confirmation
    Créé le 26 mars 2012
    Livré le 10 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 12 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of confirmation
    Créé le 26 mars 2012
    Livré le 10 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole property (including uncalled capital) which is or may be from time to time while the floating charge is in force comprised in the property and undertaking of the chargor.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 12 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 26 mars 2012
    Livré le 10 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 10 avr. 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 12 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Debenture
    Créé le 26 mars 2012
    Livré le 10 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 12 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 05 sept. 2003
    Livré le 23 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under the charge, each of the facility agreements and each of the other finance documents
    Brèves mentions
    First legal mortgage, first fixed charge and floating charge over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 sept. 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 sept. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    • 12 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 04 sept. 2003
    Livré le 23 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under each finance document
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 sept. 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 sept. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    • 10 avr. 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 12 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Legal charge
    Créé le 10 déc. 1999
    Livré le 16 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Property at madeira drive, brighton.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Third party deed of charge over shareholders' loans
    Créé le 19 oct. 1995
    Livré le 06 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All the company's present and future rights, title and interest in and to the sum of £350,000 together with any interest arising from a loan in connection with the purchase of property at 9 bridge street, newport.
    Personnes ayant droit
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transactions
    • 06 nov. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Guarantee & floating charge
    Créé le 19 sept. 1967
    Livré le 25 sept. 1967
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the said guarantee by the company to the chargee
    Brèves mentions
    The sum of £80,000 deposited by the company with the chargee & all moneys now or hereafter standing to the credit of the company's deposit accounts with the chargee up to the sum of £80,000.
    Personnes ayant droit
    • British and French Bank LTD
    Transactions
    • 25 sept. 1967Enregistrement d'une charge
    • 22 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0