COMPCO HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | COMPCO HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | SC037323 |
Juridiction | Écosse |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COMPCO HOLDINGS LIMITED ?
Adresse du siège social | Level 4 Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COMPCO HOLDINGS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour COMPCO HOLDINGS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Cessation de la nomination de Steven Ross Collins en tant que directeur le 18 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Niki Maxine Cole en tant que directeur le 18 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mrs Niki Cole en tant qu'administrateur le 30 juin 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Terence Shelby Cole en tant que directeur le 30 juin 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2021 | 7 pages | AA | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019 | 11 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2018 | 13 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017 | 14 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Richard Jeremy De Barr en tant que secrétaire le 23 juin 2017 | 1 pages | TM02 | ||
Satisfaction de la charge 7 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 10 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Qui sont les dirigeants de COMPCO HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEINBERG, Mark Neil | Administrateur | Wadham Gardens NW3 3DN London 11 | United Kingdom | British | Company Director | 59275730001 | ||||
DE BARR, Richard Jeremy | Secrétaire | 38 Tring Avenue W5 3QB London | British | 43885410001 | ||||||
MCPAKE, Ian Alan Herbert | Secrétaire | 66 Queen Street EH2 4NE Edinburgh Midlothian | British | Solicitor | 1087400003 | |||||
RANKEN & REID SSC | Secrétaire | 7 Albyn Place EH2 4NG Edinburgh Midlothian | 36900001 | |||||||
ANDERSON, Bruce Smith | Administrateur | 2 Bramdean View EH10 6JX Edinburgh | Scotland | British | Director | 73849040001 | ||||
BUTTON, John Martin | Administrateur | Highclere Coin Colin, St. Martin GY4 6AQ Guernsey Channel Islands | British | Banker | 8959490001 | |||||
COLE, Niki Maxine | Administrateur | Level 4 Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh | England | British | Director | 303564480001 | ||||
COLE, Terence Shelby | Administrateur | Upper Berkeley Street W1H 7PE London 10 England | United Kingdom | British | Company Director | 71810060003 | ||||
COLLINS, Steven Ross | Administrateur | Bulstrode Street W1U 2JH London 17 England | England | British | Company Director | 7128850005 | ||||
HOWES, Christopher Kingston, Sir | Administrateur | Westerly House IP15 5EL Aldeburgh Suffolk | England | British | Chartered Surveyor | 84824340001 | ||||
JAYE, Andrew Ian | Administrateur | Weatheroak The Common HA7 3HP Stanmore Middlesex | England | British | Estate Agent | 10174290002 | ||||
LEAVER, Brian Ivan | Administrateur | The Garden House 72 Paines Lane HA5 3BL Pinner Middlesex | England | British | Director | 13082210001 | ||||
LEHMANN, Colin Ivor | Administrateur | 25 Totteridge Village N20 8PN London | England | British | Company Director | 43173670002 | ||||
LEWIS, Philip Geoffrey | Administrateur | 1 Parkside NW7 2LJ London | England | British | Chartered Surveyor | 6639590001 | ||||
MYERS, Bernard Ian | Administrateur | New Court St Swithins Lane EC4P 4DU London | United Kingdom | British | Consultant | 47627350005 | ||||
NADLER, John Esmond | Administrateur | Flat 4 Essex Court 30 St James Place SW1 London | British | Chartered Surveyor | 1791570001 | |||||
NADLER, Robert Arthur | Administrateur | 123 Old Church Street SW3 6EA London | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 33752790002 | ||||
PICKFORD, David Michael | Administrateur | Elm Tree Farm Mersham TN25 7HS Ashford Kent | British | Chartered Surveyor | 64475900002 | |||||
ROSS, Nigel Keith | Administrateur | 60 Cumberland Terrace NW1 4HJ London | United Kingdom | British | Director | 47878830001 | ||||
RUBENS, Kenneth David | Administrateur | 61 Springfield Road St Johns Wood NW8 0QJ London | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 35531750001 | ||||
WOLFSON OF SUNNINGDALE, David, Lord | Administrateur | 1 Portobello Studios Haydens Place W11 1LY London | England | British | Director | 92063640001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COMPCO HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
City & General Securities Ltd | 06 avr. 2016 | Upper Berkeley Street W1H 7PE London 10 England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
|
COMPCO HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Deed of amendment and confirmation | Créé le 26 mars 2012 Livré le 10 avr. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of confirmation | Créé le 26 mars 2012 Livré le 10 avr. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole property (including uncalled capital) which is or may be from time to time while the floating charge is in force comprised in the property and undertaking of the chargor. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Bond & floating charge | Créé le 26 mars 2012 Livré le 10 avr. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Debenture | Créé le 26 mars 2012 Livré le 10 avr. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 05 sept. 2003 Livré le 23 sept. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under the charge, each of the facility agreements and each of the other finance documents | |
Brèves mentions First legal mortgage, first fixed charge and floating charge over assets. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Créé le 04 sept. 2003 Livré le 23 sept. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under each finance document | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Legal charge | Créé le 10 déc. 1999 Livré le 16 déc. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Property at madeira drive, brighton. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Third party deed of charge over shareholders' loans | Créé le 19 oct. 1995 Livré le 06 nov. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All the company's present and future rights, title and interest in and to the sum of £350,000 together with any interest arising from a loan in connection with the purchase of property at 9 bridge street, newport. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & floating charge | Créé le 19 sept. 1967 Livré le 25 sept. 1967 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due under the said guarantee by the company to the chargee | |
Brèves mentions The sum of £80,000 deposited by the company with the chargee & all moneys now or hereafter standing to the credit of the company's deposit accounts with the chargee up to the sum of £80,000. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0