GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED

GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC039207
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Argyll Court
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Scotland
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BETT HOMES (NORTH WEST) LIMITED 05 mars 200305 mars 2003
    BETT HOMES (NORTHERN) LIMITED06 oct. 199506 oct. 1995
    BETT DEVELOPMENTS LIMITED16 mai 198616 mai 1986
    CHARLES E. SPALDING (PROPERTIES) LIMITED03 sept. 196303 sept. 1963

    Quels sont les derniers comptes de GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 11 déc. 2015

    • Capital: GBP 2.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2015 au 30 avr. 2016

    1 pagesAA01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Giles Henry Sharp le 22 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Glyn David Mabey le 22 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Colin Edward Lewis le 22 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Joanne Elizabeth Massey le 22 oct. 2015

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de Regency House Crossgates Road, Halbeath Dunfermline, Fife KY11 7EG à Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT le 23 oct. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jon William Mortimore en tant que directeur le 31 mars 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 mars 2015

    État du capital au 12 mars 2015

    • Capital: GBP 12,016,000
    SH01

    Nomination de Mr Giles Sharp en tant qu'administrateur le 23 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Neil Fitzsimmons en tant que directeur le 12 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 20 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 18 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 17 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Secrétaire
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    147809270001
    LEWIS, Colin Edward
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    WalesWelsh59395180001
    MABEY, Glyn David
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    WalesBritish100945610001
    SHARP, Giles Henry
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secrétaire
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Secrétaire
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    ANDERSON, Alexander
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish114144470001
    ASKER, Giles Allen Trevor
    Nicholas Way
    Corringham
    DN21 5QE Gainsborough
    9
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Nicholas Way
    Corringham
    DN21 5QE Gainsborough
    9
    Lincolnshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish75879360004
    BALL, Malcolm
    6 Bowline Close
    CW11 4AQ Sandbach
    Cheshire
    Administrateur
    6 Bowline Close
    CW11 4AQ Sandbach
    Cheshire
    Great BritainBritish107732120001
    BETT, Iain Charles Rattray
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    Administrateur
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    ScotlandBritish95179330001
    BURTON, Christopher Julian
    5 The Heatherways
    CW6 0HP Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    5 The Heatherways
    CW6 0HP Tarporley
    Cheshire
    British71961290002
    CALDER, John Murray
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    Administrateur
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    British318650001
    CALDWELL, Denise Elsie
    14 The Hillock
    Astley
    M29 7GW Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    14 The Hillock
    Astley
    M29 7GW Manchester
    Lancashire
    British122926060001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    COLLS, Andrew John
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish61370150001
    CORRIN, Brian Stanley
    14 Ward Close
    Great Sankey
    WA5 8XY Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    14 Ward Close
    Great Sankey
    WA5 8XY Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish110416140001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Administrateur
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Administrateur
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    GIBSON, Alexander
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    Administrateur
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    British318180001
    GORE, Derek Cyril
    15 Rockfield Crescent
    DD2 1JF Dundee
    Tayside
    Administrateur
    15 Rockfield Crescent
    DD2 1JF Dundee
    Tayside
    British92043160001
    GRANT, Alexander James
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    British107801990001
    GRIFFIN, Stephen Barry
    29 Little Acton Drive
    Garden Village
    LL12 8DH Wrexham
    N Wales
    Administrateur
    29 Little Acton Drive
    Garden Village
    LL12 8DH Wrexham
    N Wales
    British66519990002
    HANDYSIDE, Mark
    11 Lawn Park
    Milngavie
    G62 6HG Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    11 Lawn Park
    Milngavie
    G62 6HG Glasgow
    Lanarkshire
    British56712320001
    HANNA, Ronald George
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish8506940001
    HIRST, Stephen Jeremy
    Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    157
    United Kingdom
    Administrateur
    Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    157
    United Kingdom
    United KingdomBritish95787000001
    KELLY, Richard Ian
    30 Wood Lane
    WA15 7PS Timperley
    Cheshire
    Administrateur
    30 Wood Lane
    WA15 7PS Timperley
    Cheshire
    United KingdomBritish157317280001
    LANCASTER, Michaela Dawn
    2 Highmoor Park
    BB7 1JB Clitheroe
    Lancashire
    Administrateur
    2 Highmoor Park
    BB7 1JB Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritish79770560001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    LAW, Ronald Douglas
    7 Burns Avenue
    FK5 4FB Larbert
    Administrateur
    7 Burns Avenue
    FK5 4FB Larbert
    British67443350001
    MITCHELL, Ronald
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    Administrateur
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    British318190001
    MORTIMORE, Jon William
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002

    GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 01 sept. 2009
    Livré le 16 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 sept. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 févr. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    • 24 févr. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    • 16 juil. 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Shares pledge
    Créé le 01 sept. 2009
    Livré le 15 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2 ordinary shares in gladedale (dundee) limited.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Shares pledge
    Créé le 01 sept. 2009
    Livré le 15 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1,000 ordinary shares in gladedale (central scotland) limited.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 01 sept. 2009
    Livré le 15 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 sept. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 juil. 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Share pledge
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 14 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Entire right, title and interest (present and future) to the shares.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 14 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 sept. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 juil. 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 08 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 sept. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 juil. 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 21 mai 2003
    Livré le 03 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 juin 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 sept. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 juil. 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Legal charge
    Créé le 18 juin 1990
    Livré le 25 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ironbank car park site, east side thorpe road staines sy 566260.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 16 janv. 1990
    Livré le 29 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold property known as tudor lodge, king harry st, hemal hempstead, hertfordshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 16 mai 1989
    Livré le 18 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot 8, south partway business park, old sarom, laverstock, wiltshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 23 mars 1989
    Livré le 10 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000
    Brèves mentions
    120 west campbell street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Birnam Securities (Glasgow) Limited
    Transactions
    • 10 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 30 nov. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 30 déc. 1988
    Livré le 10 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land north west side crabtree road thorpe part sy 535529 sy 485155 sy 489268.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 08 déc. 1988
    Livré le 22 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land at crabtree road, thorpe nr. Staines, middlesex.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 22 juil. 1987
    Livré le 04 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground in the city of glasgow and county of the barony and regality of glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 02 févr. 1987
    Livré le 06 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1,029.59 square metres in kilmarnock ayrshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    Letter of offset
    Créé le 10 avr. 1984
    Livré le 24 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by bett brothers PLC and or others
    Brèves mentions
    Balances at credit of any account held by the bank of scotland.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0