PEARL ALAS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPEARL ALAS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC039458
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PEARL ALAS LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe PEARL ALAS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PEARL ALAS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RESOLUTION ALAS LIMITED18 avr. 200718 avr. 2007
    ALBA LIFE ASSOCIATION OF SCOTLAND LIMITED07 déc. 199907 déc. 1999
    BRITANNIA LIFE ASSOCIATION OF SCOTLAND LIMITED01 janv. 199401 janv. 1994
    LIFE ASSOCIATION OF SCOTLAND LIMITED (THE)31 oct. 196331 oct. 1963

    Quels sont les derniers comptes de PEARL ALAS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour PEARL ALAS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael John Merrick le 05 mars 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Kerr Luscombe en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 301 st Vincent Street Glasgow G2 5HN le 10 janv. 2010

    1 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 21 oct. 2009

    LRESSP

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    Statuts

    14 pagesMA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed resolution alas LIMITED\certificate issued on 22/05/08
    2 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Certificat de changement de nom

    Company name changed alba life association of scotlan d LIMITED\certificate issued on 18/04/07
    2 pagesCERTNM

    Résolutions

    Resolutions
    16 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de PEARL ALAS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PEARL GROUP SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    Secrétaire
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    115204320002
    MERRICK, Michael John
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    EnglandBritishActuary74114060001
    GRIFFIN-SMITH, Philip Bernard
    The Rickyard
    CV23 0JN Easenhall
    7
    Warwickshire
    Secrétaire
    The Rickyard
    CV23 0JN Easenhall
    7
    Warwickshire
    British130189950001
    JORDAN, Barbara Craig
    8 Rosemount Meadows
    Bothwell
    G71 8EL Glasgow
    Secrétaire
    8 Rosemount Meadows
    Bothwell
    G71 8EL Glasgow
    British80291020001
    KELLY, Malcolm James, Mr.
    Balade, 9 Hazel Avenue
    Lenzie
    G66 4RR Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    Balade, 9 Hazel Avenue
    Lenzie
    G66 4RR Glasgow
    Lanarkshire
    British103788380001
    PATERSON, James
    6 Horsburgh Grove
    EH14 7BU Balerno
    Midlothian
    Secrétaire
    6 Horsburgh Grove
    EH14 7BU Balerno
    Midlothian
    British556210001
    RANKIN, Colin Graham
    Spottiswoode
    Sandy Road
    KA23 9NN Seamill
    Ayrshire
    Secrétaire
    Spottiswoode
    Sandy Road
    KA23 9NN Seamill
    Ayrshire
    British120453410001
    ROSS, Marie Isobel
    51 Killermont Road
    Bearsden
    G61 2JF Glasgow
    Secrétaire
    51 Killermont Road
    Bearsden
    G61 2JF Glasgow
    British42057170004
    SHEPHERD, Neil Morton
    35 Kaimes Road
    EH12 6JT Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    35 Kaimes Road
    EH12 6JT Edinburgh
    Midlothian
    British1063630001
    WAGNER, Deborah Anne
    1 Hillend Road
    Burnside
    G73 4JU Glasgow
    Secrétaire
    1 Hillend Road
    Burnside
    G73 4JU Glasgow
    British6059110004
    ANDRINGA, Syste Adriaan
    B Peereboomvollerlaan 13
    2111 Ta Aerdenhout
    Holland
    Administrateur
    B Peereboomvollerlaan 13
    2111 Ta Aerdenhout
    Holland
    DutchInsurance Manager34450990001
    BAYLEY, Trevor John
    Woodside Clay Lake
    Endon
    ST9 9DD Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Woodside Clay Lake
    Endon
    ST9 9DD Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishFinance Director804490002
    BUCHANAN, Richard Robertson Trail
    Lynwood
    6 Essex Road
    EH4 6LG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Lynwood
    6 Essex Road
    EH4 6LG Edinburgh
    Midlothian
    BritishInsurance Company Manager32224420001
    BURDON, Peter Vincent
    6 Belhaven Place
    G77 5FJ Glasgow
    Administrateur
    6 Belhaven Place
    G77 5FJ Glasgow
    BritishActuary65710740001
    BURNET, George Wardlaw
    Rose Court Inveresk Village
    EH21 7TD Musselburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Rose Court Inveresk Village
    EH21 7TD Musselburgh
    Midlothian
    BritishWriter To The Signet46268800001
    CRAINE, Roger
    2 Pheasant Field
    Hale Village
    L24 5SD Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    2 Pheasant Field
    Hale Village
    L24 5SD Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritishAccountant89585440001
    ERNSTE, Derk
    Italuulenkuja 11
    02100 Espoo
    Finland
    Administrateur
    Italuulenkuja 11
    02100 Espoo
    Finland
    DutchInsurance Company Manager27566690001
    FALCONER, James Alexander Reid
    Caol Ila
    Kinnesswood
    KY13 7HL Kinross
    Administrateur
    Caol Ila
    Kinnesswood
    KY13 7HL Kinross
    BritishCompany Director556240001
    FLETCHER, Alexander Macpherson, Sir
    5-9 Abercromby Place
    EH3 6LA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5-9 Abercromby Place
    EH3 6LA Edinburgh
    Midlothian
    BritishManaging Director43790001
    GREENFIELD, Richard Edward Keith
    Byeways
    Neston
    CH64 7TA South Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    Byeways
    Neston
    CH64 7TA South Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritishChartered Accountant100783270001
    HEAPS, John Edward
    Top House Farm Dodsleigh
    ST10 4QA Leigh
    Staffs
    Administrateur
    Top House Farm Dodsleigh
    ST10 4QA Leigh
    Staffs
    BritishManaging Director36563030002
    HENDERSON, William Grahamslaw
    6 West Munro Drive
    G84 9AA Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    6 West Munro Drive
    G84 9AA Helensburgh
    Dunbartonshire
    United KingdomBritishFinance Director86647560001
    HILL, John Lawrence
    Warwick Lodge
    10 Warwicks Bench
    GU1 3TG Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Warwick Lodge
    10 Warwicks Bench
    GU1 3TG Guildford
    Surrey
    BritishChartered Engineer1226130001
    HOLSBOER, Jan Hendrik
    Noord Crailoseweg
    FOREIGN 1272 Rd Huizen
    Netherlands
    Administrateur
    Noord Crailoseweg
    FOREIGN 1272 Rd Huizen
    Netherlands
    DutchExecutive Board Member6029330001
    HUIZINGA, Herman
    Rozenburglaan 44
    FOREIGN 3062 Ed Rotterdam
    Holland
    Administrateur
    Rozenburglaan 44
    FOREIGN 3062 Ed Rotterdam
    Holland
    DutchInsurance Official27566680001
    JONCKHEER, Guillaume Francois
    Guilianaweg 2 2243 Wassenaar
    FOREIGN The Hague
    Holland
    Administrateur
    Guilianaweg 2 2243 Wassenaar
    FOREIGN The Hague
    Holland
    BritishInsurance Company Mamger1105980001
    JONKER, Samuel Jacob
    50 Van Lennepweg
    2597 Lk
    FOREIGN The Hague
    The Netherlands
    Administrateur
    50 Van Lennepweg
    2597 Lk
    FOREIGN The Hague
    The Netherlands
    DutchInsurance Company Manager556230001
    LAIRD, Gavin Harry, Sir
    9 Cleveden House
    Holmbury Park
    BR1 2WG Bromley
    Kent
    Administrateur
    9 Cleveden House
    Holmbury Park
    BR1 2WG Bromley
    Kent
    BritishGeneral Secretary127153740001
    LAURENSON, James Tait
    Hillhouse
    EH27 8DR Kirknewton
    Midlothian
    Administrateur
    Hillhouse
    EH27 8DR Kirknewton
    Midlothian
    BritishCa338250001
    LUSCOMBE, Kerr
    3e Melbourne Court
    Braidpark Drive, Giffnock
    G46 6LA Glasgow
    Administrateur
    3e Melbourne Court
    Braidpark Drive, Giffnock
    G46 6LA Glasgow
    ScotlandBritishDirector83541890001
    MACLEOD, Calum Alexander, Dr
    6 Westfield Terrace
    AB25 2RU Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    6 Westfield Terrace
    AB25 2RU Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishSolicitor1085020001
    MILLER, James
    Belmont
    Ellersly Road
    EH12 6JA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    Belmont
    Ellersly Road
    EH12 6JA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    BritishBuilding And Civil Engineering Contractor10931510001
    MUNRO, David Michael
    Cockairnie House
    KY3 0RZ Aberdour
    Burntisland
    Fife
    Administrateur
    Cockairnie House
    KY3 0RZ Aberdour
    Burntisland
    Fife
    BritishChartered Accountant84930001
    NICKSON, John William
    65 Redgrove Park
    GL51 6QY Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    65 Redgrove Park
    GL51 6QY Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant67485130001
    O'NEIL, Daniel
    25 Newlands Road
    Newlands
    G43 2JD Glasgow
    Administrateur
    25 Newlands Road
    Newlands
    G43 2JD Glasgow
    ScotlandBritishActuary35459350002

    PEARL ALAS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 19 août 1994
    Livré le 22 août 1994
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    (1) legal mortgage- 59 market street, colne, lancashire registered at hm land registry under title number LA524144. (2) fixed charge over the benefit of all covenants and rights affecting or concerning the property described in (1) and the plant, machinery and fixtures and fittings, furniture, equipment, implements and utensils now and in the future at the property. Note: the legal charge contains covenants by the company with the bank not without the bank's prior consent to create or permit to arise any mortgage charge or lien on the charged property nor to dispose of any of same.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 août 1994Enregistrement d'une charge (410)
    Legal charge
    Créé le 18 avr. 1994
    Livré le 21 avr. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1. legal mortgage over 55 london road, stockton heath, warrington, cheshire. 2. fixed charge over rights etce in connection with said property see ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    Legal charge
    Créé le 28 sept. 1984
    Livré le 10 oct. 1984
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    44 & 45 1/2 & 46 eagle street holborn london.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 21 nov. 1983
    Livré le 05 déc. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £40,000 due by the company and another
    Brèves mentions
    18 new church rd hove east sussex.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • South West Trustee Savings Bank
    Transactions
    • 05 déc. 1983Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 05 févr. 1982
    Livré le 15 févr. 1982
    En cours
    Montant garanti
    £51,000 due by the company and another
    Brèves mentions
    The jason works, clarence street, loughborough, leicestershire.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 07 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 10 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    PEARL ALAS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 avr. 2011Dissolved on
    21 oct. 2009Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0