ARGENT OILS (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéARGENT OILS (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC039715
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ARGENT OILS (UK) LIMITED ?

    • Collecte de déchets non dangereux (38110) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution

    Où se situe ARGENT OILS (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    236-240 Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ARGENT OILS (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ARGENT ENERGY COLLECTIONS LIMITED30 janv. 200730 janv. 2007
    W.C. HODGKINSON (CLELAND) LIMITED31 déc. 196331 déc. 1963

    Quels sont les derniers comptes de ARGENT OILS (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour ARGENT OILS (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Nomination de Dr Louise Jacqueline Calviou en tant qu'administrateur le 31 déc. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Erik Peter Rietkerk en tant que directeur le 31 déc. 2023

    1 pagesTM01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital au 03 août 2023

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    7 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 17 mai 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 mai 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 mai 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    22 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew William Dane en tant que directeur le 09 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Nicola Dean en tant qu'administrateur le 09 juil. 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 17 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 mai 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mr Andrew William Dane en tant qu'administrateur le 12 mars 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Bruce Rae-Smith en tant que directeur le 12 mars 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Arthur Richard Boyd en tant que directeur le 12 mars 2019

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de ARGENT OILS (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MORRIS, David Charles
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    Secrétaire
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    251441300001
    CALVIOU, Louise Jacqueline, Dr
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    Administrateur
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    United KingdomBritish215932720001
    DEAN, Nicola
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    Administrateur
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    United KingdomBritish219781490001
    BARNES, Andrew John
    19 Queens Avenue
    IG8 0JE Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    19 Queens Avenue
    IG8 0JE Woodford Green
    Essex
    British79031400002
    BOND, Christopher David
    Ashgrove
    4/5 Wester Coates Road
    EH12 5LU Edinburgh
    Secrétaire
    Ashgrove
    4/5 Wester Coates Road
    EH12 5LU Edinburgh
    Other95433830001
    BOYD, James Arthur Richard
    Renwick Lane
    Cardrona
    EH45 9LU Peebles
    14
    Borders
    Scotland
    Secrétaire
    Renwick Lane
    Cardrona
    EH45 9LU Peebles
    14
    Borders
    Scotland
    British130003610001
    CARTWRIGHT, David Frederick
    38 Argyle Way
    FK15 9DY Dunblane
    Perthshire
    Secrétaire
    38 Argyle Way
    FK15 9DY Dunblane
    Perthshire
    British1161680001
    DIBBEN, Ann Marie
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    England
    Secrétaire
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    England
    213029000001
    HYND, Russell John
    22/4 East Suffolk Park
    Newington
    EH16 5PN Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    22/4 East Suffolk Park
    Newington
    EH16 5PN Edinburgh
    Midlothian
    British84638940002
    JANNETTA, Lucio Enrico Peter
    18 Beauly Crescent
    G77 5UQ Newwton Mearns
    Renfrewshire
    Secrétaire
    18 Beauly Crescent
    G77 5UQ Newwton Mearns
    Renfrewshire
    British115543480001
    MACEACHRAN, Ronald Bannatyne
    59 Finnart Street
    Greenock
    PA16 8HH Renfrewshire
    Secrétaire
    59 Finnart Street
    Greenock
    PA16 8HH Renfrewshire
    British108202220001
    MCLINDEN, John Farrell
    21 Castleton Avenue
    Newton Mearns
    G77 5NF Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    21 Castleton Avenue
    Newton Mearns
    G77 5NF Glasgow
    Lanarkshire
    British183160001
    MORRIS, David Charles
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    England
    Secrétaire
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    England
    203885110001
    BARNES, Andrew John
    19 Queens Avenue
    IG8 0JE Woodford Green
    Essex
    Administrateur
    19 Queens Avenue
    IG8 0JE Woodford Green
    Essex
    EnglandBritish79031400002
    BOYD, James Arthur Richard
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    United Kingdom
    Administrateur
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    United Kingdom
    United KingdomBritish130003610003
    BUSWELL, Michel Norman
    The Dower House
    1 The Green
    NN12 8PD Blakesley
    Northants
    Administrateur
    The Dower House
    1 The Green
    NN12 8PD Blakesley
    Northants
    British15685720001
    CARTWRIGHT, David Frederick
    38 Argyle Way
    FK15 9DY Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    38 Argyle Way
    FK15 9DY Dunblane
    Perthshire
    British1161680001
    DANE, Andrew William
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    Administrateur
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    ScotlandBritish184371050002
    DELL, Julian David
    37 The Moor
    Melbourn
    SG8 6ED Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    37 The Moor
    Melbourn
    SG8 6ED Royston
    Hertfordshire
    British37454890002
    GORDON, George Hay Robertson
    18 Lynecroft
    Bishopbriggs
    G64 3LN Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    18 Lynecroft
    Bishopbriggs
    G64 3LN Glasgow
    Lanarkshire
    British183180001
    GRAY, David John
    20 Warwick Avenue
    W9 2PT London
    Administrateur
    20 Warwick Avenue
    W9 2PT London
    EnglandBritish105745700001
    HUNTER, Andrew Pennington Havard
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    Administrateur
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    EnglandBritish54239750005
    MACEACHRAN, Ronald Bannatyne
    59 Finnart Street
    Greenock
    PA16 8HH Renfrewshire
    Administrateur
    59 Finnart Street
    Greenock
    PA16 8HH Renfrewshire
    British108202220001
    MCLINDEN, John Farrell
    21 Castleton Avenue
    Newton Mearns
    G77 5NF Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    21 Castleton Avenue
    Newton Mearns
    G77 5NF Glasgow
    Lanarkshire
    British183160001
    MENZIES, John
    35 Dundonald Road
    KA1 1RY Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    35 Dundonald Road
    KA1 1RY Kilmarnock
    Ayrshire
    British183170002
    RAE-SMITH, John Bruce
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    Administrateur
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    United KingdomBritish135359240003
    RIETKERK, Erik Peter
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    United Kingdom
    Administrateur
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    United Kingdom
    United KingdomDutch249633820001
    WALKER, James Lamont
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    United Kingdom
    Administrateur
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    United Kingdom
    ScotlandBritish127869700010
    WARD, Douglas John
    6 Halmyre Loan
    Romanno Bridge
    EH46 7DN West Linton
    Valhalla
    Administrateur
    6 Halmyre Loan
    Romanno Bridge
    EH46 7DN West Linton
    Valhalla
    United KingdomBritish35803420005

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ARGENT OILS (UK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    North Lanarkshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    North Lanarkshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc359384
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    ARGENT OILS (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 09 sept. 2011
    Livré le 17 sept. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 17 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 21 sept. 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 29 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 09 sept. 2011
    Livré le 17 sept. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 21 sept. 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 27 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 02 sept. 2009
    Livré le 09 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Auchterderran road lochgelly FFE47732.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 18 août 2009
    Livré le 26 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 26 août 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 25 juil. 2007
    Livré le 06 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under the finance documents
    Brèves mentions
    Subjects at auchterderran road, lochgelly FFE47732.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 06 août 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 17 juil. 2007
    Livré le 31 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under the finance documents
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 31 juil. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 16 juil. 2007
    Livré le 31 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under the finance documents
    Brèves mentions
    Legal mortgage over any property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 31 juil. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 12 mars 2003
    Livré le 20 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects on the east side of biggarford road, cleland--title number LAN23031.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 mars 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 30 oct. 2002
    Livré le 12 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under the bos documents
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 nov. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 oct. 1997
    Livré le 10 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at east side of biggarford road, cleland.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee
    Transactions
    • 10 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 oct. 1997
    Livré le 16 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    East side of biggarford road, cleland : ground at parish of bothwell.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee
    Transactions
    • 16 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 30 sept. 1997
    Livré le 06 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 06 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0