BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED

BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC041450
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    216 East Main Street
    Broxburn
    EH52 5AS West Lothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BUDGET EXHAUSTS & TYRES LIMITED 17 juin 199117 juin 1991
    BUDGET TYRES & EXHAUSTS LIMITED 05 avr. 198405 avr. 1984
    THISTLE METALLICS LIMITED10 déc. 196410 déc. 1964

    Quels sont les derniers comptes de BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 juin 2012

    État du capital au 25 juin 2012

    • Capital: GBP 100,020
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2011 au 31 mars 2012

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Kazushi Ogura en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Kenji Murai en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Healy en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Fraser en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Healy en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Nomination de Ian Vincent Ellis en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Michael Joseph Anthony Healy le 20 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Joseph Anthony Healy le 20 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Ellis Fraser le 20 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ELLIS, Ian Vincent
    216 East Main Street
    Broxburn
    EH52 5AS West Lothian
    Secrétaire
    216 East Main Street
    Broxburn
    EH52 5AS West Lothian
    British162126270001
    MURAI, Kenji
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapanese95702340002
    OGURA, Kazushi
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapanese150485750001
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Secrétaire
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    British99111340001
    HUTHERSALL, Robert
    17 Corstorphine Road
    EH12 6DD Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Secrétaire
    17 Corstorphine Road
    EH12 6DD Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British3204110001
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Secrétaire
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    MORRISON, Scott
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    British99297890001
    BISSETT, Graeme
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    Administrateur
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    British79800380001
    FARMER, Thomas, Sir
    192 Queensferry Road
    EH4 6JL Edinburgh
    Maidencraig House
    Midlothian
    Administrateur
    192 Queensferry Road
    EH4 6JL Edinburgh
    Maidencraig House
    Midlothian
    ScotlandBritish94804240004
    FRASER, Ian Ellis
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Administrateur
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    ScotlandUk28393850006
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Administrateur
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritish99111340001
    HOUSTON, John Mclellan
    The Rock
    3 Douglas Avenue
    PA14 6PE Langbank
    Administrateur
    The Rock
    3 Douglas Avenue
    PA14 6PE Langbank
    British712840002
    HUTHERSALL, Robert
    56 Pentland Drive
    EH10 6PX Edinburgh
    Administrateur
    56 Pentland Drive
    EH10 6PX Edinburgh
    British3204110005
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Administrateur
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Administrateur
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    OWENS, Stanley Hart
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    Administrateur
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    American75755850002
    PARKER, Timothy Charles
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Administrateur
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritish126476060001

    BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of agreement
    Créé le 10 janv. 1983
    Livré le 14 janv. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All sums standing at the credit of the company with the bank on current account or otherwise.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 janv. 1983Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 déc. 1982
    Livré le 06 janv. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    14/20 brown street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 janv. 1983Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 03 sept. 1982
    Livré le 10 sept. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    123/125 causeway end, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 sept. 1982Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 03 juin 1982
    Livré le 15 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 juin 1982Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0