SUKL REALISATIONS 2020 LIMITED

SUKL REALISATIONS 2020 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSUKL REALISATIONS 2020 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC041753
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SUKL REALISATIONS 2020 LIMITED ?

    • fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base (20130) / Industries manufacturières

    Où se situe SUKL REALISATIONS 2020 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Craigshaw Road
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3AS Aberdeen
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SUKL REALISATIONS 2020 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STYROPACK (UK) LIMITED30 juil. 200830 juil. 2008
    STYROPACK (UK) LIMITED 19 févr. 196519 févr. 1965

    Quels sont les derniers comptes de SUKL REALISATIONS 2020 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SUKL REALISATIONS 2020 LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au07 nov. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour SUKL REALISATIONS 2020 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans CVL

    20 pagesLIQ14(Scot)

    Passage de la procédure d'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    17 pagesAM22(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    25 pagesAM10(Scot)

    Décision des créanciers sur les propositions de l'administrateur

    6 pagesAM07(Scot)

    Déclaration des affaires AM02SOASCOT

    17 pagesAM02(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Avis de proposition de l'administrateur

    85 pagesAM03(Scot)

    Avis de proposition de l'administrateur

    85 pagesAM03(Scot)

    Avis de proposition de l'administrateur

    85 pagesAM03(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01(Scot)

    Nomination de Mr Richard Peter Simon Lee en tant que secrétaire le 28 févr. 2020

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Matthew David Groom en tant que directeur le 28 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Matthew David Groom en tant que secrétaire le 28 févr. 2020

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    27 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Modifications à la charge flottante SC0417530027

    28 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC0417530026

    29 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC0417530023

    28 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC0417530021

    28 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC0417530019

    28 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC0417530020

    28 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC0417530022

    28 pages466(Scot)

    Qui sont les dirigeants de SUKL REALISATIONS 2020 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEE, Richard Peter Simon
    Silver Birch Drive
    PO22 6SJ Bognor Regis
    18
    England
    Secrétaire
    Silver Birch Drive
    PO22 6SJ Bognor Regis
    18
    England
    267782240001
    BROWN, Wayne Robert
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3AS Aberdeen
    Craigshaw Road
    Scotland
    Administrateur
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3AS Aberdeen
    Craigshaw Road
    Scotland
    United KingdomBritish174760640001
    LEE, Richard Peter Simon
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3AS Aberdeen
    Craigshaw Road
    Scotland
    Administrateur
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3AS Aberdeen
    Craigshaw Road
    Scotland
    EnglandBritish159751960001
    GROOM, Matthew David
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3AS Aberdeen
    Craigshaw Road
    Scotland
    Secrétaire
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3AS Aberdeen
    Craigshaw Road
    Scotland
    250819880001
    HUTCHINS, Kenneth, Mr.
    Beechenlea Lane
    BR8 8DP Swanley
    Rosedale
    Kent
    England
    Secrétaire
    Beechenlea Lane
    BR8 8DP Swanley
    Rosedale
    Kent
    England
    British123646570001
    WARING, Robert
    81 Edge End Lane
    Great Harwood
    BB6 7QD Blackburn
    Lancashire
    Secrétaire
    81 Edge End Lane
    Great Harwood
    BB6 7QD Blackburn
    Lancashire
    British16012650001
    YEOMAN, John
    1 Hillside Gardens
    Westhill Skene
    AB32 6PB Aberdeen
    Scotland
    Secrétaire
    1 Hillside Gardens
    Westhill Skene
    AB32 6PB Aberdeen
    Scotland
    Scottish34952400001
    ABBENHUIS, Wouter Jozeph Christiaan Michael
    Mr Gerritspark 5
    FOREIGN 5361 Js Grave
    The Netherlands
    Administrateur
    Mr Gerritspark 5
    FOREIGN 5361 Js Grave
    The Netherlands
    Dutch91949570001
    BIRNIE, Gavin James
    3 Oak Close, Calderstones Park
    Whalley
    BB7 9XF Clitheroe
    Lancashire
    Administrateur
    3 Oak Close, Calderstones Park
    Whalley
    BB7 9XF Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritish95103810003
    CRAIG, Robert
    2 Partan Skelly Way
    Cove Bay
    AB1 4PH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    2 Partan Skelly Way
    Cove Bay
    AB1 4PH Aberdeen
    Aberdeenshire
    British36748780001
    ELVERS, Jurgen
    Edsviken
    FOREIGN Sollentuna
    Sweden
    Administrateur
    Edsviken
    FOREIGN Sollentuna
    Sweden
    British27206780001
    GOEMANS, Ton
    Sueavagen 34
    FOREIGN Djursholm
    Sweden
    Administrateur
    Sueavagen 34
    FOREIGN Djursholm
    Sweden
    Dutch4953520001
    GRIFFITHS, Jason Ian
    West Tullos Industrial Estate
    Aberdeen
    Administrateur
    West Tullos Industrial Estate
    Aberdeen
    EnglandBritish102528040001
    GROOM, Matthew David
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3AS Aberdeen
    Craigshaw Road
    Scotland
    Administrateur
    West Tullos Industrial Estate
    AB12 3AS Aberdeen
    Craigshaw Road
    Scotland
    United KingdomBritish239264660001
    HANSEN, Johannes
    79 Gabelsparken
    FOREIGN Bramming
    Denmark
    Administrateur
    79 Gabelsparken
    FOREIGN Bramming
    Denmark
    Danish540220001
    HASTINGS, Peter
    Heul 75 4741 Rb
    Hoeven
    The Netherlands
    Administrateur
    Heul 75 4741 Rb
    Hoeven
    The Netherlands
    British51095700004
    HONORE, Michael
    Rosenbakken 89
    6100 Haderslev
    Denmark
    Administrateur
    Rosenbakken 89
    6100 Haderslev
    Denmark
    Danish37696760001
    HUTCHINS, Kenneth
    Beechenlea Lane
    BR8 8DP Swanley
    Rosedale
    Kent
    England
    Administrateur
    Beechenlea Lane
    BR8 8DP Swanley
    Rosedale
    Kent
    England
    EnglandBritish123646570002
    KEY, Gijsbrecht
    Mereldreef 14
    2980 Halle-Zoersel
    Belgium
    Administrateur
    Mereldreef 14
    2980 Halle-Zoersel
    Belgium
    Dutch56432620001
    LILLEY, John Howard
    Johan Baners Vag 49
    18275 Stocksund
    Sweden
    Administrateur
    Johan Baners Vag 49
    18275 Stocksund
    Sweden
    British37039080001
    PARTNER, Mark
    74 The Avenue
    M33 4WA Sale
    Cheshire
    Administrateur
    74 The Avenue
    M33 4WA Sale
    Cheshire
    British71956490002
    SKJOLDBORG, Finn
    6753 Agerback
    FOREIGN
    Denmark
    Administrateur
    6753 Agerback
    FOREIGN
    Denmark
    Danish540190001
    TOMMERUP, Peter
    Kildevaeldsgade 6
    DK 2100 Copenhagen
    Denmark
    Administrateur
    Kildevaeldsgade 6
    DK 2100 Copenhagen
    Denmark
    Danish540240002
    VAN DER LOO, Harry
    Bihhen Hof 1
    Asten
    5721 Vs
    Nl
    Administrateur
    Bihhen Hof 1
    Asten
    5721 Vs
    Nl
    Dutch77975280001
    VAN OOSTERHOUT, Adriaan
    Helil 75
    Hoeven
    4741rb
    Netherlands
    Administrateur
    Helil 75
    Hoeven
    4741rb
    Netherlands
    Dutch77975230001
    VERSTEGEN, Josef Hendrikus
    Stollenbergweg 3a
    6571 4a Berg En Dal
    Netherlands
    Administrateur
    Stollenbergweg 3a
    6571 4a Berg En Dal
    Netherlands
    NetherlandsDutch54942830001
    WALTERS, Anthony Joseph
    "Millbank", West Craigton Road
    Peterculter
    Aberdeen
    Administrateur
    "Millbank", West Craigton Road
    Peterculter
    Aberdeen
    British540200002
    WARING, Robert
    81 Edge End Lane
    Great Harwood
    BB6 7QD Blackburn
    Lancashire
    Administrateur
    81 Edge End Lane
    Great Harwood
    BB6 7QD Blackburn
    Lancashire
    British16012650001
    YEOMAN, John
    1 Hillside Gardens
    Westhill Skene
    AB32 6PB Aberdeen
    Scotland
    Administrateur
    1 Hillside Gardens
    Westhill Skene
    AB32 6PB Aberdeen
    Scotland
    Scottish34952400001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SUKL REALISATIONS 2020 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Anderson Way
    DA17 6BG Belvedere
    Infinity House
    England
    06 avr. 2016
    Anderson Way
    DA17 6BG Belvedere
    Infinity House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03193472
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour SUKL REALISATIONS 2020 LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    07 nov. 201607 nov. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    SUKL REALISATIONS 2020 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    15 juin 2020Administration started
    19 mai 2021Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Matthew Robert Haw
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    practitioner
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Paul Dounis
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    practitioner
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    2
    DateType
    19 mai 2021Commencement of winding up
    05 sept. 2024Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul Dounis
    Third Floor
    2 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    proposed liquidator
    Third Floor
    2 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Matthew Robert Haw
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    proposed liquidator
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0