HEWDEN PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHEWDEN PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC043085
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HEWDEN PROPERTIES LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe HEWDEN PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ey Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de HEWDEN PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour HEWDEN PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de passage de l'administration à la dissolution

    21 pages2.26B(Scot)

    Avis d'insuffisance d'actifs pour la distribution aux créanciers non garantis autres qu'en vertu de l'article S176A(2)(A)

    1 pages2.32B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    17 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    19 pages2.20B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Ey Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EB à Ey Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX le 04 déc. 2017

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Ernst & Young Llp 10 George Street Edinburgh EH2 2DZ à Ey Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EB le 27 nov. 2017

    2 pagesAD01

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    32 pages2.20B(Scot)

    Satisfaction de la charge SC0430850032 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0430850037 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0430850031 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0430850033 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0430850034 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0430850036 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Adrian Michael Murphy en tant que directeur le 14 févr. 2017

    2 pagesTM01

    Proposition réputée de l'administrateur

    116 pages2.16BZ(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    112 pages2.16B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.14B(Scot)

    9 pages2.15B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN à Ernst & Young Llp 10 George Street Edinburgh EH2 2DZ le 28 nov. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    Cessation de la nomination de Patrick Francis Jelly en tant que directeur le 30 juin 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juil. 2016

    État du capital au 28 juil. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Mr Patrick Francis Jelly en tant qu'administrateur le 15 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Hogg en tant que directeur le 26 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de HEWDEN PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHARDLOW, Susan
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    United Kingdom
    British151517240001
    HIERONS, Mark
    c/o Hewden Stuart
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    England
    Administrateur
    c/o Hewden Stuart
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    England
    EnglandBritishCompany Director178582490001
    HULL, Christopher John
    c/o Hewden Stuart Limited
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    England
    Administrateur
    c/o Hewden Stuart Limited
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    England
    United KingdomBritishChief Financial Officer165040000001
    SHARDLOW, Susan
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    Administrateur
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    United KingdomBritishFinance Director151325710002
    DEAKIN, Alastair Wright
    Wheatlands Hazelden Road
    Newton Mearns
    G77 6RR Glasgow
    Secrétaire
    Wheatlands Hazelden Road
    Newton Mearns
    G77 6RR Glasgow
    BritishChartered Accountant63127160001
    NETHERWAY, Robert William
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    Secrétaire
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    BritishDirector30995760008
    SPROUT, Douglas
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    Secrétaire
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    Canadian149464830001
    ALBISTON, Mark
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Administrateur
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    United KingdomBritishCompany Director101189350001
    BERG, Ian Christopher
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Administrateur
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    EnglandGbCompany Director153905520001
    BERG, Ian Christopher
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Administrateur
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    EnglandGbCompany Director153905520001
    DAVIES, Michael
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    Administrateur
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director140297230001
    DEAKIN, Alastair Wright
    Wheatlands Hazelden Road
    Newton Mearns
    G77 6RR Glasgow
    Administrateur
    Wheatlands Hazelden Road
    Newton Mearns
    G77 6RR Glasgow
    ScotlandBritishChartered Accountant63127160001
    DICKINSON, Neil Robert
    C/O Finning (Uk) Ltd.
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    Administrateur
    C/O Finning (Uk) Ltd.
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director102224030002
    FINDLAY, Alexander Fraser
    Pitfour 1 Leewood Park
    FK15 0NX Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    Pitfour 1 Leewood Park
    FK15 0NX Dunblane
    Perthshire
    BritishCo Director634480001
    FRASER, Andrew
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    Administrateur
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    United KingdomCanadianCompany Director117518070002
    GOODWIN, Matthew Dean, Sir
    87 Kelvin Court
    G12 0AH Glasgow
    Administrateur
    87 Kelvin Court
    G12 0AH Glasgow
    ScotlandBritishCa56200004
    HOGG, Mark Stephen
    c/o Hewden Stuart
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    England
    Administrateur
    c/o Hewden Stuart
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    England
    EnglandBritishCompany Director178582620001
    HOTCHKISS, Colin Archibald
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    Administrateur
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Staffordshire
    CanadianCompany Director133634850001
    HUGHES, Raymond
    Holmcroft Middleshaw
    Middleshaw
    DG11 1AJ Lockerbie
    Dumfriesshire
    Administrateur
    Holmcroft Middleshaw
    Middleshaw
    DG11 1AJ Lockerbie
    Dumfriesshire
    BritishCo Director634540001
    JARVIS, Paul James Christopher
    49 Oatlands Avenue
    KT13 9SS Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    49 Oatlands Avenue
    KT13 9SS Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishEngineer2293800001
    JELLY, Patrick Francis
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Administrateur
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    EnglandBritishSales And Marketing Director81626190002
    LEDGER, Raymond Henry
    4 Brunswick House 5/6 West Park
    HG1 1BL Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    4 Brunswick House 5/6 West Park
    HG1 1BL Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCo Director59499280002
    LLOYD, Nicholas Bradley
    Hewden, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    Administrateur
    Hewden, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    BritishManaging Director91982390004
    MURPHY, Adrian Michael
    Chester Road
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    England
    Administrateur
    Chester Road
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    England
    EnglandBritishChief Executive290625510001
    NAPIER, Alistair George St Clair
    33/13 Murrayfield Road
    EH12 6EP Edinburgh
    Scotland
    Administrateur
    33/13 Murrayfield Road
    EH12 6EP Edinburgh
    Scotland
    BritishCompany Director57915070001
    NETHERWAY, Robert William
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    Administrateur
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    United KingdomBritishDirector30995760008
    PARKES, Kevin
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    Administrateur
    Chester Road
    Stretford
    M32 0RL Manchester
    Trafford House
    United KingdomBritishDirector146059290002
    QUENBY, Roger Brian
    1 Millbrae
    Gargunnock
    FK8 3BB Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    1 Millbrae
    Gargunnock
    FK8 3BB Stirling
    Stirlingshire
    ScotlandBritishCo Director636400001
    SHERLOCK, Brian Foster
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    Administrateur
    Hewden Stuart Plc, Trafford House
    Chester Road, Stretford
    M32 0RL Manchester
    BritishDirector107903020002
    SPROUT, Douglas
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    Administrateur
    C/O Finning (Uk) Ltd
    Watling Street
    WS11 8LL Cannock
    Staffordshire
    United KingdomCanadianCompany Director149547490001
    STUART, Ronald Grierson
    17 Newlands Road
    Newlands
    G43 2JD Glasgow
    Administrateur
    17 Newlands Road
    Newlands
    G43 2JD Glasgow
    BritishBsc612540001
    WOODS, Darren John
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Administrateur
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    EnglandGbCfo155115730001

    HEWDEN PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 17 avr. 2015
    Livré le 21 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Ashmore lake way, willenhall WM991424 WM650360.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of America, N.A. (London Branch) as Agewnt and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 21 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 26 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 18 févr. 2015
    Livré le 20 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Old glamis road, dundee. As more particularly described in the instrument.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of America
    Transactions
    • 20 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 26 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 17 févr. 2015
    Livré le 20 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    2300 london road, glasgow. Title number LAN19031.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of America
    Transactions
    • 20 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 17 févr. 2015
    Livré le 20 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Old glamis road, dundee. Title number ANG5929.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of America
    Transactions
    • 20 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 26 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 17 févr. 2015
    Livré le 20 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    20 carmaben road, glasgow. Title number GLA101126.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of America
    Transactions
    • 20 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 26 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 févr. 2015
    Livré le 12 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Bryn works, llandegai, bangor and trademark number 2462395. see deed for further details.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of America, Na
    Transactions
    • 12 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 févr. 2015Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 26 févr. 2015Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 déc. 2015Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 26 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 10 févr. 2015
    Livré le 12 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of America, Na
    Transactions
    • 12 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 févr. 2015Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 févr. 2015Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 févr. 2015Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 26 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 04 sept. 2012
    Livré le 08 sept. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground at hazeldean gardens off gogar road einburgh.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 08 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 03 sept. 2012
    Livré le 06 sept. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tenants interest in lease over 1 ellismuir way, tannochside park, uddingston LAN146120.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 06 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 31 août 2012
    Livré le 18 sept. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tenant's interest in lease of 20 carmaben road, glasgow GLA101126.
    Personnes ayant droit
    • Fsjc Xi, Llc
    Transactions
    • 18 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 31 août 2012
    Livré le 18 sept. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease of ground at hazeldean gardens, off gogar road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Fsjc Xi, Llc
    Transactions
    • 18 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 31 août 2012
    Livré le 18 sept. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease of 1 ellismuir way, tannochside park, uddingston LAN146120.
    Personnes ayant droit
    • Fsjc Xi, Llc
    Transactions
    • 18 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 31 août 2012
    Livré le 18 sept. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2300 london road, glasgow LAN19031.
    Personnes ayant droit
    • Fsjc Xi, Llc
    Transactions
    • 18 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 31 août 2012
    Livré le 18 sept. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Old glamis road, dundee ANG5929.
    Personnes ayant droit
    • Fsjc Xi, Llc
    Transactions
    • 18 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 29 août 2012
    Livré le 06 sept. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Old glamis road, dundee ANG5929.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 06 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 29 août 2012
    Livré le 06 sept. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tenants interest in lease of 20 carmaben road, glasgow GLA101126.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 06 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 29 août 2012
    Livré le 06 sept. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2300 london road, glasgow LAN19031.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 06 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 11 août 2012
    Livré le 29 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Fsjc Xi, Llc
    Transactions
    • 29 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 29 août 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 mars 2015Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 mars 2015Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 déc. 2015Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Group debenture
    Créé le 11 août 2012
    Livré le 28 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 28 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 28 août 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 11 août 2012
    Livré le 28 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 28 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 28 août 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 10 août 2012
    Livré le 29 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Fsjc Xi, Llc
    Transactions
    • 29 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 29 août 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 mars 2015Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 mars 2015Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Supplemental legal charge
    Créé le 31 août 2010
    Livré le 14 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land and buildings on the north side of ellis road mitcham.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 14 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 12 août 2010
    Livré le 21 août 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease of ground at hazeldean gardens off gogar road edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 21 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 12 août 2010
    Livré le 21 août 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1 ellismuir way tannochside park uddingston.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 21 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 12 août 2010
    Livré le 21 août 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    20 carmaben road glasgow gla 101126.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 21 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    HEWDEN PROPERTIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    15 nov. 2018Administration ended
    22 nov. 2016Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0