REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED

REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC044625
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    First Floor, Quay 2,
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 sept. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    15 pages4.26(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de * Gala Clubs Regional Office Kerse Lane Falkirk FK1 1RJ* le 06 mars 2014

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 29 sept. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 mai 2013

    État du capital au 30 mai 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Harry Willits le 19 févr. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 24 sept. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 25 sept. 2010

    5 pagesAA

    legacy

    4 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    7 pagesMG03s

    Cessation de la nomination de Diane Penfold en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Harry Willits en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 26 sept. 2009

    5 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gala Coral Nominees Limited le 26 oct. 2009

    1 pagesCH02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Diane June Penfold le 13 nov. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 27 sept. 2008

    5 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 29 sept. 2007

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Secrétaire
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    69240850005
    WILLITS, Harry Andrew
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Administrateur
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish175965490001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Administrateur
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    CHEATLE, Martyn David
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    British149874460001
    HAMILTON, William Burt
    Douglas House 58c Allanfauld Road
    Cumbernauld
    Glasgow
    Secrétaire
    Douglas House 58c Allanfauld Road
    Cumbernauld
    Glasgow
    British1054590001
    HODGES, Simon
    Meadowbank 102 Crosshill Street
    Lennoxtown
    G66 7HQ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    Meadowbank 102 Crosshill Street
    Lennoxtown
    G66 7HQ Glasgow
    Lanarkshire
    British66090970001
    LANG, Anthony
    58 West Regent Street
    G2 2QZ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    58 West Regent Street
    G2 2QZ Glasgow
    Lanarkshire
    British557550001
    MACKAY, William Donald
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    Secrétaire
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    British796730001
    MAGEE, Martin Paul
    28 Barncluith Road
    ML3 7DQ Hamilton
    Lanarkshire
    Secrétaire
    28 Barncluith Road
    ML3 7DQ Hamilton
    Lanarkshire
    British1367560001
    MILLER, John Ashley Laing
    18 Learmonth Gardens
    EH4 1HB Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    18 Learmonth Gardens
    EH4 1HB Edinburgh
    Midlothian
    British97666900001
    MITCHELL, Andrew Ross
    Highwood
    PA13 4TA Kilmacolm
    Refrewshire
    Secrétaire
    Highwood
    PA13 4TA Kilmacolm
    Refrewshire
    British25359180002
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    Secrétaire
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    British52292450003
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Secrétaire
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    60530770001
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    Administrateur
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritish780950001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Administrateur
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish21686380006
    GRIFFITHS, Jonathan
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    Administrateur
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    British73691620003
    JENKINS, Stuart Nicol
    Parkview, 7 Arden Drive
    Giffnock
    G46 7AF Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    Parkview, 7 Arden Drive
    Giffnock
    G46 7AF Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish116623260001
    KELLY, John Michael
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    Administrateur
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    British56474600002
    MATTINGLEY, Brian Roger
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    British22417130001
    MCCARVILL, James
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    Administrateur
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    British24036030002
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    MILLER, John Ashley Laing
    18 Learmonth Gardens
    EH4 1HB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    18 Learmonth Gardens
    EH4 1HB Edinburgh
    Midlothian
    British97666900001
    O'CALLAGHAN, Francis
    21 Hamilton Avenue
    Pollokshields
    G41 4JG Glasgow
    Administrateur
    21 Hamilton Avenue
    Pollokshields
    G41 4JG Glasgow
    ScotlandBritish557570001
    PENFOLD, Diane June
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Administrateur
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    United KingdomBritish59962430002
    SCHOLARIOS, Fivos
    110 Haggs Road
    G41 4AT Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    110 Haggs Road
    G41 4AT Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish583820001
    SOWERBY, Richard Thomas Neville
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish47734920003
    STAKIS, Andros
    Glentyan House
    Glentyan Estate
    PA10 7JJ Kilbarchan
    Renfrewshire
    Administrateur
    Glentyan House
    Glentyan Estate
    PA10 7JJ Kilbarchan
    Renfrewshire
    British27237990001
    STAKIS, Reo, Sir
    54 Aytoun Road
    Pollokshields
    G41 5HE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    54 Aytoun Road
    Pollokshields
    G41 5HE Glasgow
    Lanarkshire
    British69301420001
    WAGGETT, Colin
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    Administrateur
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    British62266600001
    LADBROKE CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    62360460001

    REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 11 mai 2006
    Livré le 26 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 mai 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 nov. 2005
    Livré le 03 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 déc. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 27 oct. 2005
    Livré le 16 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with any secured document
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over property and assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 16 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 01 sept. 2005
    Livré le 20 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 20 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 août 2005
    Livré le 05 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 11 févr. 2005
    Livré le 24 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 24 févr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 10 févr. 2005
    Livré le 16 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with any finance document
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 févr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 17 mars 2003
    Livré le 21 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with any finance document
    Brèves mentions
    First legal mortgage over all real property in england and wales; first fixed equitable charge over all other real property; first fixed charge and first floating charge over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 21 mars 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 13 mars 2003
    Livré le 27 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston as Security Trustee
    Transactions
    • 27 mars 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 21 déc. 2000
    Livré le 10 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company
    Transactions
    • 10 janv. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 14 août 1991
    Livré le 03 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Stakis PLC
    Transactions
    • 03 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 17 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 14 août 1991
    Livré le 03 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent of and Trustee for the Bank
    Transactions
    • 03 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 19 janv. 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 28 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 févr. 2014Commencement of winding up
    11 oct. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0