MCCONNELL SALMON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMCCONNELL SALMON LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC045850
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MCCONNELL SALMON LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe MCCONNELL SALMON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Marine Harvest, Ratho Park
    88 Glasgow Road, Ratho Station
    EH28 8PP Newbridge
    Midlothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MCCONNELL SALMON LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour MCCONNELL SALMON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 nov. 2010

    État du capital au 26 nov. 2010

    • Capital: GBP 5,185,000
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages287

    Comptes établis au 31 déc. 2004

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MCCONNELL SALMON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THOMPSON, Lorraine Elizabeth
    40 Gardiner Road
    EH4 3RN Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    40 Gardiner Road
    EH4 3RN Edinburgh
    Midlothian
    British69247060001
    MCINTOSH, Kenneth James
    Colliers Way
    Whins Of Milton
    FK7 8FG Stirling
    10
    Stirlingshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Colliers Way
    Whins Of Milton
    FK7 8FG Stirling
    10
    Stirlingshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish124854160002
    SUTHERLAND, Alan George
    35 Corton Lea
    Alloway
    KA6 6GJ Ayr
    Administrateur
    35 Corton Lea
    Alloway
    KA6 6GJ Ayr
    ScotlandBritish121052220002
    ALEXANDER, Keith David Rennie
    3 West Terrace
    High Street
    TN17 3LG Cranbrook
    Kent
    Secrétaire
    3 West Terrace
    High Street
    TN17 3LG Cranbrook
    Kent
    British35984770001
    MILLER, Andrew Charles
    Rydal Lodge
    1 Goldenfields Close
    GU30 7EZ Liphook
    Hampshire
    Secrétaire
    Rydal Lodge
    1 Goldenfields Close
    GU30 7EZ Liphook
    Hampshire
    British38236230002
    WILLETT, Peter Frederick
    51 Beechwood
    EH49 6SE Linlithgow
    West Lothian
    Secrétaire
    51 Beechwood
    EH49 6SE Linlithgow
    West Lothian
    British45112230002
    CAWLEY, John Andrew
    Redcote 23 Henry Bell Street
    G84 7HL Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Redcote 23 Henry Bell Street
    G84 7HL Helensburgh
    Dunbartonshire
    British45899730001
    DAVIDSON, Donald Cameron Lamont
    191 Newhaven Road
    EH6 4QD Edinburgh
    Administrateur
    191 Newhaven Road
    EH6 4QD Edinburgh
    ScotlandBritish97047400001
    DEAR, Graeme, Dr
    16 William Place
    Scone
    PH2 6TF Perth
    Administrateur
    16 William Place
    Scone
    PH2 6TF Perth
    ScotlandBritish41516590002
    DEAR, Graeme
    6 Rowan Crescent
    Killearn
    G63 9RZ Glasgow
    Administrateur
    6 Rowan Crescent
    Killearn
    G63 9RZ Glasgow
    British41516590001
    DEN BIEMAN, Johannes Cornelius Antonius
    Anna Paulownalaan 48
    Nl-3818
    Ge Amersfoort
    The Netherlands
    Administrateur
    Anna Paulownalaan 48
    Nl-3818
    Ge Amersfoort
    The Netherlands
    NetherlandsDutch167379290002
    FLEAR, Frank Alan
    93 High Street
    Waltham
    DN37 0PN Grimsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    93 High Street
    Waltham
    DN37 0PN Grimsby
    North East Lincolnshire
    British2785880001
    GRAY, Paul Douglas
    1 Necton Road
    Wheathampstead
    AL4 8AT St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Necton Road
    Wheathampstead
    AL4 8AT St Albans
    Hertfordshire
    British55720410001
    GRONTVEDT, Havard Johannes
    9 Wedderburn Road
    FK15 0FN Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    9 Wedderburn Road
    FK15 0FN Dunblane
    Perthshire
    Norwegian105815350001
    HOSKINS, Lowell
    299 Weed Street
    FOREIGN New Canaan
    Usa
    Administrateur
    299 Weed Street
    FOREIGN New Canaan
    Usa
    Usa12150001
    JOHNSON, Hugh Bernard
    30 Burnhead Road
    Cumbernauld
    G68 9BT Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    30 Burnhead Road
    Cumbernauld
    G68 9BT Glasgow
    Lanarkshire
    British12200002
    KUIJPERS, Johannes Theodorus
    De Driest 7
    3953 BS Maasbergen
    Utrecht
    The Netherlands
    Administrateur
    De Driest 7
    3953 BS Maasbergen
    Utrecht
    The Netherlands
    Dutch66052320001
    LISTER, John David
    Greystones Bonnington Road
    EH45 9HF Peebles
    Administrateur
    Greystones Bonnington Road
    EH45 9HF Peebles
    British1324750001
    MCCRONE, Iain Alastair
    Cardsknolls
    KY7 6LP Markinch
    Fife
    Administrateur
    Cardsknolls
    KY7 6LP Markinch
    Fife
    ScotlandBritish907970001
    MCCUNN, Archibald Eddington
    3 Mcintosh Way
    ML1 3BB Motherwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    3 Mcintosh Way
    ML1 3BB Motherwell
    Lanarkshire
    British263890001
    MILLER, Allan Gerard
    13 Birchwood Gardens
    Bellsquarry Village
    EH54 9JR Livingston
    Administrateur
    13 Birchwood Gardens
    Bellsquarry Village
    EH54 9JR Livingston
    ScotlandScottish84080100001
    NESTEL, Barry Lionel
    38 Hatchlands Road
    RH1 6AT Redhill
    Surrey
    Administrateur
    38 Hatchlands Road
    RH1 6AT Redhill
    Surrey
    British12160001
    NICOLSON, Malise Allen
    Frog Hall Tilston
    SY14 7HB Malpas
    Cheshire
    Administrateur
    Frog Hall Tilston
    SY14 7HB Malpas
    Cheshire
    British12180001
    NORTHFIELD, Robin Derek
    42 Nelson Road
    SS6 8HB Rayleigh
    Essex
    Administrateur
    42 Nelson Road
    SS6 8HB Rayleigh
    Essex
    British12190001
    PARKER, Bruce Edwin
    Windham Road
    FOREIGN Marlborough
    Usa
    Administrateur
    Windham Road
    FOREIGN Marlborough
    Usa
    British1373860001
    ROBINSON, Edward Christopher
    142 Burbage Road
    SE21 7AG London
    Administrateur
    142 Burbage Road
    SE21 7AG London
    EnglandBritish12210001
    WILLETT, Peter Frederick
    51 Beechwood
    EH49 6SE Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    51 Beechwood
    EH49 6SE Linlithgow
    West Lothian
    British45112230002
    WILSON, Robert
    3 Pikes Knowe Court
    Cardrona
    EH45 9LP Peebles
    Borders
    Administrateur
    3 Pikes Knowe Court
    Cardrona
    EH45 9LP Peebles
    Borders
    ScotlandBritish84079420001
    WINDMILL, David Michael
    Priestfield Road North
    EH16 5HS Edinburgh
    2
    Administrateur
    Priestfield Road North
    EH16 5HS Edinburgh
    2
    ScotlandBritish82907910001

    MCCONNELL SALMON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Instrument of charge
    Créé le 10 févr. 1976
    Livré le 24 févr. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £20000
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Highlands & Islands Development Board
    Transactions
    • 24 févr. 1976Enregistrement d'une charge
    • 21 déc. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Instrument of charge
    Créé le 20 oct. 1971
    Livré le 28 oct. 1971
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £3,500
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Highlands & Islands Development Board
    Transactions
    • 28 oct. 1971Enregistrement d'une charge
    • 21 déc. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Instrument of charge & agreement
    Créé le 31 déc. 1968
    Livré le 13 janv. 1969
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £9,205
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Highlands & Islands Development Board
    Transactions
    • 13 janv. 1969Enregistrement d'une charge
    • 21 déc. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0