DF SUPPLIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDF SUPPLIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC046283
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DF SUPPLIES LIMITED ?

    • Commerce de gros non spécialisé de produits alimentaires, de boissons et de tabac (46390) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe DF SUPPLIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    First Floor, Quay 2,
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DF SUPPLIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DEEP FREEZE SUPPLIES LIMITED07 juin 199607 juin 1996
    DEEP FREEZE SUPPLIES (ABERDEEN) LIMITED30 janv. 196930 janv. 1969

    Quels sont les derniers comptes de DF SUPPLIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au27 mars 2010

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour DF SUPPLIES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour DF SUPPLIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    4 pages4.26(Scot)

    Avis de réunion finale des créanciers

    12 pages4.17(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 24 Blythswood Square Glasgow G2 4BG le 19 juil. 2012

    2 pagesAD01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 mars 2012

    État du capital au 28 mars 2012

    • Capital: GBP 4,206,063
    SH01

    Cessation de la nomination de Burrell Jayne Katherine en tant que secrétaire le 14 mars 2012

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 27 mars 2010

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jeremy Rossler Fitton le 25 févr. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Leo George Weston le 25 févr. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Burrell Jayne Katherine le 25 févr. 2011

    1 pagesCH03

    Cessation de la nomination de Tarsem Dhaliwal en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Ramsden en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Leo George Watson le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Nomination de Jeremy Rossler Fitton en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Leo George Watson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 27 mars 2009

    15 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    5 pages288a

    Qui sont les dirigeants de DF SUPPLIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FITTON, Jeremy Rossler, Mr.
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    First Floor, Quay 2,
    Administrateur
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    First Floor, Quay 2,
    EnglandBritish132712400001
    WESTON, Leo George
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    First Floor, Quay 2,
    Administrateur
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    First Floor, Quay 2,
    EnglandBritish74534820006
    AGGARWAL, Amit
    27 St Mary's Mansions
    St Mary's Terrace
    W2 1SQ London
    Secrétaire
    27 St Mary's Mansions
    St Mary's Terrace
    W2 1SQ London
    British113667030001
    ATTWOOD, Paul Gerard
    12 Holborn Drive
    L39 3QL Ormskirk
    Lancashire
    Secrétaire
    12 Holborn Drive
    L39 3QL Ormskirk
    Lancashire
    British72538660001
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    68 Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    Secrétaire
    68 Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    British78255980001
    CROWE, John Alexander
    21 Ashwood Road
    Bridge Of Don
    AB22 8XR Aberdeen
    Secrétaire
    21 Ashwood Road
    Bridge Of Don
    AB22 8XR Aberdeen
    British34854360001
    HOWARTH, David
    Cherry Bank
    Church Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EW Chester
    Cheshire
    Secrétaire
    Cherry Bank
    Church Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EW Chester
    Cheshire
    British107155000001
    JAYNE KATHERINE, Burrell
    Blythswood Square
    G2 4BG Glasgow
    24
    Secrétaire
    Blythswood Square
    G2 4BG Glasgow
    24
    British123593390001
    MOOREHEAD, Simon Charles Wheeler
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British101873090001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    Secrétaire
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    British48949090001
    SHEARER, James Addison
    Heathfield 6 Oldfold Walk
    AB13 0JG Milltimber
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    Heathfield 6 Oldfold Walk
    AB13 0JG Milltimber
    Aberdeenshire
    British61887100001
    THAIN, John Robert
    38 Corse Wynd
    Kingswells
    AB15 8TP Aberdeen
    Secrétaire
    38 Corse Wynd
    Kingswells
    AB15 8TP Aberdeen
    5813510002
    LEFEVRE & CO
    8 Rubislaw Terrace
    AB1 Aberdeen
    Secrétaire
    8 Rubislaw Terrace
    AB1 Aberdeen
    28350005
    SF SECRETARIES LIMITED
    80 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    80 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Midlothian
    101875740003
    THE FRANK LEFEVRE PRACTICE
    70 Carden Place
    AB10 1UP Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    70 Carden Place
    AB10 1UP Aberdeen
    Aberdeenshire
    37030660001
    BERRY, John Graham
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Administrateur
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    WalesBritish10711650001
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    Administrateur
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    United KingdomBritish135246350001
    CRAIG, Frederick John Robert
    Gateside
    KY14 7SX Cupar
    Freeland
    Fife
    United Kingdom
    Administrateur
    Gateside
    KY14 7SX Cupar
    Freeland
    Fife
    United Kingdom
    ScotlandBritish133316040001
    DHALIWAL, Tarsem Singh
    Ruthin Road
    CH7 4AF Gwernymynydd
    Ty Coch
    Flintshire
    Administrateur
    Ruthin Road
    CH7 4AF Gwernymynydd
    Ty Coch
    Flintshire
    United KingdomBritish151680990001
    ELSBY SMITH, Andrew Edward
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Administrateur
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritish114320980001
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    HOWARTH, David
    Cherry Bank
    Church Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EW Chester
    Cheshire
    Administrateur
    Cherry Bank
    Church Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EW Chester
    Cheshire
    British107155000001
    HUSTAD, Hans Kristian
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Administrateur
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Norwegian103594230001
    HYSLOP, Edward James
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritish127371260001
    HYSLOP, Edward James
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritish127371260001
    JOHANNESSON, Jon Asgeir
    Laufasvegur 69
    FOREIGN Reykjavik
    101
    Iceland
    Administrateur
    Laufasvegur 69
    FOREIGN Reykjavik
    101
    Iceland
    IcelandIcelandic78382920001
    MCBRIDE, Maurice
    Am Bruach
    Fore Road
    FK8 3DT Kippen
    Administrateur
    Am Bruach
    Fore Road
    FK8 3DT Kippen
    ScotlandBritish84209480001
    MILNE, Peter Gordon
    17 Hatton View
    PH2 7DA Perth
    Administrateur
    17 Hatton View
    PH2 7DA Perth
    British49203360001
    MORGAN, Stanley Charles Arthur
    The Sheiling
    Blackhall Road
    AB51 4JT Inverurie
    Aberdeenshire
    Administrateur
    The Sheiling
    Blackhall Road
    AB51 4JT Inverurie
    Aberdeenshire
    British55361230001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    Administrateur
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    United KingdomBritish48949090001
    PRITCHARD, Andrew Simon
    Kidnal Grange
    Kidnal
    SY14 7DJ Malpas
    Cheshire
    Administrateur
    Kidnal Grange
    Kidnal
    SY14 7DJ Malpas
    Cheshire
    United KingdomBritish42467790003
    RAMSDEN, Andrew Nicholas
    The Farmhouse
    Wood Lea Farm Shepley
    HD8 8ES Huddersfield
    Administrateur
    The Farmhouse
    Wood Lea Farm Shepley
    HD8 8ES Huddersfield
    EnglandBritish122765080001
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Administrateur
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    EnglandIcelandic114179720001
    THAIN, Andrew Bruce
    South Craigbank
    Kirk Brae
    AB1 9QL Cults
    Aberdeen
    Administrateur
    South Craigbank
    Kirk Brae
    AB1 9QL Cults
    Aberdeen
    British103540002
    THAIN, John Robert
    38 Corse Wynd
    Kingswells
    AB15 8TP Aberdeen
    Administrateur
    38 Corse Wynd
    Kingswells
    AB15 8TP Aberdeen
    5813510002

    DF SUPPLIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 14 mars 2007
    Livré le 19 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects now extending to 4.875 acres or thereby at craigshaw drive, west tullos industrial estate, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 19 mars 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 05 sept. 2006
    Livré le 23 sept. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 23 sept. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 22 août 2006
    Livré le 12 sept. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 12 sept. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 25 févr. 2005
    Livré le 03 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 déc. 1997
    Livré le 23 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.945 hectares of ground at M8 food park, keppochill road, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 déc. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 déc. 1997
    Livré le 22 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £244,500 and all other sums due or to become due
    Brèves mentions
    9447 sq metres at M8 food park, keppochill road, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Glasgow Development Agency
    Transactions
    • 22 déc. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 mai 1990
    Livré le 25 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease over ground at south west-side of craigshaw drive, west tullos industrial estate, aberdeen, and a sub-lease agreement.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 27 mars 1984
    Livré le 05 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    4 riverside drive 200 south college st aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    • 15 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 27 mars 1984
    Livré le 05 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground north of carsegate road north, inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 27 mars 1984
    Livré le 05 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Cold store south esplanade west aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 20 janv. 1984
    Livré le 24 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 janv. 1984Enregistrement d'une charge
    • 12 déc. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 20 juin 1983
    Livré le 11 juil. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground lying north east of carsegate road north, inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 juil. 1983Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 19 janv. 1983
    Livré le 31 janv. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    200 south college street, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 janv. 1983Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 12 nov. 1981
    Livré le 18 nov. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground west of ardarroch road and bounded on the east by ardarroch road, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 nov. 1981Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 12 nov. 1981
    Livré le 18 nov. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Torry cold store, south esplanade west, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 nov. 1981Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 20 janv. 1977
    Livré le 26 janv. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects in riverside drive,aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 janv. 1977Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 juil. 1976
    Livré le 16 juil. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    31 west church st buckie.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 juil. 1976Enregistrement d'une charge
    • 28 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 juil. 1976
    Livré le 16 juil. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop 17 high st turriff.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 juil. 1976Enregistrement d'une charge
    • 31 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 févr. 1974
    Livré le 15 févr. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due
    Brèves mentions
    529 great western road, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 févr. 1974Enregistrement d'une charge
    • 28 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Letter of set-off
    Créé le 22 mars 1972
    Livré le 28 mars 1972
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 mars 1972Enregistrement d'une charge
    • 31 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 févr. 1972
    Livré le 25 févr. 1972
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    61 powis terrace, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 févr. 1972Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 07 févr. 1972
    Livré le 25 févr. 1972
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 févr. 1972Enregistrement d'une charge
    • 09 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    DF SUPPLIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 mars 2015Dissolved on
    06 juil. 2012Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Russell Stewart Cash
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    practitioner
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Keith Veitch Anderson
    First Floor Quay 2
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    practitioner
    First Floor Quay 2
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0