ATHOLL BAPTIST CENTRE LIMITED

ATHOLL BAPTIST CENTRE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéATHOLL BAPTIST CENTRE LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société SC046703
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ATHOLL BAPTIST CENTRE LIMITED ?

    • Autres hébergements de vacances et autres hébergements collectifs (55209) / Hébergement et restauration

    Où se situe ATHOLL BAPTIST CENTRE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Atholl Baptist Centre
    Atholl Road
    PH16 5BX Pitlochry
    Perthshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ATHOLL BAPTIST CENTRE LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2021
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2022
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour ATHOLL BAPTIST CENTRE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Résolutions

    Resolutions
    6 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    The company(charity no.SC015113) converted into a scio on 07/03/22 10/11/2021
    RES13

    Nomination de Mrs Patricia Ann Menzies en tant qu'administrateur le 20 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Derek Boyd Murray en tant que directeur le 30 sept. 2021

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Statuts

    7 pagesMA

    Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2019

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Alan Oliver Berry en tant que directeur le 06 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Reverent William George Slack le 12 sept. 2019

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2018

    15 pagesAA

    Nomination de Mrs Eleanor Ruth Reed en tant qu'administrateur le 02 août 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Kenneth John Drysdale en tant qu'administrateur le 19 juin 2019

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2017

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2015

    14 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    9 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 juin 2016 sans liste des membres

    6 pagesAR01

    Nomination de Mrs Elizabeth Sarah Mcgrouther en tant qu'administrateur le 19 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 juin 2015 sans liste des membres

    8 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de ATHOLL BAPTIST CENTRE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PETRIE, George Macdonald
    Macfarlane Place
    EH52 5PS Uphall
    56
    West Lothian
    Scotland
    Secrétaire
    Macfarlane Place
    EH52 5PS Uphall
    56
    West Lothian
    Scotland
    British163007430001
    DICKSON, Alastair
    Aldour Court
    PH16 5BG Pitlochry
    19 Aldour Court
    Perthshire
    Scotland
    Administrateur
    Aldour Court
    PH16 5BG Pitlochry
    19 Aldour Court
    Perthshire
    Scotland
    ScotlandBritish189632460001
    DRYSDALE, Kenneth John
    Atholl Baptist Centre
    Atholl Road
    PH16 5BX Pitlochry
    Perthshire
    Administrateur
    Atholl Baptist Centre
    Atholl Road
    PH16 5BX Pitlochry
    Perthshire
    ScotlandBritish163081190001
    MCGROUTHER, Elizabeth Sarah
    Queen Street
    FK10 2AR Alloa
    16
    Clackmannanshire
    Scotland
    Administrateur
    Queen Street
    FK10 2AR Alloa
    16
    Clackmannanshire
    Scotland
    ScotlandBritish161904270001
    MENZIES, Patricia Ann
    Atholl Baptist Centre
    Atholl Road
    PH16 5BX Pitlochry
    Perthshire
    Administrateur
    Atholl Baptist Centre
    Atholl Road
    PH16 5BX Pitlochry
    Perthshire
    ScotlandBritish292042010001
    PETRIE, George
    Macfarlane Place
    EH54 5PS Uphall
    56
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    Macfarlane Place
    EH54 5PS Uphall
    56
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish155153920001
    REED, Eleanor Ruth
    Ballumbie Drive
    DD4 0NP Dundee
    68
    Scotland
    Administrateur
    Ballumbie Drive
    DD4 0NP Dundee
    68
    Scotland
    ScotlandBritish171725900001
    SLACK, William George, Reverent
    The Paddock
    ML3 0RF Hamilton
    93
    Scotland
    Administrateur
    The Paddock
    ML3 0RF Hamilton
    93
    Scotland
    ScotlandBritish191814770002
    TUCKLEY, Richard John
    Burrell Street
    PH7 4DG Crieff
    52
    Perthshire
    Scotland
    Administrateur
    Burrell Street
    PH7 4DG Crieff
    52
    Perthshire
    Scotland
    ScotlandBritish184831180001
    BEAUMONT, Paul Reid
    7 Laurel View
    Danestone
    AB22 8XZ Aberdeen
    Secrétaire
    7 Laurel View
    Danestone
    AB22 8XZ Aberdeen
    British34457700002
    FALCONER, William George
    Dail Na Coille 21 West Moulin Road
    PH16 5EA Pitlochry
    Perthshire
    Secrétaire
    Dail Na Coille 21 West Moulin Road
    PH16 5EA Pitlochry
    Perthshire
    British78640002
    MURRAY, Nan
    Flat 11 Arranview Court
    KA12 8ST Irvine
    Ayrshire
    Secrétaire
    Flat 11 Arranview Court
    KA12 8ST Irvine
    Ayrshire
    British70358200001
    WALKER, Iain Mcbay
    103 East Moulin Road
    PH16 5ER Pitlochry
    Perthshire
    Secrétaire
    103 East Moulin Road
    PH16 5ER Pitlochry
    Perthshire
    British48641580001
    WALLACE, Neville
    29 Knockard Place
    PH16 5JF Pitlochry
    Perthshire
    Secrétaire
    29 Knockard Place
    PH16 5JF Pitlochry
    Perthshire
    British123914120001
    BARCLAY, John Robert
    11 Bruntsfield Gardens
    EH10 4DX Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    11 Bruntsfield Gardens
    EH10 4DX Edinburgh
    Midlothian
    British918390002
    BEAUMONT, Paul Reid
    7 Laurel View
    Danestone
    AB22 8XZ Aberdeen
    Administrateur
    7 Laurel View
    Danestone
    AB22 8XZ Aberdeen
    British34457700002
    BERRY, Alan Oliver, Reverend
    Castle Row
    Mile Mark
    KY12 2AZ Dunfermline
    2
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    Castle Row
    Mile Mark
    KY12 2AZ Dunfermline
    2
    Fife
    Scotland
    United KingdomBritish35126950004
    BOWMAN, Heather
    Hillhouse Foulford Road
    KY4 9AS Cowdenbeath
    Fife
    Administrateur
    Hillhouse Foulford Road
    KY4 9AS Cowdenbeath
    Fife
    British48641400001
    BOYLE, Graham Sinclair Wallace
    Badaguish Urlar Road
    PH15 2ET Aberfeldy
    Perthshire
    Administrateur
    Badaguish Urlar Road
    PH15 2ET Aberfeldy
    Perthshire
    British48641620001
    BROWN, Elaine Morcary
    3 Knockard Crescent
    PH16 5JG Pitlochry
    Perthshire
    Administrateur
    3 Knockard Crescent
    PH16 5JG Pitlochry
    Perthshire
    British99054690001
    BURROWS, Ronald James
    4 Martin Gardens, Drumlaken Park
    Muthill
    PH5 2DG Crieff
    Perthshire
    Administrateur
    4 Martin Gardens, Drumlaken Park
    Muthill
    PH5 2DG Crieff
    Perthshire
    ScotlandBritish120020180001
    CLARK, Graeme Mcminn, Rev
    94 Barry Road
    KY2 6JL Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    94 Barry Road
    KY2 6JL Kirkcaldy
    Fife
    British1157940001
    CORMACK, David, Dr
    King's Gate
    St Mary's Tower
    PH8 0BJ Birnam
    Perthshire
    Administrateur
    King's Gate
    St Mary's Tower
    PH8 0BJ Birnam
    Perthshire
    British918430002
    CORMACK, Edith
    St. Marys Tower
    PH8 0BJ Birnam
    King's Castle
    Perthshire
    Administrateur
    St. Marys Tower
    PH8 0BJ Birnam
    King's Castle
    Perthshire
    British152513620001
    EVANS, David William John, Rev
    123 Kinghorne Road
    DD3 6PW Dundee
    Angus
    Administrateur
    123 Kinghorne Road
    DD3 6PW Dundee
    Angus
    British918410001
    FALCONER, William George
    Dail Na Coille 21 West Moulin Road
    PH16 5EA Pitlochry
    Perthshire
    Administrateur
    Dail Na Coille 21 West Moulin Road
    PH16 5EA Pitlochry
    Perthshire
    ScotlandBritish78640002
    FALCONER, William George
    Dail Na Coille 21 West Moulin Road
    PH16 5EA Pitlochry
    Perthshire
    Administrateur
    Dail Na Coille 21 West Moulin Road
    PH16 5EA Pitlochry
    Perthshire
    ScotlandBritish78640002
    GIRDWOOD, John Millar
    11 Martin Drive
    AB39 2LF Stonehaven
    Kincardineshire
    Administrateur
    11 Martin Drive
    AB39 2LF Stonehaven
    Kincardineshire
    British54680060001
    GRAHAM, Harry N
    36 Carleton Gate
    Giffnock
    G46 6NU Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    36 Carleton Gate
    Giffnock
    G46 6NU Glasgow
    Lanarkshire
    British918440001
    HENDERSON, David Methven
    27 Lundin View
    KY8 5TL Leven
    Fife
    Administrateur
    27 Lundin View
    KY8 5TL Leven
    Fife
    British70358250001
    KIRKLAND, Mary Jane Miriam
    2 Wilson Street
    KY4 9DQ Cowdenbeath
    Fife
    Administrateur
    2 Wilson Street
    KY4 9DQ Cowdenbeath
    Fife
    British1157950001
    MCINNES, Marjorie Mary
    Flat 4c Brisbane Court
    Braidpark Drive Giffnock
    G46 6LX Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    Flat 4c Brisbane Court
    Braidpark Drive Giffnock
    G46 6LX Glasgow
    Lanarkshire
    British83840003
    MCNEISH, Norman John
    38 Cannerton Park
    Milton Of Campsie
    G66 8HR Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    38 Cannerton Park
    Milton Of Campsie
    G66 8HR Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish117293190001
    MOYES, Thomas Watson, Reverend
    7 Hope Place
    St Monans
    KY10 2DJ Anstruther
    Fife
    Administrateur
    7 Hope Place
    St Monans
    KY10 2DJ Anstruther
    Fife
    British106140480001
    MUNDIE, Ian, Rev
    121 Nether Auldhouse
    G43 2YS Glasgow
    Administrateur
    121 Nether Auldhouse
    G43 2YS Glasgow
    British918420001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour ATHOLL BAPTIST CENTRE LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    16 juin 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    ATHOLL BAPTIST CENTRE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 07 déc. 1982
    Livré le 15 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Breadalbane villa, pitlochry, moulin.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 déc. 1982Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0