WHALSAY FISH PROCESSORS LIMITED

WHALSAY FISH PROCESSORS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWHALSAY FISH PROCESSORS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC047001
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WHALSAY FISH PROCESSORS LIMITED ?

    • (1520) /

    Où se situe WHALSAY FISH PROCESSORS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O CAMPBELL DALLAS
    Sherwood House 7 Glasgow Road
    PA1 3QS Paisley
    Renfrewshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WHALSAY FISH PROCESSORS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2009

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour WHALSAY FISH PROCESSORS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour WHALSAY FISH PROCESSORS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Avis de réunion finale des créanciers

    4 pages4.17(Scot)

    Avis de passage de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    7 pages2.25B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    7 pages2.20B(Scot)

    Avis d'insuffisance d'actifs pour la distribution aux créanciers non garantis autres qu'en vertu de l'article S176A(2)(A)

    1 pages2.32B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    7 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    7 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    2 pages2.22B(Scot)

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    7 pages2.20B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.13B(SCOT)

    21 pages2.15B(Scot)

    Proposition réputée de l'administrateur

    1 pages2.16BZ(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Symbister Ness Whalsay Shetland ZE2 9AA le 15 nov. 2010

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Symbister Ness Whalsay Shetland ZE2 9AA le 22 oct. 2010

    2 pagesAD01

    Comptes établis au 30 juin 2009

    22 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Charles en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 janv. 2010

    État du capital au 12 janv. 2010

    • Capital: GBP 83,333
    SH01

    Résolutions

    Resolutions
    16 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages410(Scot)

    Qui sont les dirigeants de WHALSAY FISH PROCESSORS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEASK, Valerie Christina
    Vaarhjem
    Hillhead, Symbister
    ZE2 9AQ Whalsay
    Shetland
    Secrétaire
    Vaarhjem
    Hillhead, Symbister
    ZE2 9AQ Whalsay
    Shetland
    British113983220001
    JOHNSON, Francis William
    Helenlea
    27 Hillhead
    ZE1 0EJ Lerwick
    Isle Of Shetland
    Ze1 0ej
    Administrateur
    Helenlea
    27 Hillhead
    ZE1 0EJ Lerwick
    Isle Of Shetland
    Ze1 0ej
    United KingdomBritish39950120001
    SIMPSON, Juliet
    Sandwick
    Symbister Whalsay
    ZE2 9AG Shetland
    Secrétaire
    Sandwick
    Symbister Whalsay
    ZE2 9AG Shetland
    British42771680001
    TAIT, John
    Breda
    East Voe
    ZE1 0US Scalloway
    Isle Of Shetland
    Secrétaire
    Breda
    East Voe
    ZE1 0US Scalloway
    Isle Of Shetland
    Scottish108238430001
    ANDERSON, John George
    Oot Bye, East Hamister
    Symbister
    ZE2 9AE Shetland
    Administrateur
    Oot Bye, East Hamister
    Symbister
    ZE2 9AE Shetland
    British79217080001
    BLACK, Robert Irvine
    Melview
    Bressay
    ZE2 9EL Shetland
    Isle Of Shetland
    Administrateur
    Melview
    Bressay
    ZE2 9EL Shetland
    Isle Of Shetland
    British67943540001
    CARTER, Robert Andrew
    26 West Leys Park
    Swanland
    HU14 3LS Hull
    North Humberside
    Administrateur
    26 West Leys Park
    Swanland
    HU14 3LS Hull
    North Humberside
    United KingdomBritish149410003
    CHARLES, Andrew
    Craignish
    12 Golf View Road
    AB15 9DQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Craignish
    12 Golf View Road
    AB15 9DQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish104240410001
    CLUNESS, Alexander Jamieson
    5 Twageos Road
    ZE1 0BB Lerwick
    Shetland Isles
    Administrateur
    5 Twageos Road
    ZE1 0BB Lerwick
    Shetland Isles
    ScotlandBritish92547740001
    INKSTER, John James
    Blaisdon
    Ocraquoy, Cunningsburgh
    ZE2 9HA Shetland
    Administrateur
    Blaisdon
    Ocraquoy, Cunningsburgh
    ZE2 9HA Shetland
    ScotlandBritish92971670001
    ISBISTER, Brian Neil
    Vestroena
    Walls
    ZE2 9PF Shetland
    Isle Of Shetland
    Administrateur
    Vestroena
    Walls
    ZE2 9PF Shetland
    Isle Of Shetland
    ScotlandBritish66566770001
    MCLEOD, Robert
    Woodstock
    Friester
    ZE2 9PP Skellister
    Shetland
    Administrateur
    Woodstock
    Friester
    ZE2 9PP Skellister
    Shetland
    British69459740001
    SIMPSON, Anthony George
    4 Vallafield
    ZE2 9XH Tingwall
    Shetland
    Administrateur
    4 Vallafield
    ZE2 9XH Tingwall
    Shetland
    ScotlandBritish54907140001
    TAIT, John
    Breda
    East Voe
    ZE1 0US Scalloway
    Isle Of Shetland
    Administrateur
    Breda
    East Voe
    ZE1 0US Scalloway
    Isle Of Shetland
    ScotlandScottish108238430001
    TAIT, John
    Breda
    East Voe
    ZE1 0US Scalloway
    Isle Of Shetland
    Administrateur
    Breda
    East Voe
    ZE1 0US Scalloway
    Isle Of Shetland
    ScotlandScottish108238430001
    TAIT, William
    Bonavista
    East Ireland
    ZE2 9JA Bigton
    Shetland
    Administrateur
    Bonavista
    East Ireland
    ZE2 9JA Bigton
    Shetland
    ScotlandBritish127630001
    WILLIAMSON, Andrew Anderson
    6 Brough
    Whalsay
    Shetland
    Administrateur
    6 Brough
    Whalsay
    Shetland
    British151490001
    WILLIAMSON, Larry
    Boothpark
    Whalsay
    ZE2 9AA Shetland
    Isle Of Shetland
    Administrateur
    Boothpark
    Whalsay
    ZE2 9AA Shetland
    Isle Of Shetland
    ScotlandBritish1380680001
    WILLIAMSON, Robert George
    Islesview
    Symbister
    Whalsay
    Shetland
    Administrateur
    Islesview
    Symbister
    Whalsay
    Shetland
    British151500001

    WHALSAY FISH PROCESSORS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 28 août 2009
    Livré le 09 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Shetland Islands Council
    Transactions
    • 09 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 08 avr. 2009
    Livré le 21 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 avr. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 14 oct. 2005
    Livré le 27 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 27 oct. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 10 nov. 1997
    Livré le 27 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £173,000
    Brèves mentions
    Ground at factory building & symbister, tonga, whalsay, nesting, shetland.
    Personnes ayant droit
    • Shetland Development Trust
    Transactions
    • 27 nov. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 18 sept. 1986
    Livré le 29 sept. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000 and all other sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Shetland Islands Council
    Transactions
    • 29 sept. 1986Enregistrement d'une charge
    • 05 mai 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 26 févr. 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Fishing boats mortgage
    Créé le 27 janv. 1983
    Livré le 15 févr. 1983
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Four shares in the fishing vessel ("santomarko") registered number LK20.
    Personnes ayant droit
    • C T Securities (Shetland) LTD
    Transactions
    • 15 févr. 1983Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 29 janv. 1980
    Livré le 06 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £40000
    Brèves mentions
    Factory at tonga symbister whalsay.
    Personnes ayant droit
    • Highlands and Islands Development Board
    Transactions
    • 06 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 01 avr. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Instrument of charge
    Créé le 16 janv. 1980
    Livré le 28 janv. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £40,000
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Highlands and Islands Development Board
    Transactions
    • 28 janv. 1980Enregistrement d'une charge
    • 01 avr. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Standard security
    Créé le 18 mai 1979
    Livré le 29 mai 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fish factory at tonga, symbister, whalsay, shetland.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 mai 1979Enregistrement d'une charge
    • 22 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 nov. 1977
    Livré le 18 nov. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000
    Brèves mentions
    Factory site at tonga, symbister, whalsay in the county of zetland together with the whole buildings erected thereon.
    Personnes ayant droit
    • The Highlands and Islands Development Board
    Transactions
    • 18 nov. 1977Enregistrement d'une charge
    • 01 avr. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Instrument of charge
    Créé le 28 oct. 1977
    Livré le 16 nov. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Highlands and Islands Development Board
    Transactions
    • 16 nov. 1977Enregistrement d'une charge
    • 01 avr. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 25 avr. 1977
    Livré le 03 mai 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 mai 1977Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 mai 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 mars 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 12 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    WHALSAY FISH PROCESSORS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 oct. 2010Administration started
    03 sept. 2012Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Derek Forsyth
    Campbell Dallas
    Sherwood House
    PA1 3QS 7 Glasgow Road
    Paisley
    practitioner
    Campbell Dallas
    Sherwood House
    PA1 3QS 7 Glasgow Road
    Paisley
    David K Hunter
    Sherwood House
    7 Glasgow Road
    PA1 3QS Paisley
    practitioner
    Sherwood House
    7 Glasgow Road
    PA1 3QS Paisley
    2
    DateType
    03 sept. 2012Commencement of winding up
    26 déc. 2014Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David K Hunter
    Titanium 1 King'S Inch Place
    G51 4BP Glasgow
    practitioner
    Titanium 1 King'S Inch Place
    G51 4BP Glasgow
    Derek Forsyth
    Titanium 1 Kings Inch Place
    G51 4BP Glasgow
    practitioner
    Titanium 1 Kings Inch Place
    G51 4BP Glasgow
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0