M.B.E. LEISURE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéM.B.E. LEISURE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC048440
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de M.B.E. LEISURE LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe M.B.E. LEISURE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de M.B.E. LEISURE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MINOR BINGO ENTERTAINMENTS (SCOTLAND) LIMITED19 févr. 197119 févr. 1971

    Quels sont les derniers comptes de M.B.E. LEISURE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour M.B.E. LEISURE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)
    S1MDXH9U

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 24 févr. 2012

    LRESSP

    Résolutions

    Resolutions
    12 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 16/02/2012
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA
    A6S3HXVK

    Modification des coordonnées du secrétaire Rank Nemo (Twenty-Six) Limited le 05 sept. 2011

    1 pagesCH04
    XQL2XXIM

    legacy

    3 pagesMG02s
    SRJZ8XBH

    legacy

    3 pagesMG02s
    SRJZ7XBG

    legacy

    3 pagesMG02s
    SRJZ6XBF

    legacy

    3 pagesMG02s
    SRJZ5XBE

    legacy

    3 pagesMG02s
    SRJZCXBL

    legacy

    3 pagesMG02s
    SRJZZXB8

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 avr. 2011

    État du capital au 04 avr. 2011

    • Capital: GBP 750
    SH01
    X8LUET0R

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA
    A7XVCLDJ

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    XPJ6IJLX

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Frances Bingham le 01 mars 2010

    2 pagesCH01
    XBDSPHXG

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA
    A5I94CYK

    legacy

    3 pages363a
    X4JXX8TF

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA
    AYWH641W

    legacy

    2 pages288a
    X24MFZWZ

    legacy

    1 pages288b
    X24MEZWY

    legacy

    3 pages363a
    XPNAKYCD

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de M.B.E. LEISURE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THE RANK ORGANISATION LIMITED
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    116576210002
    BINGHAM, Frances
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Administrateur
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    United KingdomBritishSolicitor128838610001
    DE MIGUEL, Fiona Margaret
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    Secrétaire
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    British 42996540002
    DOCKRELL, Carol Ann
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    Secrétaire
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    British26244410001
    DUFFILL, Clare Marianne
    91a Crystal Palace Road
    SE22 9EY London
    Secrétaire
    91a Crystal Palace Road
    SE22 9EY London
    BritishChartered Secretary71005690004
    PATEL, Aurelia Azalea
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    Secrétaire
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    BritishCompany Secretariat Assistant108784710001
    TAYLOR, Dorothy Muriel
    100 Halbeath Road
    KY12 7LR Dunfermline
    Fife
    Secrétaire
    100 Halbeath Road
    KY12 7LR Dunfermline
    Fife
    British338110001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Secrétaire
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    British34191470001
    WARD, Allan
    23 Broom Road
    KY13 7BU Kinross
    Fife
    Secrétaire
    23 Broom Road
    KY13 7BU Kinross
    Fife
    British338120001
    WATKINS, Simon Andrew
    6 Errington Close
    Chadwell St Mary
    RM16 4TA Grays
    Essex
    Secrétaire
    6 Errington Close
    Chadwell St Mary
    RM16 4TA Grays
    Essex
    British34048840001
    ANDERSON, Barry
    Plantation House
    Dargate
    ME13 9HB Faversham
    Kent
    Administrateur
    Plantation House
    Dargate
    ME13 9HB Faversham
    Kent
    British694090001
    COLES, Pamela Mary
    36 London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    36 London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary70326980002
    CORMICK, Charles Bruce Arthur
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    Administrateur
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    United KingdomBritishCompany Secretary17946190001
    DE BOER, David Hessell
    The Knowe
    Rumbling Bridge
    KY13 7PT Kinross
    Fife
    Administrateur
    The Knowe
    Rumbling Bridge
    KY13 7PT Kinross
    Fife
    BritishCompany Director338130001
    DE MIGUEL, Fiona Margaret
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    British 42996540002
    DOCKRELL, Carol Ann
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    Administrateur
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    BritishSecretary26244410001
    DUFFILL, Clare Marianne
    25 Landells Road
    SE22 9PG London
    Administrateur
    25 Landells Road
    SE22 9PG London
    BritishChartered Secretary71005690005
    HOW, David Alfred George, Mr.
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritishSecretary21860001
    KELLY, John Michael
    Willow Bank Cottage
    Wicken Road Clavering
    CB11 4QT Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Willow Bank Cottage
    Wicken Road Clavering
    CB11 4QT Saffron Walden
    Essex
    BritishLeisure56474600001
    PATEL, Aurelia Azalea
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    Administrateur
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    BritishCompany Secretariat Assistant108784710001
    RICHARDSON, William Milne
    Dunslair House
    EH45 8RL Peebles
    Administrateur
    Dunslair House
    EH45 8RL Peebles
    BritishCompany Director338140001
    TAYLOR, Dorothy Muriel
    100 Halbeath Road
    KY12 7LR Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    100 Halbeath Road
    KY12 7LR Dunfermline
    Fife
    BritishCompany Director338110001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish34191470001
    TIMMONS, Joseph Patrick
    55 Station Road
    KY5 9QX Lochgelly
    Fife
    Administrateur
    55 Station Road
    KY5 9QX Lochgelly
    Fife
    BritishCompany Director338150001
    WARD, Allan
    23 Broom Road
    KY13 7BU Kinross
    Fife
    Administrateur
    23 Broom Road
    KY13 7BU Kinross
    Fife
    BritishCompany Director338120001
    WATKINS, Simon Andrew
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    Administrateur
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    BritishChartered Secretary34048840002

    M.B.E. LEISURE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 01 oct. 1987
    Livré le 07 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    101E queensferry rd rosyth, dunfermline.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 26 mai 1986
    Livré le 04 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Rialto bingo hall lochee dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 juin 1986Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 15 févr. 1983
    Livré le 02 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £55,000
    Brèves mentions
    The rialto bingo hall, gray's lane lochee, dundee.
    Personnes ayant droit
    • Gray's Cinemas LTD
    Transactions
    • 02 mars 1983Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 15 juin 1982
    Livré le 18 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole property and undertaking of miner bingo entertainments (scotland) LTD.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 juin 1982Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 11 juin 1982
    Livré le 15 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £250,000
    Brèves mentions
    The whole property and undertaking of minor bingo entertainments (scotland) limited.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kingsway Entertainments LTD
    Transactions
    • 15 juin 1982Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 21 mai 1982
    Livré le 07 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Cinema de luxe and cafe at 20/22 bank street lochgelly, picture house at 83 high street cowdenbeath, regal cinema main street kelby rex cinema, auchterderran including opera house clubroom, lochgelly.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 juin 1982Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 21 mai 1982
    Livré le 07 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £250,000
    Brèves mentions
    Cinema de luxe and cafe at 20/22 bank street lochgelly, picture house at.
    Personnes ayant droit
    • Kingsway Entertainments Limited
    Transactions
    • 07 juin 1982Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 05 févr. 1981
    Livré le 18 févr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Cinema de luxe and cafe at 20/22 bank street lochgelly, picture house at 83 high street cowdenbeath, regal cinema main street kelly rex cinema, auchterderran.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 févr. 1981Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 26 juil. 1974
    Livré le 02 août 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due from the company/minto developments LTD and minor bingo (scotland) limited to the chargee
    Brèves mentions
    Cinema de luxe, lochgelly and 26 & 34 bank st. Lochgelly, fife.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 août 1974Enregistrement d'une charge
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 26 juil. 1974
    Livré le 02 août 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due from the company/minto developments LTD and minor bingo (scotland) limited to the chargee
    Brèves mentions
    Subjects in cartmore rd, lochgelly, fife.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 août 1974Enregistrement d'une charge
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 26 juil. 1974
    Livré le 02 août 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due from the company/minto developments LTD and minor bingo (scotland) limited to the chargee
    Brèves mentions
    Regal cinema, main st. Kelty fife.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 août 1974Enregistrement d'une charge
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 26 juil. 1974
    Livré le 02 août 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due from the company/minto developments LTD and in minor bingo (scotland) limited to the chargee
    Brèves mentions
    The picture house, cowdenbeath.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 août 1974Enregistrement d'une charge
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 26 juil. 1974
    Livré le 02 août 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due from the company/minto developments LTD and minor bingo (scotland) limited to the chargee
    Brèves mentions
    Rex cinema, cardenden fife.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 août 1974Enregistrement d'une charge
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 26 juil. 1974
    Livré le 02 août 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due from the company/minto developments LTD and minor bingo (scotland) limited to the chargee
    Brèves mentions
    The halfway house, kingseat fife.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 août 1974Enregistrement d'une charge
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)

    M.B.E. LEISURE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 févr. 2013Dissolved on
    24 févr. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0