LINDSAY PLANT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLINDSAY PLANT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC049012
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LINDSAY PLANT LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe LINDSAY PLANT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Hydrex Equipment (Uk) Ltd
    Duntilland Road
    ML7 4NZ Salsburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LINDSAY PLANT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour LINDSAY PLANT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2010 au 30 juin 2011

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 avr. 2011

    État du capital au 15 avr. 2011

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Carl Mark D'ammassa le 19 mars 2011

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Alan James Jordan en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Wood en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Wood en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    legacy

    17 pagesMG01s

    legacy

    34 pagesMG01s

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Carl Mark D'ammassa le 19 mars 2010

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Carl Mark D'ammassa en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Simcox en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2006

    9 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages288c

    legacy

    2 pages288c

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de LINDSAY PLANT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    D'AMMASSA, Carl Mark
    C/O Hydrex Equipment (Uk) Ltd
    Duntilland Road
    ML7 4NZ Salsburgh
    Administrateur
    C/O Hydrex Equipment (Uk) Ltd
    Duntilland Road
    ML7 4NZ Salsburgh
    United KingdomBritish147037660007
    JORDAN, Alan James
    C/O Hydrex Equipment (Uk) Ltd
    Duntilland Road
    ML7 4NZ Salsburgh
    Administrateur
    C/O Hydrex Equipment (Uk) Ltd
    Duntilland Road
    ML7 4NZ Salsburgh
    EnglandIrish150320720001
    ADDIS, Jonathan Peter
    Park Hill
    B13 8DS Birmingham
    98
    West Midlands
    United Kingdom
    Secrétaire
    Park Hill
    B13 8DS Birmingham
    98
    West Midlands
    United Kingdom
    British260439420001
    DEMPSTER, Janet Margaret
    53 Muir Drive
    KA17 0ET Darvel
    Ayrshire
    Secrétaire
    53 Muir Drive
    KA17 0ET Darvel
    Ayrshire
    British824120001
    MCCARROLL, Peter
    Grangevale
    Bigholm Road
    KA15 2JQ Beith
    Ayrshire
    Secrétaire
    Grangevale
    Bigholm Road
    KA15 2JQ Beith
    Ayrshire
    British70927950001
    SEYMOUR, Paul Richard
    14 Campanula Drive
    Meadow Brook
    NP10 9JG Rogerstone
    Newport
    Secrétaire
    14 Campanula Drive
    Meadow Brook
    NP10 9JG Rogerstone
    Newport
    British75293670002
    WOOD, Andrew Simon
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    Secrétaire
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    British33951380003
    GARVEY, Paul Maurice
    2a Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    2a Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish70932160001
    HUME, John Montgomery
    4 Avon Grove
    Barnton
    EH4 6RF Edinburgh
    Administrateur
    4 Avon Grove
    Barnton
    EH4 6RF Edinburgh
    British130550001
    LINDSAY, George Duncan
    Greystoneknowe
    Craigie
    KA1 5JT Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    Greystoneknowe
    Craigie
    KA1 5JT Kilmarnock
    Ayrshire
    British63712870001
    LINDSAY, James Dunlop
    1 Laurel Place
    KA1 2HB Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    1 Laurel Place
    KA1 2HB Kilmarnock
    Ayrshire
    British824140001
    MCCARROLL, Peter
    Grangevale
    Bigholm Road
    KA15 2JQ Beith
    Ayrshire
    Administrateur
    Grangevale
    Bigholm Road
    KA15 2JQ Beith
    Ayrshire
    ScotlandBritish70927950001
    MILLAR, William Gerard
    12 Holmlands Place
    KA1 1UT Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    12 Holmlands Place
    KA1 1UT Kilmarnock
    Ayrshire
    British67524510001
    MURTAGH, Joseph
    2 Arnbrae Farm Steadings
    Glasgow Road, Kilsyth
    G65 9AF Glasgow
    North Lanarkshire
    Administrateur
    2 Arnbrae Farm Steadings
    Glasgow Road, Kilsyth
    G65 9AF Glasgow
    North Lanarkshire
    ScotlandBritish97596570001
    SIMCOX, Andrew James
    Ashley Drive South
    Ashley Heath
    BH24 2JP Ringwood
    53
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Drive South
    Ashley Heath
    BH24 2JP Ringwood
    53
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish41023640002
    TAYLOR, Robert
    18 Kerr Drive
    KA12 0JH Irvine
    Ayrshire
    Administrateur
    18 Kerr Drive
    KA12 0JH Irvine
    Ayrshire
    British48197400001
    WOOD, Andrew Simon
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    Administrateur
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    United KingdomBritish33951380003

    LINDSAY PLANT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Accession deed
    Créé le 23 juil. 2010
    Livré le 09 août 2010
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Floating charge
    Créé le 23 juil. 2010
    Livré le 09 août 2010
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Floating charge
    Créé le 03 mars 2005
    Livré le 17 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 17 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 21 févr. 2003
    Livré le 10 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bridgepoint Capital (Nominees) Limited
    Transactions
    • 10 mars 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 21 févr. 2003
    Livré le 26 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 26 sept. 2000
    Livré le 03 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All or any debts owing or accruing to the company now or at any time hereafter (and all rights relative thereto) which are or are purported to be subject to the agreement but in respect of which title has not passed to and vested in rbif or to which rbif is not otherwise absolutely entitled and which are or may be from time to time while the charge is in force comprised in the companys property and undertaking.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 03 oct. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 mai 1995
    Livré le 13 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Balmoral road,kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 juin 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 mai 1995
    Livré le 07 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    172.08 poles at balmoral road, kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 juin 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 mai 1995
    Livré le 05 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 juin 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 23 janv. 1990
    Livré le 29 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 29 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 05 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 09 mars 1973
    Livré le 15 mars 1973
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due and to become due
    Brèves mentions
    The whole property.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 mars 1973Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0