SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.

SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC049239
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD. ?

    • Autre vente au détail de marchandises neuves en magasin spécialisé (à l'exclusion des galeries d'art commerciales et des opticiens) (47789) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD. ?

    Adresse du siège social
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD. ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SALON SERVICES (HAIRDRESSING SUPPLIES) LIMITED27 sept. 197127 sept. 1971

    Quels sont les derniers comptes de SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD. ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2021

    10 pagesAA

    État du capital au 12 avr. 2022

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolutions

    £2,460,344 standing to the credit of the company's capital contribution reserve capitalised to sally uk holdngs LTD 26/01/2022
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    État du capital après une attribution d'actions au 26 janv. 2022

    • Capital: GBP 2,465,344
    3 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 08 févr. 2022 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2020

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 févr. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2019

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 févr. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Nina Azemoudeh en tant que secrétaire le 13 nov. 2019

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2018

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 févr. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2017

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Joanne Sarah Finch en tant que directeur le 30 mars 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Heidi Van Ocken en tant qu'administrateur le 23 mars 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Olivier Badezet en tant qu'administrateur le 23 mars 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 08 févr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Sally Uk Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 févr. 2018

    2 pagesPSC05

    Qui sont les dirigeants de SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BADEZET, Olivier
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    FranceFrench245094380001
    SCARR, Warren Peter
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Administrateur
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    EnglandBritish187830740001
    VAN OCKEN, Heidi
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    BelgiumBelgian245092140001
    AITKEN, Brian
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    Secrétaire
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    British610080001
    AZEMOUDEH, Nina
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Secrétaire
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    British148931910001
    NORTH, David John
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British76739920001
    AITKEN, Brian
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    Administrateur
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    ScotlandBritish610080001
    BURNS, Margaret Bell
    8 Windhill Park
    Waterfoot, Eaglesham
    G76 0HH Glasgow
    Administrateur
    8 Windhill Park
    Waterfoot, Eaglesham
    G76 0HH Glasgow
    Scotland, UkBritish55852770003
    CONNOLLY, Michael John
    73 Lochhead Avenue
    Lochwinnoch
    PA12 4AW Glasgow
    Renfrewshire
    Administrateur
    73 Lochhead Avenue
    Lochwinnoch
    PA12 4AW Glasgow
    Renfrewshire
    United KingdomBritish117746340001
    DEWEY, Michael John
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Administrateur
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    UkAmerican199356850001
    DIAMOND, Robin C
    Glavecottage, 41 Spa Road
    BT24 8PT Ballynahinch
    Co.Down
    Administrateur
    Glavecottage, 41 Spa Road
    BT24 8PT Ballynahinch
    Co.Down
    British610710006
    FAULKNER, Mark
    Wolf Run
    76226 Bartonville
    304
    Texas
    Usa
    Administrateur
    Wolf Run
    76226 Bartonville
    304
    Texas
    Usa
    UsaAmerican136766440001
    FINCH, Joanne Sarah
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Administrateur
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    United KingdomBritish158146620001
    HEGARTY, Gerard P
    Glen Imm
    KA7 4ES Alloway
    Ayrshire
    Administrateur
    Glen Imm
    KA7 4ES Alloway
    Ayrshire
    ScotlandBritish610090002
    HEGARTY, Maureen
    Glen Imm
    Alloway
    Ayrshire
    Scotland
    Administrateur
    Glen Imm
    Alloway
    Ayrshire
    Scotland
    British17646720001
    HULL, Richard George
    Belvedere House
    Belvedere Drive
    RG14 7DB Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Belvedere House
    Belvedere Drive
    RG14 7DB Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish108758410001
    MACDONOUGH, Gordon S
    Nethermill Drumore Road
    Killearn
    G63 9NX Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    Nethermill Drumore Road
    Killearn
    G63 9NX Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish610120003
    NICHOLSON, Alistair
    1a Bellvue Road
    Kirkintilloch
    Glasgow
    Administrateur
    1a Bellvue Road
    Kirkintilloch
    Glasgow
    British610690007
    NORTH, David John
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Administrateur
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish76739920001
    PECKHAM, Stephen
    Wharfedale Road
    Winnersh Triangle
    RG41 5TP Wokingham
    210
    Berkshire
    Uk
    Administrateur
    Wharfedale Road
    Winnersh Triangle
    RG41 5TP Wokingham
    210
    Berkshire
    Uk
    EnglandBritish69764870003
    POSTON, John
    5 Minoru Place
    RG42 4HS Binfield
    Berkshire
    Administrateur
    5 Minoru Place
    RG42 4HS Binfield
    Berkshire
    American97966830002
    WINTERHALTER, Gary Gene
    702 Sunny Haven Court
    Highland Village
    Texas 75077
    United States
    Administrateur
    702 Sunny Haven Court
    Highland Village
    Texas 75077
    United States
    American113530080001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD. ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Sally Uk Holdings Limited
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Inspired, Ground Floor
    Berkshire
    England
    06 avr. 2016
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Inspired, Ground Floor
    Berkshire
    England
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegister Of Companies
    Numéro d'enregistrement05836805
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 30 janv. 2004
    Livré le 16 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease over block 7, evanton drive, thornliebank industrial estate, glasgow GLA124713 GLA15264.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 févr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 juin 1990
    Livré le 02 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot 69 (flat 83/8) lancefield quay glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 05 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 avr. 1989
    Livré le 20 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2.37 acres at hillington industrial estate, glasgow (82/90 kelvin avenue, hillington).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 04 janv. 1989
    Livré le 23 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The dome, 66/74 broomielaw glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 avr. 1988
    Livré le 14 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground lying north of broomielaw containing 197 square yards and 5 square feet.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 févr. 1988
    Livré le 22 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5-9 oswald street, glasgow 3-9 oswald street, glasgow 54-62 broomielaw, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 févr. 1986
    Livré le 27 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    29/31/33/35 bridge st, glasgow 151/153/155 oxford st, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 05 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 26 mars 1984
    Livré le 12 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease 12A cloisters court see page 2 doc 51.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    • 15 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 sept. 1981
    Livré le 25 nov. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects north east of said subjects.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 nov. 1982Enregistrement d'une charge
    • 05 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 sept. 1981
    Livré le 25 nov. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    134 to 150 broomielaw, 4 to 12 james watt street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 nov. 1982Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 23 nov. 1976
    Livré le 01 déc. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 déc. 1976Enregistrement d'une charge
    • 22 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Gr. Midlothian standard security
    Créé le 12 nov. 1975
    Livré le 20 nov. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground floor & basement premises known as 50/52 bernard st. Leith, in the city of edinburgh & county of midlothian.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 nov. 1975Enregistrement d'une charge
    • 05 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0