TARMAC SAND & GRAVEL LIMITED

TARMAC SAND & GRAVEL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTARMAC SAND & GRAVEL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC049264
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TARMAC SAND & GRAVEL LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TARMAC SAND & GRAVEL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cambusnethan House
    Linnet Way
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TARMAC SAND & GRAVEL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SPRINGFIELD QUARRY PRODUCTS (BLANEFIELD) LIMITED24 mars 199524 mars 1995
    ALFRED MCALPINE QUARRY PRODUCTS (BLANEFIELD) LIMITED24 juin 199324 juin 1993
    A. TULLOCH & SONS (PLANT) LIMITED01 oct. 197101 oct. 1971

    Quels sont les derniers comptes de TARMAC SAND & GRAVEL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour TARMAC SAND & GRAVEL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael John Choules le 01 juin 2016

    2 pagesCH01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 18 déc. 2015

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Lafarge Tarmac Directors (Uk) Limited en tant que directeur le 27 août 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Michael John Choules en tant qu'administrateur le 27 août 2015

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées du secrétaire Lafarge Tarmac Secretaries (Uk) Limited le 27 août 2015

    1 pagesCH04

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 janv. 2015

    État du capital au 23 janv. 2015

    • Capital: GBP 1,600
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    3 pagesAA

    Nomination de Mrs Fiona Puleston Penhallurick en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Bolter en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Lafarge Tarmac Secretaries (Uk) Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Tarmac Nominees Two Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Lafarge Tarmac Directors (Uk) Limited en tant qu'administrateur

    2 pagesAP02

    Cessation de la nomination de Tarmac Nominees Two Limited en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Tarmac Nominees Limited en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 janv. 2014

    État du capital au 28 janv. 2014

    • Capital: GBP 1,600
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Christopher Bolter le 03 déc. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Tarmac Nominees Two Limited le 02 déc. 2013

    2 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Tarmac Nominees Limited le 02 déc. 2013

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Tarmac Nominees Two Limited le 02 déc. 2013

    2 pagesCH02

    Résolutions

    Resolutions
    22 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Sect 175/conflicts of interest/sect 239 company be ratified 23/09/2013
    RES13
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    1 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TARMAC SAND & GRAVEL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TARMAC SECRETARIES (UK) LIMITED
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement532256
    9859690020
    CHOULES, Michael John
    Cambusnethan House
    Linnet Way
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    Administrateur
    Cambusnethan House
    Linnet Way
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    United KingdomBritishAccountant178681090002
    PENHALLURICK, Fiona Puleston
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    Administrateur
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director147397910001
    BORT, Stefan Edward
    126 Grove Park
    SE5 8LD London
    Secrétaire
    126 Grove Park
    SE5 8LD London
    British32824200005
    CALLADINE, Paul George
    9 Glanrafon Flats
    Southsea
    LL11 5NS Wrexham
    Clwyd
    Secrétaire
    9 Glanrafon Flats
    Southsea
    LL11 5NS Wrexham
    Clwyd
    British38866320001
    LEVEN, Steven
    69 Northolt Road
    HA2 0LP South Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    69 Northolt Road
    HA2 0LP South Harrow
    Middlesex
    British37605240001
    MATTHEWS, Karen Margaret
    Avalon 12 Noctorum Avenue
    L43 9SA Birkenhead
    Merseyside
    Secrétaire
    Avalon 12 Noctorum Avenue
    L43 9SA Birkenhead
    Merseyside
    British38721010001
    STEWART, Katherine M
    22 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RB Inverness
    Inverness Shire
    Secrétaire
    22 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RB Inverness
    Inverness Shire
    British565690001
    STIRK, James Richard
    Drovers Cottage
    53 Upper Cound Cound
    SY5 6AS Shrewsbury
    Shropshire
    Secrétaire
    Drovers Cottage
    53 Upper Cound Cound
    SY5 6AS Shrewsbury
    Shropshire
    BritishSolicitor34328400001
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Secrétaire
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    British1321720003
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Secrétaire
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    British1321720003
    TARMAC NOMINEES TWO LIMITED
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3782704
    68229150002
    ABBOTT, Ivan Michael
    Avondale Whitchurch Road
    Christleton
    CH3 6AE Chester
    Cheshire
    Administrateur
    Avondale Whitchurch Road
    Christleton
    CH3 6AE Chester
    Cheshire
    BritishChartered Civil Engineer5779910001
    ANCELL, James Ross
    21 Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    Avon
    Administrateur
    21 Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    Avon
    British New ZealandAccountant5839620003
    BOLTER, Andrew Christopher
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    Administrateur
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant146583270001
    BORT, Stefan Edward
    180a Underhill Road
    SE22 0QH London
    Administrateur
    180a Underhill Road
    SE22 0QH London
    BritishChartered Secretary32824200001
    BOWATER, John Ferguson
    4 Parkers Court
    Coven
    WV9 5JZ Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    4 Parkers Court
    Coven
    WV9 5JZ Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector Of Companies33052570012
    CAMERON, Neil Stuart
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    Administrateur
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    ScotlandBritishChartered Surveyor34848670001
    CHATER, Andrew John Gordon
    Sunnyside
    North St Winkfield
    SL4 4SY Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    Sunnyside
    North St Winkfield
    SL4 4SY Windsor
    Berkshire
    Australian/BritishChartered Accountant50346110001
    GRADY, David Anthony
    Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NR Birmingham
    20
    Administrateur
    Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NR Birmingham
    20
    EnglandBritishAccountant139324790001
    HENDERSON, Alan
    Bayhead
    IV8 8NP Munlochy
    Administrateur
    Bayhead
    IV8 8NP Munlochy
    BritishTransport Manager35579330001
    JOB, Gerald Fraser
    Wester Milton
    Moyness
    IV12 5LB Nairn
    Highland
    Administrateur
    Wester Milton
    Moyness
    IV12 5LB Nairn
    Highland
    United KingdomBritishEngineer12017200001
    MCALPINE, Euan James
    Lower Carden Hall
    SY14 7HW Malpas
    Cheshire
    Administrateur
    Lower Carden Hall
    SY14 7HW Malpas
    Cheshire
    United KingdomBritishBuisness Executive57585880001
    MURTAGH, Joseph
    4 Kirk Glebe
    Stewarton
    KA3 5BJ Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    4 Kirk Glebe
    Stewarton
    KA3 5BJ Kilmarnock
    Ayrshire
    BritishGeneral Manager679920001
    NOVOTNY, Charles
    Hawthorn Cottage
    Bradshaw Lane
    WN8 7NQ Parbold
    Lancashire
    Administrateur
    Hawthorn Cottage
    Bradshaw Lane
    WN8 7NQ Parbold
    Lancashire
    BritishDirector32993550001
    RANTON, Christopher Gordon
    4 Whites Meadow
    Ranton
    ST18 9JB Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    4 Whites Meadow
    Ranton
    ST18 9JB Stafford
    Staffordshire
    BritishAccountant127658770001
    ROSS, Timothy Stuart
    Old Passage House
    Passage Road Aust
    BS35 4BG Bristol
    Avon
    Administrateur
    Old Passage House
    Passage Road Aust
    BS35 4BG Bristol
    Avon
    EnglandBritishSolicitor33564830003
    ROTHWELL, Peter Beresford
    21 Wentworth Road
    Four Oaks
    B74 2SD Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    21 Wentworth Road
    Four Oaks
    B74 2SD Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector32506900001
    STEWART, Katherine M
    22 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RB Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    22 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RB Inverness
    Inverness Shire
    BritishAccountant565690001
    STIRK, James Richard
    Cambusnethan House
    Linnet Way
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    Administrateur
    Cambusnethan House
    Linnet Way
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    EnglandBritishSolicitor34328400002
    STIRK, James Richard
    Drovers Cottage
    53 Upper Cound Cound
    SY5 6AS Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Drovers Cottage
    53 Upper Cound Cound
    SY5 6AS Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishSolicitor34328400001
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Administrateur
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    ScotlandBritishChartered Accountant1321720003
    TULLOCH, Kenneth
    1 The Fairways
    Alton Burn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    Uk
    Administrateur
    1 The Fairways
    Alton Burn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    Uk
    BritishCompany Director27241440001
    LAFARGE TARMAC DIRECTORS (UK) LIMITED
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    Administrateur
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3221775
    148616660002
    TARMAC NOMINEES LIMITED
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    Administrateur
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement670096
    68229260001

    TARMAC SAND & GRAVEL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 10 févr. 1989
    Livré le 27 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Development Limited
    Transactions
    • 27 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 18 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 10 févr. 1989
    Livré le 16 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 18 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Letter of pledge
    Créé le 14 avr. 1975
    Livré le 22 avr. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All credit balances on any account held by the governor & company of the bank of scotland in name of a tulloch & sons (plant) LTD all and any sums due to a tulloch & sons (plant) LTD by any subsidiary company of the governor and company of the bank of scotland and in particular north west securities LTD. And the bank of scotland finance company LTD.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 avr. 1975Enregistrement d'une charge
    • 13 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Instrument of charge
    Créé le 01 nov. 1971
    Livré le 09 nov. 1971
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £19,500
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Highlands & Islands Development Board
    Transactions
    • 09 nov. 1971Enregistrement d'une charge
    • 18 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    TARMAC SAND & GRAVEL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 déc. 2015Commencement of winding up
    13 déc. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0