CASTLE STREET NOMINEES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CASTLE STREET NOMINEES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
Numéro de société | SC050721 |
Juridiction | Écosse |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CASTLE STREET NOMINEES LIMITED ?
Adresse du siège social | 10 George Street EH2 2PF Edinburgh Scotland |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CASTLE STREET NOMINEES LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CASTLE STREET NOMINEES LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 25 juin 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 09 juil. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 25 juin 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CASTLE STREET NOMINEES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de William Ruthven Gemmell en tant que directeur le 18 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Changement d'adresse du siège social de Quartermile One Lauriston Place Edinburgh EH3 9EN Scotland à 10 George Street Edinburgh EH2 2PF le 05 juil. 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2024 au 30 sept. 2024 | 1 pages | AA01 | ||||||
Cessation de la nomination de Jennifer Elizabeth Mathias en tant que directeur le 31 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023 | 2 pages | AA | ||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Jennifer Elizabeth Mathias le 17 oct. 2023 | 2 pages | CH01 | ||||||
Nomination de Ali Johnson en tant que secrétaire le 21 sept. 2023 | 2 pages | AP03 | ||||||
Nomination de Ms Jennifer Elizabeth Mathias en tant qu'administrateur le 21 sept. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||
Nomination de Mr Robert Paul Stockton en tant qu'administrateur le 21 sept. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Modification des détails de Murray Asset Management Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 févr. 2023 | 2 pages | PSC05 | ||||||
Changement d'adresse du siège social de 3 Glenfinlas Street Edinburgh EH3 6AQ à Quartermile One Lauriston Place Edinburgh EH3 9EN le 08 févr. 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||
Nomination de Details Removed Under Section 1095 en tant qu'administrateur le 31 janv. 2023 | 1 pages | AP01 | ||||||
| ||||||||
Cessation de la nomination de Hugh Patrick Younger en tant que directeur le 31 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||
Cessation de la nomination de Carole Hope en tant que directeur le 31 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||
Cessation de la nomination de John Kenneth Scott Moncrieff en tant que directeur le 31 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 2 pages | AA | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 2 pages | AA | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020 | 2 pages | AA | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019 | 2 pages | AA | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Qui sont les dirigeants de CASTLE STREET NOMINEES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHNSON, Ali | Secrétaire | George Street EH2 2PF Edinburgh 10 Scotland | 314203840001 | |||||||
LLOYD, Simon Thomas | Administrateur | Glenfinlas Street EH3 6AQ Edinburgh 3 United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Manager | 71586130002 | ||||
STOCKTON, Robert Paul | Administrateur | George Street EH2 2PF Edinburgh 10 Scotland | England | British | Director | 120520560001 | ||||
MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | Floor 125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh 5th United Kingdom | 133157900001 | |||||||
MURRAY BEITH MURRAY WS | Secrétaire | 39 Castle Street EH2 3BH Edinburgh Midlothian | 660870001 | |||||||
ADDIS, Neil Michael | Administrateur | 65 South Beechwood EH12 5YS Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Solicitor | 91852100001 | ||||
BELL, Jonathan Richard Miles | Administrateur | 29 Ladysmith Road EH9 3EU Edinburgh Midlothian | British | Solicitor | 71586100002 | |||||
BERRY, William | Administrateur | 11a Saxe Coburg Place EH3 5BR Edinburgh | British | Writer To The Signet | 46255350002 | |||||
BIGGAR, John Morrison Hay | Administrateur | 11 Cluny Gardens EH10 6BH Edinburgh Midlothian | British | Writer To The Signet | 9501220001 | |||||
BLACK, Charles Richard | Administrateur | 2a Abbotsford Park EH10 5DX Edinburgh | Scotland | British | Writer To The Signet | 7600470004 | ||||
BURNET, George Wardlaw | Administrateur | Rose Court Inveresk Village EH21 7TD Musselburgh Midlothian | British | Writer To The Signet | 46268800001 | |||||
BURNETT, Alexander Donald | Administrateur | Netherby Road EH5 3LX Edinburgh 46 | Scotland | British | Solicitor | 33393540001 | ||||
BURNS, George | Administrateur | 26 Little Road EH16 6SQ Edinburgh Midlothian | British | Director Of Finance | 44196850001 | |||||
CALDER, David William | Administrateur | 8 Cypress Glade Adambrae EH54 9JH Livingston West Lothian | Scotland | British | Solicitor | 91852220001 | ||||
FILLEUL, Richard Frederic | Administrateur | 12 Keith Place KY12 7SR Dunfermline Fife | British | Writer To The Signet | 201380002 | |||||
FINLAYSON, William Alexander | Administrateur | 6 Garscube Terrace EH12 6BQ Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | Writer To The Signet | 39300940001 | ||||
FLYNN, Austin | Administrateur | 15 Ross Gardens EH9 3BS Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | Solicitor | 87705150001 | ||||
FORD, Patrick John | Administrateur | 1 St Vincent Street EH3 6SW Edinburgh Midlothian | British | Writer To The Signet | 774340001 | |||||
FORD, Patrick John | Administrateur | 3 Comely Bank Row EH4 1DZ Edinburgh | British | Writer To The Signet | 2395340001 | |||||
GEMMELL, William Ruthven | Administrateur | Glenfinlas Street EH3 6AQ Edinburgh 3 United Kingdom | United Kingdom | British | Writer To The Signet | 37153310003 | ||||
GERVER, Alexander Nathaniel | Administrateur | 1 Orchardhead Loan EH16 6HW Edinburgh | British | Solicitor | 41137970002 | |||||
HARVEY-JAMIESON, Rodger Ridout | Administrateur | 19 Dean Terrace EH4 1NL Edinburgh | Scotland | British | Writer To The Signet | 34336790001 | ||||
HOGFORS-STEWART, Eva Elisabeth | Administrateur | 11 Russell Place EH5 3HQ Edinburgh Midlothian | Swedish | Writer To The Signet | 774350001 | |||||
HOPE, Carole | Administrateur | Glenfinlas Street EH3 6AQ Edinburgh 3 United Kingdom | Scotland | British | Writer To The Signet | 29441180002 | ||||
LOCKE, Margaret Luise Stirling | Administrateur | 22 Melville Terrace EH9 1LR Edinburgh Midlothian | British | Writer To The Signet | 774360001 | |||||
MATHIAS, Jennifer Elizabeth | Administrateur | Lauriston Place EH3 9EN Edinburgh Quartermile One Scotland | Wales | British | Director | 121078120005 | ||||
MORE, Francis Adam John | Administrateur | 12 Kingsburgh Road EH12 6DZ Edinburgh Midlothian | British | Writer To The Signet | 247000001 | |||||
POLLOCK, Nigel James | Administrateur | Newmains Dryburgh St Boswells TD6 0RQ Melrose Roxburghshire | Scotland | British | Writer To The Signet | 335320002 | ||||
ROBSON, Michael Gordon | Administrateur | The Old School House 2, Baird Road EH28 8RA Ratho Edinburgh | Scotland | British | Solicitor To The Supreme Court | 123980270001 | ||||
SCOTT, Graham William Richard | Administrateur | 102 Polwarth Gardens EH11 1LH Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | Solicitor | 116107210001 | ||||
SCOTT MONCRIEFF, John Kenneth | Administrateur | Glenfinlas Street EH3 6AQ Edinburgh 3 United Kingdom | Scotland | British | Writer To The Signet | 42638160001 | ||||
STEPHEN, Andrew Johnston | Administrateur | 7 St. Ronans Terrace EH10 5NG Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | Solicitor | 87241840001 | ||||
STEWART, Mark Edward | Administrateur | 2f1, 10 Forbes Road EH10 4ED Edinburgh Midlothian | British | Solicitor | 66954940001 | |||||
WYLIE, Roderick James | Administrateur | 15/5 Mid Steil Glenlockhart EH10 5XB Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Chief Executive | 86102670002 | ||||
YOUNGER, Charles Gerald Alexander, The Hon | Administrateur | Blinkbonny House EH41 4HF Haddington East Lothian | British | Senior Investment Manager | 1379450002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CASTLE STREET NOMINEES LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murray Asset Management Uk Limited | 06 avr. 2016 | Gresham Street EC2V 7QN London 30 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0