PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC050835 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Halliburton House Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché) | 12 pages | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Robert White en tant que directeur le 31 déc. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
État du capital au 17 sept. 2020
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Wael Mekkawy en tant qu'administrateur le 01 févr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Shaikh Usman en tant qu'administrateur le 28 févr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Kuzhuvommannil Mathew en tant que directeur le 28 févr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Scot Clifton le 02 avr. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 14 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Betts en tant que directeur le 08 déc. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Martin Robert White en tant qu'administrateur le 08 déc. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIFTON, Scot | Secrétaire | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House | British | 139856420001 | ||||||
| CLIFTON, Scot | Administrateur | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House | Scotland | British | 139856420001 | |||||
| MEKKAWY, Wael | Administrateur | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House | Scotland | Egyptian | 264116610002 | |||||
| USMAN, Shaikh | Administrateur | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House | United Kingdom | Indian | 269146770001 | |||||
| BROWN, Graham Christopher | Secrétaire | Flat 4 82 Belsize Park Gardens Hampstead NW3 4NG London | British | 106493880001 | ||||||
| CRAWLEY, Peter John | Secrétaire | Deveron Facility Howe Moss Place, Dyce AB21 0GS Aberdeen | British | 91521200006 | ||||||
| DAVIS, Richard Paul | Secrétaire | Ambersham House Estuary Crescent Shotley Gate IP9 2QA Ipswich Suffolk | British | 9506230001 | ||||||
| DEERING, John Edward | Secrétaire | Blenheim Place AB25 2DL Aberdeen 129 Aberdeenshire | British | 131261430001 | ||||||
| FARLEY, Andrew Daniel | Secrétaire | Flat 1 22 Harcourt Terrace SW10 9JR London | British | 75086910001 | ||||||
| FLINDERS, Harold Derek | Secrétaire | 23 Thetford Road KT3 5DN New Malden Surrey | British | 65317780001 | ||||||
| GARRETT, Anthony John | Secrétaire | 8 Grasmere Close GU1 2TG Guildford Surrey | British | 220420001 | ||||||
| GLYNN, Andrew David | Secrétaire | 44 Holburn Road AB10 6ET Aberdeen | British | 54450910002 | ||||||
| LINDSELL, Philip Edmund | Secrétaire | Southside Cottage Stone Lane Axford SN8 2EY Marlborough Wiltshire | British | 101775640001 | ||||||
| ORR, Raymond William | Secrétaire | 19 Lawson Avenue AB31 3TW Banchory Kincardineshire | British | 1179560001 | ||||||
| TOCHER, Judith Robertson | Secrétaire | Blacktop House, Blacktop Kingswells AB15 8QJ Aberdeen | British | 82086030001 | ||||||
| WILLIAMS, Michael James John | Secrétaire | West Steading Mains Of Inverey AB3113NY Banchory Kincardineshire | British | 54494520001 | ||||||
| BETTS, Matthew | Administrateur | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House | United Kingdom | British | 119391640001 | |||||
| BOWYER, Michael Lewis | Administrateur | Deveron Facility Howe Moss Place, Dyce AB21 0GS Aberdeen | British | 43449270009 | ||||||
| BUCHANAN, Alasdair Ian | Administrateur | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House Scotland | Scotland | British | 162046510001 | |||||
| CHAPMAN, Gordon Robin | Administrateur | Pen Y Bryn Upper Raby Road CH64 7TY Neston Cheshire | England | British | 29030650001 | |||||
| CRAVEN WALKER, Antony | Administrateur | Square Du Val De La Cambre 3 1050 Bruxelles Belgium | British | 70900640001 | ||||||
| DENMAN, Henry Wynne | Administrateur | The Penthouse Old Avenue St Georges Hill KT13 0QB Weybridge Surrey | British | 771670001 | ||||||
| FITZGERALD, Mel Oliver | Administrateur | 3 Marlyns Drive Burpham GU4 7LS Guildford Surrey | United Kingdom/England | Irish | 69993790001 | |||||
| FORD, Gregory Brent | Administrateur | 7 Prospect Hill Road Bielside AB15 9AN Aberdeen | Usa | 54533770001 | ||||||
| HEATH, Stuart Matthew | Administrateur | Beside Novotel Hotel Trade Centre PO BOX 3111 Dubai 8th Floor Convention Tower United Arab Emirates | United Arab Emirates | British | 173991180001 | |||||
| HERD, Ian Riddoch Williamson | Administrateur | 49 Abbotswell Drive AB12 5QP Aberdeen | British | 77264220001 | ||||||
| HOUSTON, John Joseph | Administrateur | Deveron Facility Howe Moss Place, Dyce AB21 0GS Aberdeen | British | 81041240005 | ||||||
| JAMES, David Noel | Administrateur | Suite 531 Premier House 10 Greycoat Place SW1P 1SB London | British | 41668080002 | ||||||
| JOHNSTON, David Alexander | Administrateur | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House | United Kingdom | British | 125502250001 | |||||
| KALBORG, Ted Gunnar Christer | Administrateur | 22 Pelham Crescent SW7 2NR London | England | Swedish | 8637550001 | |||||
| LINDSELL, Philip Edmund | Administrateur | Southside Cottage Stone Lane Axford SN8 2EY Marlborough Wiltshire | British | 101775640001 | ||||||
| MAHON, Barry Anthony | Administrateur | 133 North Deeside Road Milltimber AB13 0JS Aberdeen | Irish | 91976230001 | ||||||
| MAIR, John Arthur | Administrateur | 9a Ferryhill Place AB11 7SE Aberdeen | United Kingdom | British | 54533170001 | |||||
| MATHEW, Thomas Kuzhuvommannil | Administrateur | Citibank Tower Al-Qutayat Street Dubai 14th Floor United Arab Emirates | United Arab Emirates | Indian | 186849530001 | |||||
| METSON, Peter Alexander | Administrateur | Mayfield Malcolm Road Peterculter AB1 0NX Aberdeen Grampian | Usa | 37748950002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halliburton Holdings (No 3) | 07 juin 2016 | Howe Moss Crescent AB21 0GN Dyce Halliburton House Aberdeen United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Agreement (fixed charge) | Créé le 15 déc. 1987 Livré le 30 déc. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All r f p shares and all f p loan notes and all fourth shares to which the company is entitled. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Agreement floating charge | Créé le 15 déc. 1987 Livré le 30 déc. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All r f p shares and all f p loan rates and all the fourth shares to which the company is entitled. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 25 août 1986 Livré le 05 sept. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0