LONDON AND CLYDESIDE HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | LONDON AND CLYDESIDE HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC051288 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LONDON AND CLYDESIDE HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Unit C, Ground Floor, Cirrus Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Paisley |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LONDON AND CLYDESIDE HOLDINGS LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour LONDON AND CLYDESIDE HOLDINGS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 03 avr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 17 avr. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 03 avr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour LONDON AND CLYDESIDE HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Nomination de Sara Hollowell en tant qu'administrateur le 01 oct. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Jennifer Canty en tant que directeur le 30 sept. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2024 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Michael Andrew Lonnon en tant que secrétaire le 09 déc. 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mr Sayed Suleiman Ashrafi en tant que secrétaire le 09 déc. 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Nomination de Jennifer Canty en tant qu'administrateur le 24 avr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que directeur le 24 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 5 pages | AA | ||
Nomination de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant qu'administrateur le 09 oct. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant que directeur le 09 oct. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Alice Hannah Black en tant que directeur le 26 août 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant qu'administrateur le 26 août 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 5 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Alice Hannah Marsden le 30 mai 2021 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de James John Jordan en tant que directeur le 31 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Miss Alice Hannah Marsden en tant qu'administrateur le 31 déc. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de LONDON AND CLYDESIDE HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHRAFI, Sayed Suleiman | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 330352230001 | |||||||
| CONNOR, Ian Graham | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 193626080001 | |||||
| HOLLOWELL, Sara | Administrateur | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | United Kingdom | British | 200486170001 | |||||
| CARR, Peter Anthony | Secrétaire | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||
| DE FEO, Caterina | Secrétaire | 42 The Crescent Hampton In Arden B92 0BP Solihull West Midlands | British | 58246930001 | ||||||
| HASTINGS, Jonathan Philip | Secrétaire | 7 Hanger Court Hanger Green W5 3ER London | British | 4733610001 | ||||||
| JORDAN, James John | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
| LAWTHER, Samuel David | Secrétaire | Riverview House Church Green Woodford NN14 4EU Kettering Northamptonshire | British | 41835460010 | ||||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | British | 34521340004 | ||||||
| NUNN, Carol Jayne | Secrétaire | 4 Juniper Close NN12 6XP Towcester Northamptonshire | British | 116824870001 | ||||||
| WISEMAN, William | Secrétaire | 58 Broompark Drive Newton Mearns G77 5EH Glasgow Lanarkshire | British | 422620001 | ||||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Administrateur | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | United Kingdom | British | 193735640001 | |||||
| ANDREW, Peter Robert | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 113503830003 | |||||
| BLACK, Alice Hannah | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 264031110002 | |||||
| BLACK, Ian Craig | Administrateur | 7 The Courtyard Ecton Hall NN6 0QE Ecton Northamptonshire | British | 4579780003 | ||||||
| CANTY, Jennifer | Administrateur | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | United Kingdom | British | 322288120001 | |||||
| CARNEY, Christopher | Administrateur | KT10 | United Kingdom | British | 125216670001 | |||||
| CHALMERS, Norman Ashley | Administrateur | Brook House Templewood Lane SL2 3HW Farnham Common Buckinghamshire | United Kingdom | British | 35542160001 | |||||
| CHANDRAN, Vikranth | Administrateur | Carlton Avenue East Wembley HA9 8QB London 227 United Kingdom | United Kingdom | British | 139652640001 | |||||
| GREEN, Robert David | Administrateur | 11 Whitworth Lane Loughton MK5 8EB Milton Keynes | England | British | 76720550003 | |||||
| GRIEVE, Alexander Raeburn | Administrateur | Carlhurlie KY8 5QE Lundin Links Fife | Scotland | Scottish | 409950001 | |||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 257671040002 | |||||
| JOHNSON, Peter Thomas | Administrateur | 34 Homewood Road AL1 4BQ St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 8895880004 | |||||
| JORDAN, James John | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 120602100002 | |||||
| KELLY, Patrick Joseph | Administrateur | 2 Crosslees Road Thornliebank G46 7EW Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 71731770001 | |||||
| LAWTHER, Samuel David | Administrateur | Stow Cottage Spaldwick Road, Stow Longa PE18 0TL Huntingdon Cambridgeshire | British | 41835460012 | ||||||
| MCCALLUM, Graeme Reid | Administrateur | The Poplars Whinfield Road Dodford B61 9BG Bromsgrove Worcestershire | United Kingdom | British | 152856250001 | |||||
| MCINTYRE, John | Administrateur | The White House Of Milliken PA5 8 Brookfield | Scotland | British | 422630001 | |||||
| MILLAR, Gordon | Administrateur | Rowan Dale Torwood FK5 4SN Larbert Stirlingshire | Uk | British | 44194920001 | |||||
| MITCHELL, Brian | Administrateur | 92 Belton Grove NG31 9HH Grantham Lincolnshire | British | 51993630001 | ||||||
| MURRIN, Jonathan Charles | Administrateur | 10 Silhill Hall Road B91 1JU Solihull West Midlands | British | 115863170001 | ||||||
| PEACOCK, Raymond Anthony | Administrateur | 9 Grosvenor Road Finchley N3 1EY London | United Kingdom | British | 75750250002 | |||||
| RUDGE, Alan James | Administrateur | Packwood Manor Road Grendon NN7 1JF Northampton Northamptonshire | British | 9647250001 | ||||||
| STEVENSON, Peter David | Administrateur | The White House 147 Whitehouse Lane EH9 2EY Edinburgh | Scotland | British | 1251400001 | |||||
| SWANSON, John George | Administrateur | 14 Crosslees Road Thornliebank G46 7EW Glasgow Lanarkshire | British | 409920001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LONDON AND CLYDESIDE HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Connolly Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0