RI DORMANT NO.12 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRI DORMANT NO.12 LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC051362
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RI DORMANT NO.12 LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe RI DORMANT NO.12 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Scotland
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RI DORMANT NO.12 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RENTOKIL UYJ LIMITED11 oct. 200611 oct. 2006
    RENTOKIL AILSA ENVIRONMENTAL LIMITED01 oct. 199701 oct. 1997
    AILSA INDUSTRIAL & ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED08 janv. 199608 janv. 1996
    AILSA INDUSTRIAL SERVICES LIMITED07 sept. 197207 sept. 1972

    Quels sont les derniers comptes de RI DORMANT NO.12 LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour RI DORMANT NO.12 LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au11 sept. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation25 sept. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au11 sept. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour RI DORMANT NO.12 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 11 sept. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Michael Ellis en tant qu'administrateur le 31 août 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jeffreys Kristen Hampson en tant que directeur le 31 août 2024

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023

    6 pagesAA

    Nomination de Mr James Robert Anthony Gordon en tant qu'administrateur le 01 avr. 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr James Robert Anthony Gordon en tant que secrétaire le 01 avr. 2024

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Catherine Stead en tant que secrétaire le 31 mars 2024

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Catherine Jane Stead en tant que directeur le 31 mars 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 11 sept. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Daragh Patrick Feltrim Fagan en tant que directeur le 30 mars 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Jeffreys Kristen Hampson en tant qu'administrateur le 30 mars 2022

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 30 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    4 pagesAA

    Modification des détails de Rentokil Initial (1993) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 avr. 2021

    2 pagesPSC05

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Daragh Patrick Feltrim Fagan le 05 janv. 2021

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Catherine Stead le 05 janv. 2021

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Catherine Jane Stead le 05 janv. 2021

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 30 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 déc. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de RI DORMANT NO.12 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GORDON, James Robert Anthony
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    Scotland
    Secrétaire
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    Scotland
    321552330001
    ELLIS, Michael
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant326346850001
    GORDON, James Robert Anthony
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritishCompany Secretary321552190001
    BROWN, Gareth Trevor
    19 Holbrook School Lane
    RH12 5PP Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    19 Holbrook School Lane
    RH12 5PP Horsham
    West Sussex
    British15885460002
    BULL, Michael John
    53 Crosslands
    Caddington
    LU1 4EP Luton
    Bedfordshire
    Secrétaire
    53 Crosslands
    Caddington
    LU1 4EP Luton
    Bedfordshire
    British397910001
    COOPER, Elizabeth Jayne Clare
    39 Church Road
    LU5 6LE Harlington
    Bedfordshire
    Secrétaire
    39 Church Road
    LU5 6LE Harlington
    Bedfordshire
    British3540250005
    GRIFFITHS, Paul
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2
    West Sussex
    England
    Secrétaire
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2
    West Sussex
    England
    British11329830003
    MCDONALD, Eric
    33 Locher Avenue Locher Park Avenue
    PA6 7NR Houston
    Scotland
    Secrétaire
    33 Locher Avenue Locher Park Avenue
    PA6 7NR Houston
    Scotland
    British985230001
    SILCOCK, Siobhan Denise
    2 Peter Coats 31 Calside
    PA2 6DB Paisley
    Renfrewshire
    Secrétaire
    2 Peter Coats 31 Calside
    PA2 6DB Paisley
    Renfrewshire
    British38430670002
    STEAD, Catherine
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    Scotland
    Secrétaire
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    Scotland
    228871460001
    PLANT NOMINEES LIMITED
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Secrétaire
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1045604
    165425900001
    ALDRIDGE, Mark Ewart
    Rustlings Park
    Woodlands Lane
    GU33 7EZ Liss
    Hampshire
    Administrateur
    Rustlings Park
    Woodlands Lane
    GU33 7EZ Liss
    Hampshire
    EnglandBritishDirector66832950001
    ALLAN, John Murray
    4 Brock Way
    GU25 4SD Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    4 Brock Way
    GU25 4SD Virginia Water
    Surrey
    BritishCompany Director64484180001
    BOYLE, Bryan
    35 Alexander Gibson Way
    ML1 3FA Motherwell
    North Lanarkshire
    Administrateur
    35 Alexander Gibson Way
    ML1 3FA Motherwell
    North Lanarkshire
    ScotlandBritishFinance Director69816420001
    BROWN, Gareth Trevor
    19 Holbrook School Lane
    RH12 5PP Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    19 Holbrook School Lane
    RH12 5PP Horsham
    West Sussex
    UkBritishSolicitor15885460002
    COOPER, Elizabeth Jayne Clare
    39 Church Road
    LU5 6LE Harlington
    Bedfordshire
    Administrateur
    39 Church Road
    LU5 6LE Harlington
    Bedfordshire
    BritishCo Secretary3540250005
    COWELL, Richard John
    5 Coppins Close
    HP4 3NZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Coppins Close
    HP4 3NZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishCompany Director50745830001
    DOROSZCZUK, Paul Michael
    29 Wallace Road
    EH48 1DN Bathgate
    West Lothian
    Administrateur
    29 Wallace Road
    EH48 1DN Bathgate
    West Lothian
    BritishManaging Director64774620001
    FAGAN, Daragh Patrick Feltrim
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    Scotland
    EnglandBritishSolicitor189709530001
    FAGAN, Daragh Patrick Feltrim
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Administrateur
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    EnglandBritishSolicitor189709530001
    FINDLATER, John
    40 Woodland Rise
    LU6 2PF Studham
    Beds
    Administrateur
    40 Woodland Rise
    LU6 2PF Studham
    Beds
    BritishCompany Director397930001
    FRETWELL, Stephen James
    1 Trafalgar Gate
    Brighton Marina Village
    BN2 5UY Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    1 Trafalgar Gate
    Brighton Marina Village
    BN2 5UY Brighton
    East Sussex
    BritishCompany Director27937700003
    GODFREY, Mark John
    The Chalet
    Harwich Road Great Oakley
    CO12 5AD Harwich
    Essex
    Administrateur
    The Chalet
    Harwich Road Great Oakley
    CO12 5AD Harwich
    Essex
    EnglandEnglishAccountant70217860003
    GRAY, Ronald
    64 Crookston Road
    G52 3QQ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    64 Crookston Road
    G52 3QQ Glasgow
    Lanarkshire
    BritishChartered Management Accountan17568920001
    GRIFFITHS, Paul
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2
    West Sussex
    England
    Administrateur
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2
    West Sussex
    England
    EnglandBritishChartered Secretary11329830003
    HAMPSON, Jeffreys Kristen
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritishFinance Director178768280001
    HARRISON, George Eric
    35 Horton Road
    Slapton
    LU7 9DB Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    35 Horton Road
    Slapton
    LU7 9DB Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishCompany Director397920001
    LAAN, Alexandra Jane
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Administrateur
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    United KingdomBritishCorporate Secretary89963780002
    MCNAIR, Andrew Malcolm
    Tamarind House
    Cleghorn
    ML11 8NZ Lanark
    Lanarkshire
    Administrateur
    Tamarind House
    Cleghorn
    ML11 8NZ Lanark
    Lanarkshire
    United KingdomBritishCompany Director68954380002
    PITCAIRN, James
    19 Riverside Road
    Eaglesham
    G76 0DQ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    19 Riverside Road
    Eaglesham
    G76 0DQ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishDirector35580000001
    PRENTICE, Anthony Frank
    The Thatched Cottage
    Ball Hill
    RG20 0PD Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    The Thatched Cottage
    Ball Hill
    RG20 0PD Newbury
    Berkshire
    BritishFinance Director65443130002
    ROBSON, William Roxby
    Clovelly New Road
    Chipperfield
    WD4 9LL Kings Langley
    Hertfordshire
    Administrateur
    Clovelly New Road
    Chipperfield
    WD4 9LL Kings Langley
    Hertfordshire
    BritishCompany Director42004690001
    ROSS JONES, Allan, Dr
    5 Denmans Close
    RH16 2JX Lindfield
    West Sussex
    Administrateur
    5 Denmans Close
    RH16 2JX Lindfield
    West Sussex
    BritishDivisional Managing Director562030002
    SILCOCK, Siobhan Denise
    2 Peter Coats 31 Calside
    PA2 6DB Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    2 Peter Coats 31 Calside
    PA2 6DB Paisley
    Renfrewshire
    BritishChartered Accountant38430670002
    SMITH, Jonathan Mark
    25 Church Hill
    CR8 3QP Purley
    Surrey
    Administrateur
    25 Church Hill
    CR8 3QP Purley
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director45278090002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RI DORMANT NO.12 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement2864290
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0