APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC052644 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o WRIGHT, JOHNSTON & MACKENZIE LLP 302 St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 14 août 2020
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Bishop en tant que directeur le 01 janv. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David John Muir en tant qu'administrateur le 01 janv. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
legacy | 44 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
legacy | 51 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 4 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 4 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINCH, Mark | Secrétaire | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 175639530001 | |||||||
| FINCH, Mark Charles | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 175612870001 | |||||
| MUIR, David John | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | 254017640001 | |||||
| MACNAMARA, Richard James | Secrétaire | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 149299350001 | |||||||
| MAHAFFEY, Matthew Ian | Secrétaire | 23 St Oswalds Road Fulford YO1 4PF York North Yorkshire | British | 507940001 | ||||||
| WARD, Andrew Ian | Secrétaire | 6 Coniston Way LS22 6TT Wetherby West Yorkshire | British | 360770001 | ||||||
| WATSON, Deirdre Mary Alison | Secrétaire | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | Uk | 74385360001 | ||||||
| MATHESON & CO LIMITED | Secrétaire | 3 Lombard Street EC3V 9AQ London | 1947590001 | |||||||
| ATKIN, John Richard | Administrateur | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | 20102900001 | ||||||
| BEATTIE, Craig Alan | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 177627900001 | |||||
| BEYNON, Peter | Administrateur | Stonehurst Elm Lane Copdock IP8 3ET Ipswich Suffolk | England | British | 38504390006 | |||||
| BISHOP, Matthew | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 206755450002 | |||||
| CHAMBERS, Paul Jonathan | Administrateur | 24 Constable Road Ben Rhydding LS29 8RW Ilkley West Yorkshire | British | 1188140001 | ||||||
| HERBERT, Mark Philip | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | 123285980005 | |||||
| HOUSTON, Samuel George | Administrateur | Flat 59 Medland House 11 Branch Road E14 7JT London | British | 75730290003 | ||||||
| JONES, Alun Morton | Administrateur | Fen Walk IP12 4BG Woodbridge Fen House Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 12785600004 | |||||
| MACNAMARA, Richard James | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 149294820002 | |||||
| POTTS, Derek | Administrateur | 55 East Street Coggeshall CO6 1SJ Colchester Essex | United Kingdom | British | 52485510001 | |||||
| RITCHIE, John Muir | Administrateur | High House Snipe Farm Road IP13 6SL Clopton Suffolk | British | 22325820001 | ||||||
| STUART, John Morris | Administrateur | Cromdale 26 Foxglove Avenue LS8 2QR Leeds West Yorkshire | British | 507950001 | ||||||
| WATSON, Deirdre Mary Alison | Administrateur | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | England | Uk | 74385360001 | |||||
| WILLIAMS, Steven Wyn | Administrateur | 199 Finchampstead Road RG40 3HE Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 54580940001 | |||||
| WILLIAMSON, Michael Granville | Administrateur | Church Green Old Church Lane Pateley Bridge HG3 5LZ Harrogate North Yorkshire | British | 57360160001 | ||||||
| WITT, John Raymond | Administrateur | 28 Westerfield Road IP4 2YJ Ipswich Suffolk | Canadian | 51303670001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appleyard Group Limited | 06 avr. 2016 | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Créé le 26 janv. 1983 Livré le 31 janv. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due, or to become due by appleyard group PLC | |
Brèves mentions 1) 50.08 poles & 89.52 poles, troon ayr. 2) 3.30 acres, 0.58 acres and 0.11 acres at western road, kilmarnock, ayr. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 25 nov. 1982 Livré le 10 déc. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Standard security | Créé le 20 sept. 1982 Livré le 29 sept. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions (I) 50.08 poles and (ii) 89.52 poles, both in the burgh of troon, parish of dundonald and county of ayr (I) 3.30 acres, (ii) 0.58 acres and (iii) 0.11 acres, all at western road, kilmarnock, ayrshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 20 juil. 1981 Livré le 24 juil. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 1.13 acres, 38784 square feet and 0.031 of an acre all in renfrew and 18 holmston road, ayr, ayrshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 07 oct. 1980 Livré le 22 oct. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti Nil, an ad fachim praestandium obligation | |
Brèves mentions Westhill, prieston road bridge of weir. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 24 sept. 1980 Livré le 07 oct. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0