APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED

APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAPPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC052644
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o WRIGHT, JOHNSTON & MACKENZIE LLP
    302 St. Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 14 août 2020

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    legacy

    49 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT1

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Matthew Bishop en tant que directeur le 01 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David John Muir en tant qu'administrateur le 01 janv. 2019

    2 pagesAP01

    legacy

    44 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT1

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    legacy

    49 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT1

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    legacy

    51 pagesPARENT_ACC

    legacy

    4 pagesAGREEMENT1

    legacy

    4 pagesGUARANTEE1

    Qui sont les dirigeants de APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FINCH, Mark
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    175639530001
    FINCH, Mark Charles
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish175612870001
    MUIR, David John
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish254017640001
    MACNAMARA, Richard James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    149299350001
    MAHAFFEY, Matthew Ian
    23 St Oswalds Road
    Fulford
    YO1 4PF York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    23 St Oswalds Road
    Fulford
    YO1 4PF York
    North Yorkshire
    British507940001
    WARD, Andrew Ian
    6 Coniston Way
    LS22 6TT Wetherby
    West Yorkshire
    Secrétaire
    6 Coniston Way
    LS22 6TT Wetherby
    West Yorkshire
    British360770001
    WATSON, Deirdre Mary Alison
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Uk74385360001
    MATHESON & CO LIMITED
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Secrétaire
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    1947590001
    ATKIN, John Richard
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    British20102900001
    BEATTIE, Craig Alan
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish177627900001
    BEYNON, Peter
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish38504390006
    BISHOP, Matthew
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish206755450002
    CHAMBERS, Paul Jonathan
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    British1188140001
    HERBERT, Mark Philip
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish123285980005
    HOUSTON, Samuel George
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    Administrateur
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    British75730290003
    JONES, Alun Morton
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Fen House
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Fen House
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish12785600004
    MACNAMARA, Richard James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish149294820002
    POTTS, Derek
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    Administrateur
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish52485510001
    RITCHIE, John Muir
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    Administrateur
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    British22325820001
    STUART, John Morris
    Cromdale 26 Foxglove Avenue
    LS8 2QR Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Cromdale 26 Foxglove Avenue
    LS8 2QR Leeds
    West Yorkshire
    British507950001
    WATSON, Deirdre Mary Alison
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Administrateur
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    EnglandUk74385360001
    WILLIAMS, Steven Wyn
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish54580940001
    WILLIAMSON, Michael Granville
    Church Green
    Old Church Lane Pateley Bridge
    HG3 5LZ Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Church Green
    Old Church Lane Pateley Bridge
    HG3 5LZ Harrogate
    North Yorkshire
    British57360160001
    WITT, John Raymond
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    Canadian51303670001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement192238
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 26 janv. 1983
    Livré le 31 janv. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by appleyard group PLC
    Brèves mentions
    1) 50.08 poles & 89.52 poles, troon ayr. 2) 3.30 acres, 0.58 acres and 0.11 acres at western road, kilmarnock, ayr.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 janv. 1983Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 25 nov. 1982
    Livré le 10 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 déc. 1982Enregistrement d'une charge
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Standard security
    Créé le 20 sept. 1982
    Livré le 29 sept. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    (I) 50.08 poles and (ii) 89.52 poles, both in the burgh of troon, parish of dundonald and county of ayr (I) 3.30 acres, (ii) 0.58 acres and (iii) 0.11 acres, all at western road, kilmarnock, ayrshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 sept. 1982Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 20 juil. 1981
    Livré le 24 juil. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.13 acres, 38784 square feet and 0.031 of an acre all in renfrew and 18 holmston road, ayr, ayrshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 juil. 1981Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 07 oct. 1980
    Livré le 22 oct. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Nil, an ad fachim praestandium obligation
    Brèves mentions
    Westhill, prieston road bridge of weir.
    Personnes ayant droit
    • David Mclintock
    Transactions
    • 22 oct. 1980Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 24 sept. 1980
    Livré le 07 oct. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 oct. 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0