ARROWSPEED INVESTMENTS LIMITED

ARROWSPEED INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéARROWSPEED INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC053067
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ARROWSPEED INVESTMENTS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe ARROWSPEED INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    216 East Main Street
    Broxburn
    EH52 5AS West Lothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ARROWSPEED INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ARROWSPEED INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 juin 2012

    État du capital au 25 juin 2012

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2011 au 31 mars 2012

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Kazushi Ogura en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Kenji Murai en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ian Fraser en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Healy en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Healy en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Nomination de Ian Vincent Ellis en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Michael Joseph Anthony Healy le 16 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Ellis Fraser le 16 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Joseph Anthony Healy le 16 oct. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Qui sont les dirigeants de ARROWSPEED INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ELLIS, Ian Vincent
    216 East Main Street
    Broxburn
    EH52 5AS West Lothian
    Secrétaire
    216 East Main Street
    Broxburn
    EH52 5AS West Lothian
    British162126240001
    MURAI, Kenji
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapanese95702340002
    OGURA, Kazushi
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapanese150485750001
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Secrétaire
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    British99111340001
    HUTHERSALL, Robert
    17 Corstorphine Road
    EH12 6DD Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Secrétaire
    17 Corstorphine Road
    EH12 6DD Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British3204110001
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Secrétaire
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    MORRISON, Scott
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    British99297890001
    BISSETT, Graeme
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    Administrateur
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    British79800380001
    FARMER, Thomas, Sir
    192 Queensferry Road
    EH4 6JL Edinburgh
    Maidencraig House
    Midlothian
    Administrateur
    192 Queensferry Road
    EH4 6JL Edinburgh
    Maidencraig House
    Midlothian
    ScotlandBritish94804240004
    FRASER, Ian Ellis
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Administrateur
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    ScotlandUk28393850006
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Administrateur
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritish99111340001
    HOUSTON, John Mclellan
    The Rock
    3 Douglas Avenue
    PA14 6PE Langbank
    Administrateur
    The Rock
    3 Douglas Avenue
    PA14 6PE Langbank
    British712840002
    HUTHERSALL, Robert
    56 Pentland Drive
    EH10 6PX Edinburgh
    Administrateur
    56 Pentland Drive
    EH10 6PX Edinburgh
    British3204110005
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Administrateur
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Administrateur
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    OWENS, Stanley Hart
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    Administrateur
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    American75755850002
    PARKER, Timothy Charles
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Administrateur
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritish126476060001

    ARROWSPEED INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 29 janv. 1982
    Livré le 09 févr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by crest international securities PLC
    Brèves mentions
    56 oxford street and 90 great bridgewater street, manchester.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 févr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Leasehold land situate in marsh barton road, exeter registered at h m land registry under title number dn 48536.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Leasehold land and property situate and known as 205/211 leeds road huddersfield registered at h m land registry under title number yk 16360.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land in whittington road, oswestry.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land on property situate and known as 1/12 rockville terrace, mill street, kidderminster.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land situate in bolton road, pendlebury manchester registered at h m land registry under title number la 287123.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land and property situate and known as 179/187 marsh lane, preston, lancashire registered at h m land registry under title number la 336765.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land and property situate and known as 2/4 scholey street and 113/115 manchester road bolton registered at h m land registry under title number la 274036.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land and property situate and known as olympic garage 187/189 lower oxford street, swansea.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land and premises situate and known as 93/99 litchfield street, hanley, staffordshire registered at h m land registry under title number SF70957.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land and premises situate and known as 2/6 city road, derby registered at h m land registry under title number dy 19722.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land and property situate and known as 233/237 church road, tranmere, birkenhead registered at h m land registry under title number CH80082.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land and property situate and known as 219 swan lane, coventry registered at h m land registry under title number WM9616.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land situate in wednesfield road, wolverhampton registered at h m land registry under title number wm 107116.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land situated wellington road, stockport registered at h m land registry under title number ch 79044.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land and property known as 319 north road, darlington registered at h m land registry under title number du 25434.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 15 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land and property situate and known as 140/144 ashley donn road, bristol registered at h m land registry under title number bl. 22406.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0