RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRUBY DCO TWENTY TWO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC053733
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KYLE AND CARRICK HOLDINGS LIMITED01 août 197301 août 1973

    Quels sont les derniers comptes de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Modification des détails de Ruby Dco Twenty One Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 sept. 2023

    2 pagesPSC05

    Modification des détails de Ayrshire Pharmaceuticals Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept. 2023

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de 204 Polmadie Road Hampden Park Industrial Estate Glasgow G42 0PH Scotland à Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street Glasgow G2 1BP le 18 sept. 2023

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Graham Wiseman en tant que directeur le 31 août 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Thorsten Sprank en tant qu'administrateur le 31 août 2023

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Sole director appointment 31/08/2023
    RES13

    Certificat de changement de nom

    Company name changed kyle and carrick holdings LIMITED\certificate issued on 04/09/23
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name04 sept. 2023

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    État du capital au 15 août 2023

    • Capital: GBP 0.01
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 27 janv. 2023 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Wendy Margaret Hall en tant que directeur le 09 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nichola Louise Legg en tant que secrétaire le 09 sept. 2022

    1 pagesTM02

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Détails de la variation des droits attachés aux actions

    2 pagesSH10

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Statuts

    33 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Removal of restriction on authorised share capital/ ratification of directors actions 07/09/2022
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Nomination de Graham Wiseman en tant qu'administrateur le 07 sept. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Christian Keen en tant que directeur le 18 mai 2022

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SPRANK, Thorsten
    Crays Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Administrateur
    Crays Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandGerman203900280002
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secrétaire
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Secrétaire
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    British20341960001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Secrétaire
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    GILMOUR, David Strachan
    5 Laigh Mount
    KA7 4QS Ayr
    South Ayrshire
    Scotland
    Secrétaire
    5 Laigh Mount
    KA7 4QS Ayr
    South Ayrshire
    Scotland
    British52130850001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Secrétaire
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    LEGG, Nichola Louise
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secrétaire
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    163214890001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Secrétaire
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    RAINEY, Gary
    95 Greenacres
    KA22 7PR Ardrossan
    Ayrshire
    Secrétaire
    95 Greenacres
    KA22 7PR Ardrossan
    Ayrshire
    British3535890001
    SADLER, John Michael
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    Secrétaire
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    British44018260001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Secrétaire
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    BEER, Thorsten
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    United KingdomGerman172030260001
    COCKBURN, Henry James Kemp
    16 Dalzell Avenue
    ML1 2BX Motherwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    16 Dalzell Avenue
    ML1 2BX Motherwell
    Lanarkshire
    British504660001
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish118296490001
    GILBERT, George Andrew
    Tredawn White Plains
    KA7 4 Ayr
    Administrateur
    Tredawn White Plains
    KA7 4 Ayr
    British469190001
    HALL, Wendy Margaret
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish172979860001
    HILGER, Marcus
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    GermanyGerman238936580003
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Administrateur
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    British39644740002
    JOHNSTONE, Ian
    47 Adele Street
    ML1 2QE Motherwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    47 Adele Street
    ML1 2QE Motherwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish58656120002
    KEEN, Christian
    Hampden Park Industrial Estate
    G42 0PH Glasgow
    204 Polmadie Road
    Scotland
    Administrateur
    Hampden Park Industrial Estate
    G42 0PH Glasgow
    204 Polmadie Road
    Scotland
    EnglandBritish54544790004
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Administrateur
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritish8991780003
    LIPP, Hanns Martin
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    United KingdomGerman220582440001
    LLOYD, Allen John
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    Administrateur
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    British2270630001
    LLOYD, Peter Edward
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    British35546210001
    MCCONNELL, Walter Scott
    Braehead Of Priestgill
    ML10 6PS Strathaven
    Administrateur
    Braehead Of Priestgill
    ML10 6PS Strathaven
    British469160001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Administrateur
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Germany62107000001
    PRINGLE, John Stock
    Upper Carbarns Farm
    Netherton
    ML2 0RW Wishaw
    Administrateur
    Upper Carbarns Farm
    Netherton
    ML2 0RW Wishaw
    British355710003
    RILLIE, George Davidson
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    British88210002
    RILLIE, George Davidson
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    British88210002
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    STEELE, Richard John
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    Administrateur
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    EnglandBritish1415570001
    TAYLOR, Andrew James
    7 Milton Gardens
    Calderbraes
    G71 6EB Uddingston
    Administrateur
    7 Milton Gardens
    Calderbraes
    G71 6EB Uddingston
    British29348070001
    TURNER, Richard Gill
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    Administrateur
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    British51796560002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48
    Scotland
    06 avr. 2016
    West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 1985
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc040149
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 04 mai 1990
    Livré le 14 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Long lease of shop 178 main street auchinleck, ayrshire.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 04 mai 1990
    Livré le 14 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    27 townhead street cumnock, ayr.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 04 mai 1990
    Livré le 14 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop at 67-73 high street, maybole ayrshire.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 avr. 1990
    Livré le 02 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    123/129 high st lanark 116/118 north vennel lanark.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 févr. 1990
    Livré le 14 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64 mid street bathgate.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 oct. 1989
    Livré le 20 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 4 & 4A glasgow road burnbank glasgow lan 57118.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 mars 1987
    Livré le 19 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    268 glasgow rd blantyre.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 mars 1987Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 17 nov. 1986
    Livré le 04 déc. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    (1) 270/272 glasgow road, blantyre (2) one up left 4 joanna terrace, blantyre one up right 4 joanna terrace blantyre regd title no lan 20237.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 déc. 1986Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 mai 1984
    Livré le 10 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop premises at 48 hanover street stranraer wigtownshire.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 mai 1984Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 02 mai 1984
    Livré le 10 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop premises at 19 the foregate kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 mai 1984Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 mai 1984
    Livré le 10 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop premises at 33 burnbank road, hamilton.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 mai 1984Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 mai 1984
    Livré le 10 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop premises at 57 portland place hamilton.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 mai 1984Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 mai 1984
    Livré le 10 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tennents interest in lease of shop premises known as 15 burnbank centre glasgow rd burnbank.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 mai 1984Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 22 mars 1984
    Livré le 28 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 mars 1984Enregistrement d'une charge
    • 20 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0