QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED

QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéQUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC054465
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED ?

    • Commerce de gros de vin, bière, spiritueux et autres boissons alcoolisées (46342) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Bdo Llp 2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MARBLEHEAD BRAND DEVELOPMENT LIMITED15 mars 199615 mars 1996
    MARBLEHEAD TRADING LIMITED13 févr. 198713 févr. 1987
    RIVINVEND LIMITED09 nov. 197309 nov. 1973

    Quels sont les derniers comptes de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2024
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au12 janv. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation26 janv. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au12 janv. 2024
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Alex Pollard en tant que directeur le 17 sept. 2024

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY Scotland à C/O Bdo Llp 2 Atlantic Square 31 York Street Glasgow G2 8NJ le 11 avr. 2024

    3 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 avr. 2024

    LRESSP

    Satisfaction de la charge SC0544650007 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0544650009 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0544650008 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 12 janv. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023

    10 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 9 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY Scotland à 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY le 02 nov. 2023

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Quartermile One, 15 Lauriston Place Edinburgh EH3 9EP Scotland à 9 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY le 02 nov. 2023

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 12 janv. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    10 pagesAA

    Cessation de la nomination de Warren Michael Scott en tant que directeur le 26 juil. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James David Lousada en tant que directeur le 08 juil. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 12 janv. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2021

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 janv. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2020

    29 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 mars 2019

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge SC0544650009, créée le 17 déc. 2020

    122 pagesMR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James David Lousada le 19 nov. 2020

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Alex Pollard en tant qu'administrateur le 07 juil. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr James Lousada en tant qu'administrateur le 07 oct. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Clifford en tant que secrétaire le 31 mars 2020

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VISONE, Vincenzo
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    Administrateur
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    MonacoItalian152578310001
    BOOTH, Esther
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Secrétaire
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    238800260001
    BROWN, Sophie
    Clayton Road
    Birchwood
    WA3 6PH Warrington
    Distribution Point, Melbury Park
    United Kingdom
    Secrétaire
    Clayton Road
    Birchwood
    WA3 6PH Warrington
    Distribution Point, Melbury Park
    United Kingdom
    185803300001
    CLIFFORD, Michael
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Quartermile One,
    Scotland
    Secrétaire
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Quartermile One,
    Scotland
    245504730001
    DORMAN, Arthur Brian
    Shawhill House
    Galston Road Hurlford
    KA1 5H2 Kilmarnock
    Strathclyde
    Secrétaire
    Shawhill House
    Galston Road Hurlford
    KA1 5H2 Kilmarnock
    Strathclyde
    British752770003
    HENDERSON, Samuel Joseph
    105 Ormonde Avenue
    Netherlee
    G44 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    105 Ormonde Avenue
    Netherlee
    G44 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    British461450001
    LISTER, Steven Geoffrey
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Secrétaire
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    215481910001
    LOVE, Robert
    48 Grenville Drive
    Cambuslang
    G72 8DP Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    48 Grenville Drive
    Cambuslang
    G72 8DP Glasgow
    Lanarkshire
    British1104220001
    ROBERTSON, Bryan Carey
    16 Broomfield Avenue
    Newton Mearns
    G77 5HR Glasgow
    Secrétaire
    16 Broomfield Avenue
    Newton Mearns
    G77 5HR Glasgow
    British60602380002
    ROBERTSON, Carey
    17-27 Station Road
    Milngavie
    G62 8PG Glasgow
    East Dunbartonshire
    Secrétaire
    17-27 Station Road
    Milngavie
    G62 8PG Glasgow
    East Dunbartonshire
    British146903990001
    STEEL, Robin Gray
    48 Viewpark Drive
    Burnside
    G73 3QD Glasgow
    Secrétaire
    48 Viewpark Drive
    Burnside
    G73 3QD Glasgow
    British79076290001
    URE, Julie East
    17 North Crescent Road
    KA22 8NA Ardrossan
    Ayrshire
    Secrétaire
    17 North Crescent Road
    KA22 8NA Ardrossan
    Ayrshire
    British81670520003
    AGNEW, Richard Alexander
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    Administrateur
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    ScotlandBritish461440004
    AMNER, Kenneth Ian Mcdonald
    5 Kirkdene Grove
    Newton Mearns
    G77 5RW Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    5 Kirkdene Grove
    Newton Mearns
    G77 5RW Glasgow
    Lanarkshire
    British462540001
    AMNER, Kenneth Ian Mcdonald
    5 Kirkdene Grove
    Newton Mearns
    G77 5RW Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    5 Kirkdene Grove
    Newton Mearns
    G77 5RW Glasgow
    Lanarkshire
    British462540001
    BROWN, Sophie Nina
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Administrateur
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    United KingdomBritish184987420001
    DORMAN, Arthur Brian
    Shawhill House
    Galston Road Hurlford
    KA1 5H2 Kilmarnock
    Strathclyde
    Administrateur
    Shawhill House
    Galston Road Hurlford
    KA1 5H2 Kilmarnock
    Strathclyde
    British752770003
    GRAHAM, Heather Claire
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    Administrateur
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    United KingdomBritish27043920005
    HENDERSON, Samuel Joseph
    105 Ormonde Avenue
    Netherlee
    G44 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    105 Ormonde Avenue
    Netherlee
    G44 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    British461450001
    HENDRY, James Williamson
    Timaru 37 Maclachlan Avenue
    FK6 5HF Denny
    Stirlingshire
    Administrateur
    Timaru 37 Maclachlan Avenue
    FK6 5HF Denny
    Stirlingshire
    British72259690001
    HENDRY, James Williamson
    Timaru 37 Maclachlan Avenue
    FK6 5HF Denny
    Stirlingshire
    Administrateur
    Timaru 37 Maclachlan Avenue
    FK6 5HF Denny
    Stirlingshire
    British72259690001
    KEITH, Richard Maxwell
    14 Russell Place
    EH5 3HH Edinburgh
    Scotland
    Administrateur
    14 Russell Place
    EH5 3HH Edinburgh
    Scotland
    United KingdomBritish46747460001
    LISTER, Steven Geoffrey
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Administrateur
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    EnglandBritish215478530001
    LOUSADA, James David
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Quartermile One,
    Scotland
    Administrateur
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Quartermile One,
    Scotland
    EnglandBritish152222000001
    MORGAN, John White
    21 Claremont Drive
    Bridge Of Allan
    FK9 4EE Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    21 Claremont Drive
    Bridge Of Allan
    FK9 4EE Stirling
    Stirlingshire
    ScotlandBritish35561700001
    POLLARD, Alex
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    Administrateur
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    EnglandBritish275119170001
    SALMON, Mike
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    Administrateur
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    United KingdomBritish180282760001
    SCOTT, Warren Michael
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Quartermile One,
    Scotland
    Administrateur
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Quartermile One,
    Scotland
    EnglandBritish151869960001
    STEEL, Robin Gray
    48 Viewpark Drive
    Burnside
    G73 3QD Glasgow
    Administrateur
    48 Viewpark Drive
    Burnside
    G73 3QD Glasgow
    British79076290001
    STEWARD, David
    17-27 Station Road
    Milngavie
    G62 8PG Glasgow
    East Dunbartonshire
    Administrateur
    17-27 Station Road
    Milngavie
    G62 8PG Glasgow
    East Dunbartonshire
    United KingdomBritish199652170001
    STEWARD, David
    42 Church Street
    Coggeshall
    CM7 5JY Braintree
    Essex
    Administrateur
    42 Church Street
    Coggeshall
    CM7 5JY Braintree
    Essex
    British47647120003
    WYKES, Emma Claire
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    Administrateur
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    United KingdomBritish179739820001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Quintessential Spirits Uk Limited
    Clayton Road
    Birchwood
    WA3 6PH Warrington
    Distribution Point, Melbury Park
    England
    06 avr. 2016
    Clayton Road
    Birchwood
    WA3 6PH Warrington
    Distribution Point, Melbury Park
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleThe Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement7723026
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 17 déc. 2020
    Livré le 22 déc. 2020
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Property located at distribution point, melbury court, risley, warrington registered at the land registry with title number CH561943. UK trademark with application number UK00002428193 and registration number UK00002428193. For further details of land and intellectual property charged, please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 22 déc. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 mars 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 03 déc. 2018
    Livré le 05 déc. 2018
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 05 déc. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 mars 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 août 2018
    Livré le 01 août 2018
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 01 août 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 mars 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 juin 2015
    Livré le 12 juin 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 27 avr. 2012
    Livré le 05 mai 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 05 mai 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 12 mai 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 avr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 10 avr. 1989
    Livré le 18 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    17 cloberfield milngavie dmb 16893.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 13 juil. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Letter of agreement
    Créé le 19 juil. 1988
    Livré le 03 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All sums invested with bank or bid deposit acc. No. 91003070 and interest accrued thereon.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 août 1988Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 26 sept. 1978
    Livré le 06 oct. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1978Enregistrement d'une charge
    • 12 mai 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 juil. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)

    QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 avr. 2024Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0