QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Liquidation |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC054465 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Bdo Llp 2 Atlantic Square 31 York Street G2 8NJ Glasgow |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2024 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2024 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 12 janv. 2025 |
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 26 janv. 2025 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 12 janv. 2024 |
| En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Alex Pollard en tant que directeur le 17 sept. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY Scotland à C/O Bdo Llp 2 Atlantic Square 31 York Street Glasgow G2 8NJ le 11 avr. 2024 | 3 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge SC0544650007 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC0544650009 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC0544650008 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 janv. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023 | 10 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 9 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY Scotland à 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY le 02 nov. 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Quartermile One, 15 Lauriston Place Edinburgh EH3 9EP Scotland à 9 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY le 02 nov. 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 janv. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 10 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Warren Michael Scott en tant que directeur le 26 juil. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James David Lousada en tant que directeur le 08 juil. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 janv. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2021 | 25 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 janv. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2020 | 29 pages | AA | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2019 | 24 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Inscription de la charge SC0544650009, créée le 17 déc. 2020 | 122 pages | MR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James David Lousada le 19 nov. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Alex Pollard en tant qu'administrateur le 07 juil. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr James Lousada en tant qu'administrateur le 07 oct. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Clifford en tant que secrétaire le 31 mars 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISONE, Vincenzo | Administrateur | 2 Atlantic Square 31 York Street G2 8NJ Glasgow C/O Bdo Llp | Monaco | Italian | 152578310001 | |||||
| BOOTH, Esther | Secrétaire | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire | 238800260001 | |||||||
| BROWN, Sophie | Secrétaire | Clayton Road Birchwood WA3 6PH Warrington Distribution Point, Melbury Park United Kingdom | 185803300001 | |||||||
| CLIFFORD, Michael | Secrétaire | 15 Lauriston Place EH3 9EP Edinburgh Quartermile One, Scotland | 245504730001 | |||||||
| DORMAN, Arthur Brian | Secrétaire | Shawhill House Galston Road Hurlford KA1 5H2 Kilmarnock Strathclyde | British | 752770003 | ||||||
| HENDERSON, Samuel Joseph | Secrétaire | 105 Ormonde Avenue Netherlee G44 3SN Glasgow Lanarkshire | British | 461450001 | ||||||
| LISTER, Steven Geoffrey | Secrétaire | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire | 215481910001 | |||||||
| LOVE, Robert | Secrétaire | 48 Grenville Drive Cambuslang G72 8DP Glasgow Lanarkshire | British | 1104220001 | ||||||
| ROBERTSON, Bryan Carey | Secrétaire | 16 Broomfield Avenue Newton Mearns G77 5HR Glasgow | British | 60602380002 | ||||||
| ROBERTSON, Carey | Secrétaire | 17-27 Station Road Milngavie G62 8PG Glasgow East Dunbartonshire | British | 146903990001 | ||||||
| STEEL, Robin Gray | Secrétaire | 48 Viewpark Drive Burnside G73 3QD Glasgow | British | 79076290001 | ||||||
| URE, Julie East | Secrétaire | 17 North Crescent Road KA22 8NA Ardrossan Ayrshire | British | 81670520003 | ||||||
| AGNEW, Richard Alexander | Administrateur | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire Scotland | Scotland | British | 461440004 | |||||
| AMNER, Kenneth Ian Mcdonald | Administrateur | 5 Kirkdene Grove Newton Mearns G77 5RW Glasgow Lanarkshire | British | 462540001 | ||||||
| AMNER, Kenneth Ian Mcdonald | Administrateur | 5 Kirkdene Grove Newton Mearns G77 5RW Glasgow Lanarkshire | British | 462540001 | ||||||
| BROWN, Sophie Nina | Administrateur | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire | United Kingdom | British | 184987420001 | |||||
| DORMAN, Arthur Brian | Administrateur | Shawhill House Galston Road Hurlford KA1 5H2 Kilmarnock Strathclyde | British | 752770003 | ||||||
| GRAHAM, Heather Claire | Administrateur | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire Scotland | United Kingdom | British | 27043920005 | |||||
| HENDERSON, Samuel Joseph | Administrateur | 105 Ormonde Avenue Netherlee G44 3SN Glasgow Lanarkshire | British | 461450001 | ||||||
| HENDRY, James Williamson | Administrateur | Timaru 37 Maclachlan Avenue FK6 5HF Denny Stirlingshire | British | 72259690001 | ||||||
| HENDRY, James Williamson | Administrateur | Timaru 37 Maclachlan Avenue FK6 5HF Denny Stirlingshire | British | 72259690001 | ||||||
| KEITH, Richard Maxwell | Administrateur | 14 Russell Place EH5 3HH Edinburgh Scotland | United Kingdom | British | 46747460001 | |||||
| LISTER, Steven Geoffrey | Administrateur | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire | England | British | 215478530001 | |||||
| LOUSADA, James David | Administrateur | 15 Lauriston Place EH3 9EP Edinburgh Quartermile One, Scotland | England | British | 152222000001 | |||||
| MORGAN, John White | Administrateur | 21 Claremont Drive Bridge Of Allan FK9 4EE Stirling Stirlingshire | Scotland | British | 35561700001 | |||||
| POLLARD, Alex | Administrateur | 2 Atlantic Square 31 York Street G2 8NJ Glasgow C/O Bdo Llp | England | British | 275119170001 | |||||
| SALMON, Mike | Administrateur | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire Scotland | United Kingdom | British | 180282760001 | |||||
| SCOTT, Warren Michael | Administrateur | 15 Lauriston Place EH3 9EP Edinburgh Quartermile One, Scotland | England | British | 151869960001 | |||||
| STEEL, Robin Gray | Administrateur | 48 Viewpark Drive Burnside G73 3QD Glasgow | British | 79076290001 | ||||||
| STEWARD, David | Administrateur | 17-27 Station Road Milngavie G62 8PG Glasgow East Dunbartonshire | United Kingdom | British | 199652170001 | |||||
| STEWARD, David | Administrateur | 42 Church Street Coggeshall CM7 5JY Braintree Essex | British | 47647120003 | ||||||
| WYKES, Emma Claire | Administrateur | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire Scotland | United Kingdom | British | 179739820001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quintessential Spirits Uk Limited | 06 avr. 2016 | Clayton Road Birchwood WA3 6PH Warrington Distribution Point, Melbury Park England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 17 déc. 2020 Livré le 22 déc. 2020 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Property located at distribution point, melbury court, risley, warrington registered at the land registry with title number CH561943. UK trademark with application number UK00002428193 and registration number UK00002428193. For further details of land and intellectual property charged, please refer to the instrument. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 03 déc. 2018 Livré le 05 déc. 2018 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 01 août 2018 Livré le 01 août 2018 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 10 juin 2015 Livré le 12 juin 2015 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 27 avr. 2012 Livré le 05 mai 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Standard security | Créé le 10 avr. 1989 Livré le 18 avr. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 17 cloberfield milngavie dmb 16893. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of agreement | Créé le 19 juil. 1988 Livré le 03 août 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All sums invested with bank or bid deposit acc. No. 91003070 and interest accrued thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 26 sept. 1978 Livré le 06 oct. 1978 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0