BRITSHIP TWO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRITSHIP TWO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC055006
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRITSHIP TWO LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe BRITSHIP TWO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BRITSHIP TWO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BLUE STAR LINE MARINE LIMITED18 sept. 199618 sept. 1996
    STAR OFFSHORE SERVICES MARINE LIMITED07 févr. 197407 févr. 1974

    Quels sont les derniers comptes de BRITSHIP TWO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour BRITSHIP TWO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Modification des coordonnées du secrétaire John Kilby le 22 déc. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Kilby le 22 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd Aberdeen AB10 1DQ le 24 déc. 2009

    1 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 nov. 2009

    LRESSP

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    Certificat de changement de nom

    Company name changed blue star line marine LIMITED\certificate issued on 21/07/09
    2 pagesCERTNM

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363s

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de BRITSHIP TWO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KILBY, John, Mr.
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    Secrétaire
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    British76247880001
    BURRIDGE, James George Thomas
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    Administrateur
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    EnglandUnited Kingdom59355820001
    KILBY, John, Mr.
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    Administrateur
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    EnglandBritish76247880001
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Secrétaire
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    British7865940001
    DEAR, Philip
    61 Anderson Drive
    AB15 4UA Aberdeen
    Secrétaire
    61 Anderson Drive
    AB15 4UA Aberdeen
    British78057600001
    MCGEOCH, Christopher
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    Secrétaire
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    British40359510005
    ZIMMER, Kaarina Ann
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    Secrétaire
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    British104894830001
    ALLEN, Martyn Clive
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    Administrateur
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    United KingdomBritish117739980001
    BRYCE, John Alexander
    Craig Dorney
    Kinellar
    AB21 0SG Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Craig Dorney
    Kinellar
    AB21 0SG Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish69880420001
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Administrateur
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    United KingdomBritish7865940001
    COLLINS, John Alexander, Sir
    Flat 4
    63 Millbank Terraces
    SW1P 4RW London
    Administrateur
    Flat 4
    63 Millbank Terraces
    SW1P 4RW London
    British53032980001
    COOPER, Robert Hamilton
    Great Yews
    Lubbock Road
    BR7 5LA Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    Great Yews
    Lubbock Road
    BR7 5LA Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish11632250002
    CORK, Barry Philip Arthur
    Wainstones
    1 Riversides Blackhall
    AB31 3PS Banchory
    Grampian
    Administrateur
    Wainstones
    1 Riversides Blackhall
    AB31 3PS Banchory
    Grampian
    British555660003
    CORNTHWAITE, Christopher John
    24 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    24 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish34530990002
    DAWS, Christopher
    14 West Glebe
    AB3 2HZ Stonehaven
    Kincardineshire
    Administrateur
    14 West Glebe
    AB3 2HZ Stonehaven
    Kincardineshire
    British555670001
    DEAR, Philip
    61 Anderson Drive
    AB15 4UA Aberdeen
    Administrateur
    61 Anderson Drive
    AB15 4UA Aberdeen
    British78057600001
    HABGOOD, David John Cecil
    Richmond Cottage
    21 Ashley Park Avenue
    KT12 1ER Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    Richmond Cottage
    21 Ashley Park Avenue
    KT12 1ER Walton On Thames
    Surrey
    EnglandBritish29831660001
    MCGEOCH, Christopher
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    Administrateur
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    British40359510005
    MONEY, Timothy John
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    EnglandBritish71374890003
    O'BRIEN, Bernadette Mary
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    Administrateur
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    EnglandIrish95129740001
    PUSEY, Nigel Simon
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    Administrateur
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    British83149350005
    ROBBIE, David Andrew
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    Administrateur
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    United KingdomBritish108246820001
    SPENCER-PAYNE, Christopher David
    1 Beechgrove Gardens
    AB2 4HG Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    1 Beechgrove Gardens
    AB2 4HG Aberdeen
    Aberdeenshire
    British66395410001
    WALKER, Peter Arthur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    Administrateur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    United KingdomBritish708770001
    WOODS, Robert Barclay
    Old Rectory
    Frilsham
    RG18 9XH Newbury
    Administrateur
    Old Rectory
    Frilsham
    RG18 9XH Newbury
    EnglandBritish154397820001

    BRITSHIP TWO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    General assignment
    Créé le 08 déc. 1997
    Livré le 29 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All rights title and interest in the assigned property mv "brisbane star" to be renamed "singapore star".
    Personnes ayant droit
    • Credit Agricole Indosuez
    Transactions
    • 29 déc. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of covenant
    Créé le 08 déc. 1997
    Livré le 29 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All rights, title and interest to an in th mv "brisbane star" to be renamed "singapore star".
    Personnes ayant droit
    • Credit Agricole Indosuez
    Transactions
    • 29 déc. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Ship mortgage
    Créé le 08 déc. 1997
    Livré le 29 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the mv "brisbane star" to be renamed "singapore star".
    Personnes ayant droit
    • Credit Agricole Indosuez
    Transactions
    • 29 déc. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    General assignment
    Créé le 10 janv. 1996
    Livré le 31 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Earnings and requisition compensation of the M.V. "sydney star".
    Personnes ayant droit
    • Banque Indosuez
    Transactions
    • 31 janv. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of covenant
    Créé le 10 janv. 1996
    Livré le 25 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares in M.V. "sydney star"....see ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • Banque Indosuez
    Transactions
    • 25 janv. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    First priority bahamas stat.mortgage
    Créé le 10 janv. 1996
    Livré le 25 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares in M.V. "sydney star",nassau 343036 and boats,guns,ammunition,small arms and appertunances.
    Personnes ayant droit
    • Banque Indosuez
    Transactions
    • 25 janv. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignment agreement
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 07 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company and another
    Brèves mentions
    The earnings....... See ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of covenants
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 07 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company and another
    Brèves mentions
    "Brisbane star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 723468, with the earnings and the requisition compensation....... See ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Second deed of covenants
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 07 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    "Brisbane star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 723468, with the earnings and the requisition compensation....... See ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Second priority bahamian ship mortgage
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 07 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    "Brisbane star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 723468.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of covenants
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 07 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    "Queensland star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 358737, with the earnings and requisition compensation....... See ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of covenants
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 07 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    "America star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 341451, with the earnings and requisition compensation....... See ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transactions
    • 07 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 mars 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Second assignment of earnings
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 07 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    "Assigned monies"....... See ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignment of earnings
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 07 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    "Assigned monies"....... See ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    First priority bahamian ship mortgage
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 07 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    "Queensland star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 358737.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignment of earnings
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 07 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    "Assigned monies"........ See ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transactions
    • 07 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 mars 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    First priority bahamian ship mortgage
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 07 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    "America star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 341451.
    Personnes ayant droit
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transactions
    • 07 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 mars 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    First priority bahamian ship mortgage
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 07 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    "Brisbane star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 723468.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    First priority statutory mortgage
    Créé le 30 avr. 1992
    Livré le 07 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the M.V. "star pegasus" official number 702738.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transactions
    • 07 mai 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Second priority statutory mortgage
    Créé le 30 avr. 1992
    Livré le 07 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the M.V. "star pegasus" official number 702738.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 mai 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of covenant
    Créé le 29 avr. 1992
    Livré le 07 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £7,400,000
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the M.V. "star pegasus".
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 mai 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Delivery order
    Créé le 22 mars 1991
    Livré le 28 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All materials, engines and machinery of yard no. 603.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 14 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    3RD priority mortgage
    Créé le 22 mars 1991
    Livré le 28 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares in "star altair" official no. 701173.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 14 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of covenant
    Créé le 22 mars 1991
    Livré le 28 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares in M.V. "star altair" official no 701173.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 14 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of covenant
    Créé le 22 mars 1991
    Livré le 28 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares in M.V. "star capella" official no 701153.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 14 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    BRITSHIP TWO LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 juil. 2010Dissolved on
    30 nov. 2009Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0