GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC055629 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Regency House Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neil Fitzsimmons le 01 nov. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Elizabeth Catchpole en tant qu'administrateur le 20 juin 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 mars 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de James Mclellan Kirkpatrick en tant que directeur le 11 juil. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 6 pages | AA | ||||||||||
État du capital au 09 sept. 2011
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 mars 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 mars 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Gaffney en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Colin Edward Lewis en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Neil Fitzsimmons en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 mars 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ le 02 févr. 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 29 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Dominic Lavelle en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Secrétaire | Ridgeway Road RH1 6PQ Redhill 35 Surrey United Kingdom | 147809240001 | |||||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Administrateur | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||
| FITZSIMMONS, Neil | Administrateur | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||
| LEWIS, Colin Edward | Administrateur | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| GANDHI, Devendra | Secrétaire | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Secrétaire | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| MASON, Eddie Roy | Secrétaire | 14 John Huband Drive Birkhill DD2 5RY Dundee | British | 606150007 | ||||||
| ANDERSON, Alexander | Administrateur | 34 Ledcameroch Gardens FK15 0GZ Dunblane Perthshire | Scotland | British | 114144470001 | |||||
| BARLOW, David St John | Administrateur | Inglewood Slaley NE47 0AA Hexham | British | 40287360005 | ||||||
| BETT, Iain Charles Rattray | Administrateur | Kingennie House Kingennie DD5 3RD Dundee | Scotland | British | 95179330001 | |||||
| CALDER, John Murray | Administrateur | 69 Camphill Road Broughty Ferry DD5 2LY Dundee | British | 318650001 | ||||||
| CHURCH, Charles | Administrateur | 6 Lynebank Grove Newton Mearns G77 5GB Glasgow | United Kingdom | British | 79873860001 | |||||
| CLARK, James | Administrateur | 48 Garvine Road Coylton KA6 6NZ Ayr | British | 37854600001 | ||||||
| CLELLAND, Lorraine Agnes | Administrateur | 9 Alexander Gordon Drive Monifieth DD5 4HD Dundee Angus | British | 102629370001 | ||||||
| DAVIDSON, Kareen | Administrateur | 85 Loughborough Road KY1 3DD Kirkcaldy Fife | British | 44746080001 | ||||||
| DIPRE, John Vivian | Administrateur | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | 9018280015 | |||||
| DIPRE, Remo | Administrateur | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| DOUGLAS, Keith Richard | Administrateur | Lilac Cottage Castlehill Main Street FK8 3DN Kippen Stirlingshire | United Kingdom | British | 91229410003 | |||||
| GAFFNEY, David | Administrateur | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Administrateur | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| GIBSON, Alexander | Administrateur | 117 Strathern Road Broughty Ferry DD5 1JR Dundee Angus | British | 318180001 | ||||||
| GRANT, Alexander James | Administrateur | 52 Wester Inshes Court IV2 5HS Inverness Inverness Shire | British | 107801990001 | ||||||
| HALDANE, Kenneth Douglas | Administrateur | 64 Victoria Road PA2 9PT Paisley Renfrewshire | United Kingdom | British | 94477860001 | |||||
| HANNA, Ronald George | Administrateur | 34 Primrose Bank Road EH5 3JF Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 8506940001 | |||||
| HAWKSBY, Terry | Administrateur | Newbigging Farmhouse Tibbermore PH1 1QH Perth Perthshire | United Kingdom | British | 93733930001 | |||||
| HITCHEN, David James | Administrateur | 4 Carrongrove Avenue Carron FK2 8NG Falkirk | British | 60512890001 | ||||||
| INNES, John Gordon | Administrateur | 14 Limeview Road Glenburn PA2 8ND Paisley Renfrewshire | British | 72090910001 | ||||||
| KIRKPATRICK, James Mclellan | Administrateur | 35 Cardowan Road Stepps G33 6HJ Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 102797820001 | |||||
| KIRKPATRICK, James Mclellan | Administrateur | 35 Cardowan Road Stepps G33 6HJ Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 102797820001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Administrateur | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LEITCH, Gerald | Administrateur | 24 Mary Fisher Crescent G82 1BF Dumbarton Dunbartonshire | British | 110231420001 | ||||||
| LYON, Steven | Administrateur | 44 Maule Street DD7 6AB Carnoustie Angus | Uk | British | 97482510001 | |||||
| MCBRIDE, Alexander Clunie | Administrateur | 6 Cupar Road KY8 6DQ Lundin Links The Stables Fife United Kingdom | Scotland | British | 147233120001 | |||||
| MCGOWAN, James Joseph | Administrateur | 66 Mulben Crescent Crookston G53 7EH Glasgow | British | 77647430001 | ||||||
| MITCHELL, Ronald | Administrateur | 7 Albert Road Broughty Ferry DD5 1AY Dundee Angus | British | 318190001 |
GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 30 déc. 2008 Livré le 14 janv. 2009 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 30 déc. 2008 Livré le 08 janv. 2009 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 21 mai 2003 Livré le 03 juin 2003 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of offset | Créé le 10 avr. 1984 Livré le 24 avr. 1984 | En cours | Montant garanti All moneys due, or to become due by bett brothers PLC and/or others | |
Brèves mentions The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of spalding (insurance brokers) LTD. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0