GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED

GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC055629
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Regency House
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BETT HOMES (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED27 avr. 200527 avr. 2005
    BETT HOMES (SCOTLAND) LIMITED29 janv. 200429 janv. 2004
    BETT HOMES LIMITED11 nov. 199211 nov. 1992
    BETT ESTATES LIMITED09 mai 198609 mai 1986
    SPALDING (INSURANCE BROKERS) LIMITED09 mai 197409 mai 1974

    Quels sont les derniers comptes de GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neil Fitzsimmons le 01 nov. 2011

    2 pagesCH01

    Nomination de Elizabeth Catchpole en tant qu'administrateur le 20 juin 2012

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 mars 2012

    État du capital au 14 mars 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de James Mclellan Kirkpatrick en tant que directeur le 11 juil. 2011

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    6 pagesAA

    État du capital au 09 sept. 2011

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de David Gaffney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Colin Edward Lewis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Neil Fitzsimmons en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ le 02 févr. 2010

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 29 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Dominic Lavelle en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147809240001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secrétaire
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Secrétaire
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    ANDERSON, Alexander
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish114144470001
    BARLOW, David St John
    Inglewood
    Slaley
    NE47 0AA Hexham
    Administrateur
    Inglewood
    Slaley
    NE47 0AA Hexham
    British40287360005
    BETT, Iain Charles Rattray
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    Administrateur
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    ScotlandBritish95179330001
    CALDER, John Murray
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    Administrateur
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    British318650001
    CHURCH, Charles
    6 Lynebank Grove
    Newton Mearns
    G77 5GB Glasgow
    Administrateur
    6 Lynebank Grove
    Newton Mearns
    G77 5GB Glasgow
    United KingdomBritish79873860001
    CLARK, James
    48 Garvine Road
    Coylton
    KA6 6NZ Ayr
    Administrateur
    48 Garvine Road
    Coylton
    KA6 6NZ Ayr
    British37854600001
    CLELLAND, Lorraine Agnes
    9 Alexander Gordon Drive
    Monifieth
    DD5 4HD Dundee
    Angus
    Administrateur
    9 Alexander Gordon Drive
    Monifieth
    DD5 4HD Dundee
    Angus
    British102629370001
    DAVIDSON, Kareen
    85 Loughborough Road
    KY1 3DD Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    85 Loughborough Road
    KY1 3DD Kirkcaldy
    Fife
    British44746080001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Administrateur
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    DOUGLAS, Keith Richard
    Lilac Cottage Castlehill
    Main Street
    FK8 3DN Kippen
    Stirlingshire
    Administrateur
    Lilac Cottage Castlehill
    Main Street
    FK8 3DN Kippen
    Stirlingshire
    United KingdomBritish91229410003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Administrateur
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    GIBSON, Alexander
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    Administrateur
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    British318180001
    GRANT, Alexander James
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    British107801990001
    HALDANE, Kenneth Douglas
    64 Victoria Road
    PA2 9PT Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    64 Victoria Road
    PA2 9PT Paisley
    Renfrewshire
    United KingdomBritish94477860001
    HANNA, Ronald George
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish8506940001
    HAWKSBY, Terry
    Newbigging Farmhouse
    Tibbermore
    PH1 1QH Perth
    Perthshire
    Administrateur
    Newbigging Farmhouse
    Tibbermore
    PH1 1QH Perth
    Perthshire
    United KingdomBritish93733930001
    HITCHEN, David James
    4 Carrongrove Avenue
    Carron
    FK2 8NG Falkirk
    Administrateur
    4 Carrongrove Avenue
    Carron
    FK2 8NG Falkirk
    British60512890001
    INNES, John Gordon
    14 Limeview Road
    Glenburn
    PA2 8ND Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    14 Limeview Road
    Glenburn
    PA2 8ND Paisley
    Renfrewshire
    British72090910001
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    35 Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    35 Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish102797820001
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    35 Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    35 Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish102797820001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    LEITCH, Gerald
    24 Mary Fisher Crescent
    G82 1BF Dumbarton
    Dunbartonshire
    Administrateur
    24 Mary Fisher Crescent
    G82 1BF Dumbarton
    Dunbartonshire
    British110231420001
    LYON, Steven
    44 Maule Street
    DD7 6AB Carnoustie
    Angus
    Administrateur
    44 Maule Street
    DD7 6AB Carnoustie
    Angus
    UkBritish97482510001
    MCBRIDE, Alexander Clunie
    6 Cupar Road
    KY8 6DQ Lundin Links
    The Stables
    Fife
    United Kingdom
    Administrateur
    6 Cupar Road
    KY8 6DQ Lundin Links
    The Stables
    Fife
    United Kingdom
    ScotlandBritish147233120001
    MCGOWAN, James Joseph
    66 Mulben Crescent
    Crookston
    G53 7EH Glasgow
    Administrateur
    66 Mulben Crescent
    Crookston
    G53 7EH Glasgow
    British77647430001
    MITCHELL, Ronald
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    Administrateur
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    British318190001

    GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 14 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 08 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 21 mai 2003
    Livré le 03 juin 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 juin 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Letter of offset
    Créé le 10 avr. 1984
    Livré le 24 avr. 1984
    En cours
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by bett brothers PLC and/or others
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of spalding (insurance brokers) LTD.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 avr. 1984Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0