RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED

RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC055754
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED ?

    • (6024) /

    Où se situe RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Pricewaterhousecoopers
    PO BOX 90 Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RICHARD LAWSON MOTOR COMPANY LIMITED08 juin 197408 juin 1974

    Quels sont les derniers comptes de RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au04 janv. 2003

    Quels sont les derniers dépôts pour RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Ordonnance du tribunal

    Order of court - dissolution void
    1 pagesOC-DV

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Ordonnance du tribunal

    Order of court - dissolution void
    1 pagesOC-DV

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Avis de fin automatique de l'administration

    7 pages2.21B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    8 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    2 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    8 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    2 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    10 pages2.20B(Scot)

    legacy

    1 pages287

    legacy

    40 pages2.18B(Scot)

    État des affaires

    37 pages2.15B(Scot)

    legacy

    1 pages288b

    Proposition de l'administrateur

    40 pages2.16B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    8 pages363s

    Comptes consolidés établis au 04 janv. 2003

    20 pagesAA

    Comptes consolidés établis au 30 déc. 2001

    21 pagesAA

    legacy

    9 pages363s

    Qui sont les dirigeants de RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FYFE, Alexander
    27 Seaforth Crescent
    Broughty Ferry
    DD5 1QD Dundee
    Angus
    Secrétaire
    27 Seaforth Crescent
    Broughty Ferry
    DD5 1QD Dundee
    Angus
    British72003050001
    GISVOLD, Rune
    Iver Holters Vei 36
    N1710 Kolbotn
    Norway
    Administrateur
    Iver Holters Vei 36
    N1710 Kolbotn
    Norway
    Norwegian85499620001
    HOLM, Aage Sturtzel
    Bekkeveien 1b
    1336 Sandvika
    Norway
    Administrateur
    Bekkeveien 1b
    1336 Sandvika
    Norway
    Norwegian66364500001
    COWIE, John Michael
    Glasgow Road
    PH2 0LU Perth
    123
    Perthshire
    Secrétaire
    Glasgow Road
    PH2 0LU Perth
    123
    Perthshire
    British543350001
    NICOLL, Douglas John
    5 Mayville Gardens
    Trinity
    EH5 3DB Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    5 Mayville Gardens
    Trinity
    EH5 3DB Edinburgh
    Midlothian
    British166730001
    WILSON, Kenneth
    24 Etive Drive
    Giffnock
    G46 6PN Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    24 Etive Drive
    Giffnock
    G46 6PN Glasgow
    Lanarkshire
    British53458580002
    BRUERS, Georges
    Guyotdreef 26
    2930 Brasschaat
    Belgium
    Administrateur
    Guyotdreef 26
    2930 Brasschaat
    Belgium
    Belgium33794790001
    COWIE, John Michael
    Glasgow Road
    PH2 0LU Perth
    123
    Perthshire
    Administrateur
    Glasgow Road
    PH2 0LU Perth
    123
    Perthshire
    ScotlandBritish543350001
    EUREN, Bengt Ingvar Lennart
    Vindragarvagen 12
    Stockholm
    11750
    Sweden
    Administrateur
    Vindragarvagen 12
    Stockholm
    11750
    Sweden
    Swedish57830000001
    HAGEL, Lennart Nils Fredrik
    Trossvagen 2
    S 181 66 Lidingo
    Sweden
    Administrateur
    Trossvagen 2
    S 181 66 Lidingo
    Sweden
    SwedenSwedish36224910001
    HAYNES, Peter Davis
    19 Buckland
    Shoeburyness
    SS3 8BD Southend On Sea
    Essex
    Administrateur
    19 Buckland
    Shoeburyness
    SS3 8BD Southend On Sea
    Essex
    British3387810001
    LAWSON, Richard Herring
    Over Pilmore
    Invergowrie
    DD2 5EL Dundee
    Administrateur
    Over Pilmore
    Invergowrie
    DD2 5EL Dundee
    ScotlandBritish146501290001
    LAWSON, Susan Janet
    Winsterley 23 Reres Road
    Broughty Ferry
    DD5 2QA Dundee
    Angus
    Administrateur
    Winsterley 23 Reres Road
    Broughty Ferry
    DD5 2QA Dundee
    Angus
    British166750001
    MACKAY, Ian
    Tall Chambers
    45 Saint Wilfrids Road
    DN4 6AB Doncaster
    South Yorks
    Administrateur
    Tall Chambers
    45 Saint Wilfrids Road
    DN4 6AB Doncaster
    South Yorks
    British85693920001
    NICOLL, Douglas John
    5 Mayville Gardens
    Trinity
    EH5 3DB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 Mayville Gardens
    Trinity
    EH5 3DB Edinburgh
    Midlothian
    British166730001
    OLSSON, Christer Bengt
    Grev Turegatan 75
    S-114 38
    Stockholm
    Sweden
    Administrateur
    Grev Turegatan 75
    S-114 38
    Stockholm
    Sweden
    Swedish21234530001
    REEVES, Martin Charles
    Crestover Christmas Hill
    South Wonston
    SO21 3ES Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Crestover Christmas Hill
    South Wonston
    SO21 3ES Winchester
    Hampshire
    British22890000001
    SKAUG, Odd Ingar
    Mariesvei 18b
    N-1363 Hevik
    Norway
    Administrateur
    Mariesvei 18b
    N-1363 Hevik
    Norway
    Norwegian64835160001
    STYER, Richard
    Minimus Cottage
    BA7 7DJ Castle Cary
    Somerset
    Administrateur
    Minimus Cottage
    BA7 7DJ Castle Cary
    Somerset
    British1133930001
    VAN MOL, Walter Petrus Maria
    Rood Borstlaan 17
    FOREIGN 2660 Antwerp
    Belgium
    Administrateur
    Rood Borstlaan 17
    FOREIGN 2660 Antwerp
    Belgium
    Dutch5666990001
    WILSON, Kenneth
    24 Etive Drive
    Giffnock
    G46 6PN Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    24 Etive Drive
    Giffnock
    G46 6PN Glasgow
    Lanarkshire
    British53458580002

    RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 31 août 1999
    Livré le 17 sept. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal charge over property known as lima, block a, bourne business park, weybridge; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 sept. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 31 janv. 1997
    Livré le 07 févr. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground on the south east side of cortachy road,kirriemuir.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 févr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    Legal charge
    Créé le 08 févr. 1995
    Livré le 20 févr. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land on the south side of rossfield road, ellesmere port, cheshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 févr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 13 juin 1994
    Livré le 21 juin 1994
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 juin 1994Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 02 févr. 1989
    Livré le 08 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Cortachir road kirriemuir, angus.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 12 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 25 nov. 1988
    Livré le 05 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Parcel of land and buildings thereon situate the south side of rossfield road ch 131908.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 05 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Aircraft mortgage
    Créé le 21 mars 1988
    Livré le 29 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £88,200 and all sums due or to become due
    Brèves mentions
    One 1976 cessing 421C golden eagle aircraft reg. Mark g-rlmc serial no-421C 0118.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 29 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 01 févr. 1988
    Livré le 08 févr. 1988
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Piece of ground lying on or towards the southeast side of cortachy road in the parish of kirriemuir and county of angus (formerly forfar) sometime forming part of the lands and estate of hillhead in said parish and county and (second) all and whole that area or piece of ground in the said parish and county extending to thirty four decimal parts of a hectare or thereby.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 25 janv. 1983
    Livré le 10 févr. 1983
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Garage and warehouse premises at 51 dundonald street, dundee, angus.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1983Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 03 oct. 1975
    Livré le 13 oct. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 oct. 1975Enregistrement d'une charge
    • 04 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 sept. 2004Administration started
    13 juin 2006Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Bruce Cartwright
    Po Box 90
    Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    practitioner
    Po Box 90
    Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    John Bruce Cartwright
    Po Box 90
    Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    practitioner
    Po Box 90
    Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    Robert Hunt
    Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Graham Douglas Frost
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh
    practitioner
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh
    Graham Douglas Frost
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh
    practitioner
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0