SUTHERLANDS GARAGE (BROADFORD) LIMITED

SUTHERLANDS GARAGE (BROADFORD) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSUTHERLANDS GARAGE (BROADFORD) LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société SC055923
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SUTHERLANDS GARAGE (BROADFORD) LIMITED ?

    • (5050) /

    Où se situe SUTHERLANDS GARAGE (BROADFORD) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Robert Owen House
    87 Bath Street
    G2 2EE Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SUTHERLANDS GARAGE (BROADFORD) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 janv. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SUTHERLANDS GARAGE (BROADFORD) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SUTHERLANDS GARAGE (BROADFORD) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Conversion to an industrial & provident society 29/07/2011
    RES13

    Comptes pour une société dormante établis au 01 janv. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 déc. 2010

    État du capital au 13 déc. 2010

    • Capital: GBP 20,573
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Hurrell le 01 août 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Humes le 01 août 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2010

    5 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 11 janv. 2010 au 02 janv. 2010

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Katherine Eldridge en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Caroline Jane Sellers en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 10 janv. 2009

    8 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 12 janv. 2008

    16 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 23 avr. 2007

    7 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    Résolutions

    Resolutions
    30 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    1 pages225

    legacy

    5 pages288a

    Qui sont les dirigeants de SUTHERLANDS GARAGE (BROADFORD) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SELLERS, Caroline Jane
    Robert Owen House
    87 Bath Street
    G2 2EE Glasgow
    Secrétaire
    Robert Owen House
    87 Bath Street
    G2 2EE Glasgow
    150341250001
    HUMES, Stephen
    c/o Goverance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Goverance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director84087790001
    HURRELL, Timothy
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Manager - Food Group99724260001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secrétaire
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    SELLERS, Caroline Jane
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    Secrétaire
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    British45801060004
    SUTHERLAND, Grace
    1 Harrapool
    IV49 9AQ Broadford
    Isle Of Skye
    Secrétaire
    1 Harrapool
    IV49 9AQ Broadford
    Isle Of Skye
    British372090001
    MACPHIE, Angus
    Ptarmigan
    IV49 9AQ Broadford
    Isle Of Skye
    Administrateur
    Ptarmigan
    IV49 9AQ Broadford
    Isle Of Skye
    BritishDirector372110002
    MCCRACKEN, Philip Guy
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishRetailer106997230001
    SUTHERLAND, Angus Duncan
    A'Chomraich,I Harrapool
    Broadford
    IV49 9AQ Isle Of Skye
    Administrateur
    A'Chomraich,I Harrapool
    Broadford
    IV49 9AQ Isle Of Skye
    ScotlandScottishDirector64732980002
    SUTHERLAND, Grace
    1 Harrapool
    IV49 9AQ Broadford
    Isle Of Skye
    Administrateur
    1 Harrapool
    IV49 9AQ Broadford
    Isle Of Skye
    BritishDirector372090001

    SUTHERLANDS GARAGE (BROADFORD) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 20 sept. 2004
    Livré le 01 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 oct. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 22 août 2002
    Livré le 04 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The chalets, torvaig, sleat, isle of skye.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 sept. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 04 mars 2002
    Livré le 13 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 mars 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 déc. 1996
    Livré le 24 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £45,500
    Brèves mentions
    0.36 acres in village of broadford, strath, inverness together with the dwellinghouse forming 1 torrin road, broadford, isle of skye.
    Personnes ayant droit
    • Angus Duncan Sutherland and Others as Trustees of the Sutherlands Retirement Benefit Scheme
    Transactions
    • 24 déc. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 avr. 1995
    Livré le 19 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Chalets 1 & 2 toravaig house hotel, toravaig, sleat, isle of skye.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 19 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 11 août 1994
    Livré le 22 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transactions
    • 22 août 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 mars 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation
    Créé le 19 juil. 1994
    Livré le 21 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All those monies which may from time to time be owing to sutherlands garage(broadford)LTD. By V.A.g(united kingdom)LTD.in respect of refunds of monies paid by or bythe direction of sutherlands garage(broadford) LTD. To V.A. g(united kingdom) LTD. By way of deposit on the aquisition of motor veicles on a consignment basis. The ASSIGNATI0N provides that sutherlands garage(broadford)LTD. Shall not without the prior written consent of volkswagen financialservices(UK) LTD. Create or permit to come into being any mortgage charge or assignment inrespect ofthe moniesassigned bythe assignat/n.
    Personnes ayant droit
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transactions
    • 21 juil. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 juin 1991
    Livré le 13 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground lying to north of A850 road for portree to kyleakin isle of skye extending to 8455 decimal parts of a hectare.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 13 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 19 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 mai 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.8485 ha north of the A850 road, broadford.
    Personnes ayant droit
    • Esso Petroleum Company Limited
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 01 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 févr. 1988
    Livré le 10 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground north of public road from lyleakin to portree.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 10 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 01 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 04 juil. 1987
    Livré le 14 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Motor vehicles stock.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker LTD
    Transactions
    • 14 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 21 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation
    Créé le 20 mars 1984
    Livré le 22 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All monies owing to the company by V.A.G. (UK) LTD.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker LTD
    Transactions
    • 22 mars 1984Enregistrement d'une charge
    • 28 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 01 juil. 1983
    Livré le 14 juil. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground near portree.
    Personnes ayant droit
    • B.P. Oil LTD
    Transactions
    • 14 juil. 1983Enregistrement d'une charge
    • 21 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 24 déc. 1981
    Livré le 13 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All monies due under vehicle aquisition consignment basis.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds and Scottish Trust LTD
    Transactions
    • 13 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    • 29 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 oct. 1978
    Livré le 31 oct. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £16640.23
    Brèves mentions
    Campbells garage, broadford, skye and ground attached.
    Personnes ayant droit
    • Esso Petroleum Company LTD
    Transactions
    • 31 oct. 1978Enregistrement d'une charge
    • 01 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 févr. 1977
    Livré le 24 févr. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at broadford, strath, skye.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 24 févr. 1977Enregistrement d'une charge
    • 21 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 27 mai 1976
    Livré le 15 juin 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 15 juin 1976Enregistrement d'une charge
    • 15 sept. 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 07 mai 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 26 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0