TITAN SUBSEA SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TITAN SUBSEA SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC056038 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TITAN SUBSEA SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Kirkhill Road Kirkhill Industrial Estate Dyce AB21 0GQ Aberdeen Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TITAN SUBSEA SERVICES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour TITAN SUBSEA SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire | 4 pages | 4.26(Scot) | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Dominic Upton en tant que directeur le 10 févr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Badentoy Avenue Badentoy Industrial Estate Portlethen Aberdeen AB12 4YB | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Bj Services Company Ltd Badentoy Avenue Badentoy Industrial Estate, Portlethen Aberdeen AB12 4YB à Kirkhill Road Kirkhill Industrial Estate Dyce Aberdeen AB21 0GQ le 25 nov. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 sept. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Lorraine Amanda Dunlop en tant que secrétaire le 11 août 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jenni Therese Klassen en tant que secrétaire le 11 août 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr. John Dominic Upton en tant qu'administrateur le 26 avr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Asquith en tant que directeur le 26 avr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mrs Jenni Therese Klassen en tant que secrétaire le 01 juil. 2014 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Bryan Stokes en tant que secrétaire le 01 juil. 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 12 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr. Michael Allan Rasmuson en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Oluwole Onabolu en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Oluwole Onabolu en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Elaine Mays en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TITAN SUBSEA SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNLOP, Lorraine Amanda | Secrétaire | Kirkhill Industrial Estate Dyce AB21 0GQ Aberdeen Kirkhill Road Scotland | 212597070001 | |||||||
| RASMUSON, Michael Allan, Mr. | Administrateur | Kirkhill Industrial Estate Dyce AB21 0GQ Aberdeen Kirkhill Road Scotland | England | Canadian | 98354440002 | |||||
| FIDDES, Patricia | Secrétaire | Blenheim Place AB25 2DN Aberdeen 142 Aberdeen | British | 134131390001 | ||||||
| FORSYTH, Robert Charles | Secrétaire | 4 Turner Avenue EH14 7BS Balerno Midlothian | British | 866840001 | ||||||
| KLASSEN, Jenni Therese | Secrétaire | Badentoy Avenue Badentoy Industrial Estate, Portlethen AB12 4YB Aberdeen Bj Services Company Ltd | 189703760001 | |||||||
| MCCOLL, Robert, Mr. | Secrétaire | 7 Greenfield Street G51 3PW Glasgow Lanarkshire | British | 1395450001 | ||||||
| MCGREGOR, Neil Alexander | Secrétaire | 13 Baillieswells Terrace Bieldside AB15 9AR Aberdeen | British | 92174950001 | ||||||
| STOKES, Paul Bryan | Secrétaire | c/o Baker Hughes Floor Building 5 Chiswick Park 566 Chiswick High Road W4 5YF London 3rd United Kingdom | 158759420001 | |||||||
| PAULL & WILLIAMSONS | Secrétaire | Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen | 24280001 | |||||||
| ASQUITH, Christopher | Administrateur | c/o Baker Hughes Floor Building 5 Chiswick Park 566 Chiswick High Road W4 5YF London 3rd United Kingdom | England | British | 17673120003 | |||||
| BELISARIO, Anthony Alfredo | Administrateur | 24 Coronation Road Prestbury GL52 3DA Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 19258750001 | |||||
| BELL, William Mcdougall | Administrateur | Cumbrae Watson Street AB31 5UB Banchory Kincardineshire | British | 49014070002 | ||||||
| CLARKE, Richard John George | Administrateur | Redwood Harp Hill Charlton Kings GL52 6PX Cheltenham Gloucestershire | England | British | 38606270001 | |||||
| DICKSON, James | Administrateur | 16 Lochend Road Bearsden G61 1DX Glasgow Lanarkshire | British | 866830001 | ||||||
| DUNLAP, David Dean | Administrateur | 19featherall Place 77381 The Woodlands Texas United States | American | 51167350001 | ||||||
| EMMERSON, Stewart Frank | Administrateur | 15615 Stable Lake Drive Cypress Texas Tx77429 Usa | British | 81730760002 | ||||||
| GRAVES, Leslie John | Administrateur | Dunreggan 43 Slug Road AB39 2DU Stonehaven Kincardineshire | Scotland | British | 40661150002 | |||||
| LINK, Lindsay Robert | Administrateur | 40 Hillview Road Cults AB15 9HA Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | Canadian | 118479530001 | |||||
| MAYS, Elaine Doris | Administrateur | c/o Baker Hughes Floor Building 5 Chiswick Park 566 Chiswick High Road W4 5YF London 3rd United Kingdom | Scotland | British | 196074340001 | |||||
| MCCOLL, Robert, Mr. | Administrateur | 7 Greenfield Street G51 3PW Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 1395450001 | |||||
| MCKEOWN, Robert | Administrateur | 10 Overlee Road Clarkston G76 8BU Glasgow | Scotland | British | 50362310002 | |||||
| MITCHELL, Robert Walter | Administrateur | 54 Somerset Road Edgbaston B15 2PD Birmingham | England | British | 40132600001 | |||||
| ONABOLU, Oluwole | Administrateur | Badentoy Avenue Badentoy Industrial Estate, Portlethen AB12 4YB Aberdeen Bj Services Company Ltd | South Africa | Nigerian | 171308090001 | |||||
| RALPH, Bruce Charles | Administrateur | Leckhampton Grange Leckhampton Hill GL53 9QH Cheltenham Gloucestershire | British | 14415110002 | ||||||
| RUSSELL, Jack Ross | Administrateur | 28 Brownside Road Cambuslang G72 8NL Glasgow Lanarkshire | British | 866820001 | ||||||
| SMITH, Jeffrey Edward | Administrateur | 1927 Lake Fountain Drive Katy Houston Texas 77494 Usa | Usa | American | 112680530003 | |||||
| STEWART, James William | Administrateur | 3 Longfellow Lane Houston Texas 77005 U S A | Usa | American | 1162900003 | |||||
| TELFER, Gordon | Administrateur | Windyridge House Station Brae AB14 0PX Peterculter Aberdeen | British | 81730800002 | ||||||
| UPTON, John Dominic | Administrateur | Kirkhill Industrial Estate Dyce AB21 0GQ Aberdeen Kirkhill Road Scotland | England | British | 207648640001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TITAN SUBSEA SERVICES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bj Services Company Limited | 06 avr. 2016 | Badentoy Avenue Badentoy Industrial Estate, Portlethen AB12 4YB Aberdeen Badentoy Avenue Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
TITAN SUBSEA SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Créé le 28 août 1996 Livré le 04 sept. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Instrument of charge | Créé le 05 août 1980 Livré le 08 août 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 20 sept. 1974 Livré le 25 sept. 1974 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
TITAN SUBSEA SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0