KENNEDY UTILITY SERVICES (SCOTLAND) LIMITED

KENNEDY UTILITY SERVICES (SCOTLAND) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKENNEDY UTILITY SERVICES (SCOTLAND) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC058129
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KENNEDY UTILITY SERVICES (SCOTLAND) LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe KENNEDY UTILITY SERVICES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Fenick House 1 Lister Way
    Hamilton International Technology Park
    G72 0FT Blantyre
    Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KENNEDY UTILITY SERVICES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KENNEDY GAS SERVICES (SCOTLAND) LIMITED02 juil. 197502 juil. 1975

    Quels sont les derniers comptes de KENNEDY UTILITY SERVICES (SCOTLAND) LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2009
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2010
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour KENNEDY UTILITY SERVICES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 mai 2009 avec liste complète des actionnaires

    pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    pagesAA

    legacy

    pages287

    legacy

    pages287

    legacy

    pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    pagesAA

    legacy

    pages419a(Scot)

    legacy

    pages419a(Scot)

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    pagesAA

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    pagesAA

    legacy

    pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2004

    pagesAA

    legacy

    pages363s

    Comptes établis au 31 déc. 2003

    pagesAA

    legacy

    pages363a

    Qui sont les dirigeants de KENNEDY UTILITY SERVICES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GEORGE, Timothy Francis
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    Secrétaire
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    British24075160004
    GEORGE, Timothy Francis
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    Administrateur
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish24075160004
    MILLS, Lee James
    4 Kings Court
    CM23 2AA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Kings Court
    CM23 2AA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish53951880001
    ATKINSON, Sarah Elizabeth
    13 Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    13 Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    Cheshire
    British53216670002
    FORSTER, Garry James
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    British38750850004
    KIRKIN, Richard William
    2 Redwood Close
    Woolston
    WA1 4EH Warrington
    Cheshire
    Secrétaire
    2 Redwood Close
    Woolston
    WA1 4EH Warrington
    Cheshire
    British1180700001
    AM SECRETARIES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Secrétaire
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    28265670010
    ATKINSON, Sarah Elizabeth
    13 Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    13 Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    Cheshire
    British53216670002
    CAROLAN, Peter Vincent
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Administrateur
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Irish62299930001
    COMER, Patrick Gerald
    21 Buttermere Drive
    Hale Barns
    WA15 0ST Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    21 Buttermere Drive
    Hale Barns
    WA15 0ST Altrincham
    Cheshire
    British1180680003
    CURLEY, Patrick Joseph
    Danley House
    Alders Land
    Disley
    Cheshire
    Administrateur
    Danley House
    Alders Land
    Disley
    Cheshire
    Irish1180690001
    GLOVER, Michael John
    88 Barkham Ride
    RG40 4ET Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    88 Barkham Ride
    RG40 4ET Wokingham
    Berkshire
    British50242550001
    GRICE, Ian Michael
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    Administrateur
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    United KingdomBritish44883010002
    HUNT, Kenneth Edward
    2 Fern Cottages
    Post Office Lane Norley
    WA6 8JW Frodsham
    Cheshire
    Administrateur
    2 Fern Cottages
    Post Office Lane Norley
    WA6 8JW Frodsham
    Cheshire
    British1180660002
    JACKSON, Andrew Philip
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    Administrateur
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    EnglandBritish7921750002
    KENNEDY, John Thomas
    June Corner
    Hawley Drive Hale Barns
    WA15 0DP Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    June Corner
    Hawley Drive Hale Barns
    WA15 0DP Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish6334820001
    KENNEDY, Patrick James
    Mayo Brooks Drive
    Halebarns
    WA15 8TL Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    Mayo Brooks Drive
    Halebarns
    WA15 8TL Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish47720560001
    KENYON, David
    42 The Warings
    Heskin
    PR7 5NZ Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    42 The Warings
    Heskin
    PR7 5NZ Chorley
    Lancashire
    British37060690001
    PARSONS, James Christopher
    Chudleigh 34 Arthog Road
    Hale
    WA15 0LY Altrincham
    Administrateur
    Chudleigh 34 Arthog Road
    Hale
    WA15 0LY Altrincham
    British1180670002
    AM NOMINEES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Administrateur
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    34427260007
    AM SECRETARIES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Administrateur
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    28265670010

    KENNEDY UTILITY SERVICES (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 13 août 1997
    Livré le 01 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 sept. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Composite guarantee and mortgage debenutre
    Créé le 13 août 1997
    Livré le 01 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole of the property and undertaking of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 sept. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0