LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED

LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC059324
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2010

    11 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG03s

    Cessation de la nomination de Anne Woods en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christine Griffiths en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2009

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    16 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 mars 2010

    État du capital au 29 mars 2010

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Anthony Karran le 17 mars 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Moira Thomson Mcharrie le 17 mars 2010

    3 pagesCH01

    Nomination de Anne Elizabeth Couper Woods en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Christine Martha Campbell Griffiths en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alistair Allan en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2008

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2007

    8 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2006

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KARRAN, David Anthony
    Top Floor
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    C/O Simcocks Trust Limited
    Isle Of Man
    Administrateur
    Top Floor
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    C/O Simcocks Trust Limited
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish146844090001
    MCHARRIE, Moira Thomson
    Top Floor
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    C/O Simcocks Trust Limited
    Isle Of Man
    Administrateur
    Top Floor
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    C/O Simcocks Trust Limited
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish146827140001
    ALLAN, Alistair John
    94 Drymen Road
    Bearsden
    G61 2SY Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    94 Drymen Road
    Bearsden
    G61 2SY Glasgow
    Lanarkshire
    British110042200001
    THOM, Robin
    113 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 5BT Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    113 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 5BT Glasgow
    Lanarkshire
    Scottish41503900002
    WISEMAN, William
    58 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    58 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Glasgow
    Lanarkshire
    British422620001
    BLACK, Ian Craig
    Church View 25 Sywell Road
    Overstone
    NN6 0AQ Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Church View 25 Sywell Road
    Overstone
    NN6 0AQ Northampton
    Northamptonshire
    British4579780001
    CHALMERS, Norman Ashley
    Brook House
    Templewood Lane
    SL2 3HW Farnham Common
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Brook House
    Templewood Lane
    SL2 3HW Farnham Common
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish35542160001
    GREEN, Simon Charles
    2 Great Western Terrace Dowanhill
    G12 9NA Glasgow
    Administrateur
    2 Great Western Terrace Dowanhill
    G12 9NA Glasgow
    British44467640001
    GRIEVE, Alexander Raeburn
    Carlhurlie
    KY8 5QE Lundin Links
    Fife
    Administrateur
    Carlhurlie
    KY8 5QE Lundin Links
    Fife
    ScotlandScottish409950001
    GRIFFITHS, Christine Martha Campbell
    c/o Simcocks Trust Limited
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    Top Floor
    Isle Of Man
    Administrateur
    c/o Simcocks Trust Limited
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    Top Floor
    Isle Of Man
    UkBritish147842710001
    KELLY, Patrick Joseph
    2 Crosslees Road
    Thornliebank
    G46 7EW Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    2 Crosslees Road
    Thornliebank
    G46 7EW Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish71731770001
    LAWTHER, Samuel David
    Dean House
    Upper Dean
    PE18 0ND Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Dean House
    Upper Dean
    PE18 0ND Huntingdon
    Cambridgeshire
    British41835460001
    LOW, Richard Dennis
    Hughenden House
    25 Hughenden Road
    G12 9XP Glasgow
    Administrateur
    Hughenden House
    25 Hughenden Road
    G12 9XP Glasgow
    United KingdomBritish47115610003
    MCINTYRE, John
    The White House Of Milliken
    PA5 8 Brookfield
    Administrateur
    The White House Of Milliken
    PA5 8 Brookfield
    ScotlandBritish422630001
    RUDGE, Alan James
    Packwood Manor Road
    Grendon
    NN7 1JF Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Packwood Manor Road
    Grendon
    NN7 1JF Northampton
    Northamptonshire
    British9647250001
    STEVENSON, Peter David
    The White House
    147 Whitehouse Lane
    EH9 2EY Edinburgh
    Administrateur
    The White House
    147 Whitehouse Lane
    EH9 2EY Edinburgh
    ScotlandBritish1251400001
    SWANSON, John George
    14 Crosslees Road
    Thornliebank
    G46 7EW Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    14 Crosslees Road
    Thornliebank
    G46 7EW Glasgow
    Lanarkshire
    British409920001
    WILSON, Gordon Scott Macintyre
    2 Brierie Lane
    Brierie Hills
    PA6 7LS Crossley
    Houston
    Administrateur
    2 Brierie Lane
    Brierie Hills
    PA6 7LS Crossley
    Houston
    United KingdomBritish32664250002
    WILSON, Lynn Anthony
    The Maltings Tithe Farm
    Moulton Road Holcot
    NN6 9SH Northampton
    Administrateur
    The Maltings Tithe Farm
    Moulton Road Holcot
    NN6 9SH Northampton
    British92355200002
    WISEMAN, William
    58 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    58 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish422620001
    WOODS, Anne Elizabeth Couper
    c/o Simcocks Trust Limited
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    Top Floor
    Isle Of Man
    Administrateur
    c/o Simcocks Trust Limited
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    Top Floor
    Isle Of Man
    UkBritish147842400001

    LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 30 oct. 1998
    Livré le 12 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 nov. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 30 août 1995
    Livré le 15 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects situated at darnley mains estate, nitshill road, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 sept. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 déc. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 30 août 1995
    Livré le 15 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    955 shettleston road, glasgow, registered under title number gla 57683.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 sept. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 déc. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 30 août 1995
    Livré le 15 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    410 to 414 (even numbers) hillington road, glasgow, registered under title number gla 34663.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 sept. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 déc. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 29 août 1995
    Livré le 01 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 sept. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 janv. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 avr. 1995
    Livré le 24 avr. 1995
    En cours
    Montant garanti
    The whole obligations in terms of missives dated 31/3/95
    Brèves mentions
    Gla 96302.
    Personnes ayant droit
    • B & Q PLC
    Transactions
    • 24 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 28 janv. 1994
    Livré le 09 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects on south west side of nitshill road darnley glasgow-GLA26727.
    Personnes ayant droit
    • Seagram United Kingdom Limited
    Transactions
    • 09 févr. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 04 juin 1993
    Livré le 11 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    955 shettleston road, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juin 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 08 janv. 1991
    Livré le 11 janv. 1991
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    955 shettleston road glasgow gla 57683.
    Personnes ayant droit
    • Municipal General Insurance Limited
    Transactions
    • 11 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 29 déc. 1989
    Livré le 15 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.54 acres west of stenhouse road,falkirk.
    Personnes ayant droit
    • Scarborough and Glasgow Property Company Limited
    Transactions
    • 15 janv. 1990Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 nov. 1989
    Livré le 12 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    16.24 acres west of stenhouse road,falkirk.
    Personnes ayant droit
    • Scarborough and Glasgow Property Company Limited
    Transactions
    • 12 déc. 1989Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 05 avr. 1989
    Livré le 10 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 févr. 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 juin 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 29 janv. 1988
    Livré le 05 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Bridgeton cross shopping centre, main st, bridgeton.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 21 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 08 oct. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Bridgeton cross shopping centre, main street, bridgeton.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    • 21 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 15 déc. 1986
    Livré le 31 déc. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease over 4608 sq. Metres or thereby bounded on or towards the north north west by the south south east side of the carriageway and footpath of james street, bridgeton glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Municipal Mutual Insurance LTD
    Transactions
    • 31 déc. 1986Enregistrement d'une charge
    • 21 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 31 oct. 1984
    Livré le 19 nov. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease by city of glasgow district council.
    Personnes ayant droit
    • Balfour Beatty Construction (Scotland) LTD
    Transactions
    • 19 nov. 1984Enregistrement d'une charge
    • 21 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 11 févr. 1981
    Livré le 23 févr. 1981
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground lying on the south side of maclellan street, glasgow extending to 5.03 acres.
    Personnes ayant droit
    • St. Martins Property Investments LTD, St. Vedast House, 150 Cheapside, London
    Transactions
    • 23 févr. 1981Enregistrement d'une charge
    • 19 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 19 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 janv. 1981
    Livré le 11 févr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Elliot street,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 févr. 1981Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0