BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE)
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE) |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | SC059329 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE) ?
| Adresse du siège social | Suite 22, Enterprise House, Southbank Business Park, Kirkintilloch G66 1XQ Glasgow East Dunbartonshire Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE) ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 01 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 01 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 28 févr. 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE) ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 30 avr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 mai 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 30 avr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE) ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes pour une petite entreprise établis au 28 févr. 2025 | 29 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Ms Alexandra Elizabeth Jane Taylor en tant qu'administrateur le 24 avr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Kenneth Corbett Gray en tant qu'administrateur le 24 avr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Stephen Mee en tant qu'administrateur le 24 avr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Oliver Phillips en tant que directeur le 24 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Harry Olorunda en tant que directeur le 24 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gillian Murray en tant que directeur le 24 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Mcguire en tant que directeur le 24 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alison Johnstone en tant que directeur le 24 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul David Hastie en tant que directeur le 24 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Catherine Rennie Conaghan Duffy en tant que directeur le 24 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 29 févr. 2024 | 32 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Wishart en tant que directeur le 25 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Suite 2, Enterprise House, Southbank Business Park Kirkintilloch Glasgow East Dunbartonshire G66 1XQ Scotland à Suite 22, Enterprise House, Southbank Business Park, Kirkintilloch Glasgow East Dunbartonshire G66 1XQ le 01 mai 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kathleen Sims en tant que directeur le 25 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Iain Mckenzie Reid en tant que directeur le 25 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jason Angus Cockburn en tant que directeur le 25 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen James Annand en tant que directeur le 25 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Robert Foulds en tant qu'administrateur le 25 avr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Statuts | 17 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr James Mcguire en tant qu'administrateur le 20 avr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE) ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDNER, Christina | Secrétaire | 19 Ross Avenue Kirkintilloch G66 2BW Glasgow | British | 72475710001 | ||||||
| BAIN, Euan Marshall | Administrateur | West Regent Street G2 2AW Glasgow 79 Scotland | Scotland | British | 219313230001 | |||||
| CANT, Alan Stuart | Administrateur | Lochside Place EH12 9HA Edinburgh 11 Scotland | Scotland | British | 120952690001 | |||||
| CHALMERS, Graham | Administrateur | Tunnel Street G3 8HL Glasgow 25 Tunnel Street Scotland | Scotland | British | 308521960001 | |||||
| FOULDS, Robert | Administrateur | Chiswick Place, 566 Chiswick Road, W4 5AN London Building 12 England | England | British | 322628200001 | |||||
| GRAY, Kenneth Corbett | Administrateur | Duke Street G31 1JD Glasgow 161 Scotland | Scotland | British | 266138230001 | |||||
| HASSARD, Niall John Norman | Administrateur | West Campbell Street G2 6SE Glasgow 41 Scotland | Scotland | British | 308525210001 | |||||
| KARLSSON, Anna Jenny Karolina | Administrateur | West Regent Street G2 2AW Glasgow 79 Scotland | Scotland | Swedish | 282407230001 | |||||
| MCILWRAITH, Fraser Duncan | Administrateur | West Regent Street G2 2AW Glasgow 79 Scotland | Scotland | British | 279285960001 | |||||
| MEE, David Stephen | Administrateur | Advocates Close EH1 1ND Edinburgh 10 Advocate's Close Scotland | Scotland | British | 335533870001 | |||||
| PAUL, Warren Robert | Administrateur | Shettleston Road G32 9AT Glasgow 1346 Scotland | Scotland | British | 253786430001 | |||||
| TAYLOR, Alexandra Elizabeth Jane | Administrateur | South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 2-4 Broadway Park, South Gyle, Edinburgh Scotland | Scotland | British | 335534450001 | |||||
| MCCULLOCH, George | Secrétaire | 79 West Regent Street G2 2AW Glasgow | British | 1114360002 | ||||||
| AHMED, Salim | Administrateur | 25/3 Douglas Crescent EH12 5BA Edinburgh | British | 23190950002 | ||||||
| ALLEN, Susan Patricia | Administrateur | The Old School Aberfoyle Road G63 0SQ Balfron Station West Stirlingshire | British | 71905820001 | ||||||
| ANDERSON, Thomas | Administrateur | 16 Clairinch Way Drymen G63 0DL Glasgow Lanarkshire | British | 322930001 | ||||||
| ANNAND, Stephen James | Administrateur | West Regent Street G2 2AW Glasgow 79 Scotland | Scotland | British | 197793670001 | |||||
| BAIRD, Mark | Administrateur | 79 West Regent Street Glasgow G2 2AW | Scotland | British | 165811480001 | |||||
| BANNERMAN, Elaine Morag | Administrateur | 3 Harper Way Scone PH2 6PW Perth Perthshire | Scotland | British | 120952840001 | |||||
| BARTON, Charles | Administrateur | Seabourne House (East) 96 Monifeith Road Broughty Ferry DD5 2FJ Dundee | British | 48940240001 | ||||||
| BARTON, Joseph | Administrateur | 2 Union Terrace DD3 6JD Dundee | British | 39333010001 | ||||||
| BAUM, Michael Allan | Administrateur | Taigh Na Moine White Moss EH46 7EN West Linton Peeblsshire | British | 1114330001 | ||||||
| BELFIELD, Antony George | Administrateur | Haymains EH55 8RJ West Calder West Lothian | British | 189350001 | ||||||
| BELL, Gordon Stephen | Administrateur | 25 Dornoch Way Carrickstone G68 0JA Cumbernauld North Lanarkshire | Scotland | British | 97347260001 | |||||
| BERGIUS, William Frederick | Administrateur | 68 Crown Road North G12 9HW Glasgow Lanarkshire | British | 473100001 | ||||||
| BETT, Iain Charles Rattray | Administrateur | Kingennie House Kingennie DD5 3RD Dundee | Scotland | British | 95179330001 | |||||
| BEVERIDGE, George | Administrateur | 109 Lethame Road ML10 6EF Strathaven Lanarkshire | British | 585510001 | ||||||
| BROWN, David Douglas | Administrateur | 372 Ferry Road EH5 3QF Edinburgh | British | 71714790001 | ||||||
| BRUCE, Mark James | Administrateur | 70 Moorfoot Way G61 4RL Bearsden Lanarkshire | British | 99935130001 | ||||||
| BRYCE, Shelagh | Administrateur | Spott Road EH42 1RS Dunbar Belhaven Brewery East Lothian Scotland | Scotland | British | 160433090001 | |||||
| BUCHANAN, Marie Elizabeth Susan, Mrs. | Administrateur | 79 West Regent Street Glasgow G2 2AW | Scotland | British | 168531330001 | |||||
| BURNS, Paul | Administrateur | Broadway Park South Gyle EH12 9JZ Edinburgh 2-4 | Uk | British | 152331300001 | |||||
| CALLANDER, Douglas John | Administrateur | 5 Golf View ML10 6AZ Strathaven Lanarkshire | British | 1186810002 | ||||||
| CAMERON, John Reilly | Administrateur | 96 Brownside Road Cambuslang G72 8AF Glasgow | Scotland | British | 51574970001 | |||||
| CAMPBELL, Donald Mckinnon | Administrateur | 5 Maryville Lane Uddingston G71 6EX Glasgow | Scotland | British | 55208670001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE) ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mrs Christina Gardner | 21 avr. 2016 | Southbank Business Park, Kirkintilloch G66 1XQ Glasgow Suite 22, Enterprise House, East Dunbartonshire Scotland | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0