BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE)

BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE)

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE)
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société SC059329
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE) ?

    • Autres activités de travail social sans hébergement n.c.a. (88990) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE) ?

    Adresse du siège social
    Suite 22, Enterprise House, Southbank Business Park,
    Kirkintilloch
    G66 1XQ Glasgow
    East Dunbartonshire
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE) ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le01 mars 2025
    Date d'échéance des prochains comptes01 déc. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 févr. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE) ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au30 avr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 mai 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au30 avr. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE) ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes pour une petite entreprise établis au 29 févr. 2024

    32 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Paul Wishart en tant que directeur le 25 avr. 2024

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Suite 2, Enterprise House, Southbank Business Park Kirkintilloch Glasgow East Dunbartonshire G66 1XQ Scotland à Suite 22, Enterprise House, Southbank Business Park, Kirkintilloch Glasgow East Dunbartonshire G66 1XQ le 01 mai 2024

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Kathleen Sims en tant que directeur le 25 avr. 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Iain Mckenzie Reid en tant que directeur le 25 avr. 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jason Angus Cockburn en tant que directeur le 25 avr. 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stephen James Annand en tant que directeur le 25 avr. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Robert Foulds en tant qu'administrateur le 25 avr. 2024

    2 pagesAP01

    Statuts

    17 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr James Mcguire en tant qu'administrateur le 20 avr. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Wishart en tant qu'administrateur le 20 avr. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Gillian Murray en tant qu'administrateur le 20 avr. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Niall Hassard en tant qu'administrateur le 20 avr. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Kathleen Sims en tant qu'administrateur le 20 avr. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Harry Olorunda en tant qu'administrateur le 20 avr. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Graham Chalmers en tant qu'administrateur le 20 avr. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen John Mcgowan en tant que directeur le 20 avr. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de George William Kyle en tant que directeur le 20 avr. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 28 févr. 2023

    30 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 28 févr. 2022

    27 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 79 West Regent Street Glasgow G2 2AW à Suite 2, Enterprise House, Southbank Business Park Kirkintilloch Glasgow East Dunbartonshire G66 1XQ le 03 mai 2022

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE) ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GARDNER, Christina
    19 Ross Avenue
    Kirkintilloch
    G66 2BW Glasgow
    Secrétaire
    19 Ross Avenue
    Kirkintilloch
    G66 2BW Glasgow
    BritishChief Executive72475710001
    BAIN, Euan Marshall
    West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    79
    Scotland
    Administrateur
    West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    79
    Scotland
    ScotlandScottishBrewery Director219313230001
    CANT, Alan Stuart
    Lochside Place
    EH12 9HA Edinburgh
    11
    Scotland
    Administrateur
    Lochside Place
    EH12 9HA Edinburgh
    11
    Scotland
    ScotlandBritishCommercial Sales Manager120952690001
    CHALMERS, Graham
    Tunnel Street
    G3 8HL Glasgow
    25 Tunnel Street
    Scotland
    Administrateur
    Tunnel Street
    G3 8HL Glasgow
    25 Tunnel Street
    Scotland
    ScotlandBritishHotel Manager308521960001
    CONAGHAN DUFFY, Catherine Rennie
    The Castle Business Park
    FK9 4RT Stirling
    Edrington Beam
    Scotland
    Administrateur
    The Castle Business Park
    FK9 4RT Stirling
    Edrington Beam
    Scotland
    ScotlandBritishOn Trade Controller246109430001
    FOULDS, Robert
    Chiswick Place,
    566 Chiswick Road,
    W4 5AN London
    Building 12
    England
    Administrateur
    Chiswick Place,
    566 Chiswick Road,
    W4 5AN London
    Building 12
    England
    EnglandBritishSales Director322628200001
    HASSARD, Niall John Norman
    West Campbell Street
    G2 6SE Glasgow
    41
    Scotland
    Administrateur
    West Campbell Street
    G2 6SE Glasgow
    41
    Scotland
    ScotlandBritishSolicitor308525210001
    HASTIE, Paul David
    West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    79
    Scotland
    Administrateur
    West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    79
    Scotland
    ScotlandBritishPrecurement Manager282423830001
    JOHNSTONE, Alison
    West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    79
    Scotland
    Administrateur
    West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    79
    Scotland
    ScotlandBritishRegional Sales Manager Drinks Company153424550001
    KARLSSON, Anna Jenny Karolina
    West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    79
    Scotland
    Administrateur
    West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    79
    Scotland
    ScotlandSwedishMarketing Manager282407230001
    MCGUIRE, James
    Francis Street
    SW1P 1QN London
    12
    England
    Administrateur
    Francis Street
    SW1P 1QN London
    12
    England
    ScotlandBritishArea Manager308544480001
    MCILWRAITH, Fraser Duncan
    West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    79
    Scotland
    Administrateur
    West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    79
    Scotland
    United KingdomBritishDrinks Consultant279285960001
    MURRAY, Gillian
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    Administrateur
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    ScotlandBritishOn Trade Director308525630001
    OLORUNDA, Harry
    Francis Street
    SW1P 1QN London
    12
    England
    Administrateur
    Francis Street
    SW1P 1QN London
    12
    England
    ScotlandBritishSales Manager308523450001
    PAUL, Warren Robert
    Shettleston Road
    G32 9AT Glasgow
    1346
    Scotland
    Administrateur
    Shettleston Road
    G32 9AT Glasgow
    1346
    Scotland
    ScotlandBritishEvents Organiser253786430001
    PHILLIPS, Michael Oliver
    West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    79
    Scotland
    Administrateur
    West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    79
    Scotland
    ScotlandBritishRegional Business Manager Drinks Trade269444440001
    MCCULLOCH, George
    79 West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    Secrétaire
    79 West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    British1114360002
    AHMED, Salim
    25/3 Douglas Crescent
    EH12 5BA Edinburgh
    Administrateur
    25/3 Douglas Crescent
    EH12 5BA Edinburgh
    BritishRegional Director23190950002
    ALLEN, Susan Patricia
    The Old School
    Aberfoyle Road
    G63 0SQ Balfron Station
    West Stirlingshire
    Administrateur
    The Old School
    Aberfoyle Road
    G63 0SQ Balfron Station
    West Stirlingshire
    BritishRegional Director Pub Company71905820001
    ANDERSON, Thomas
    16 Clairinch Way
    Drymen
    G63 0DL Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    16 Clairinch Way
    Drymen
    G63 0DL Glasgow
    Lanarkshire
    BritishRetail Director322930001
    ANNAND, Stephen James
    West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    79
    Scotland
    Administrateur
    West Regent Street
    G2 2AW Glasgow
    79
    Scotland
    ScotlandBritishSales Director Wholesale Drinks Company197793670001
    BAIRD, Mark
    79 West Regent Street
    Glasgow
    G2 2AW
    Administrateur
    79 West Regent Street
    Glasgow
    G2 2AW
    ScotlandBritishDistiller165811480001
    BANNERMAN, Elaine Morag
    3 Harper Way
    Scone
    PH2 6PW Perth
    Perthshire
    Administrateur
    3 Harper Way
    Scone
    PH2 6PW Perth
    Perthshire
    ScotlandBritishEvents Manager120952840001
    BARTON, Charles
    Seabourne House (East) 96 Monifeith Road
    Broughty Ferry
    DD5 2FJ Dundee
    Administrateur
    Seabourne House (East) 96 Monifeith Road
    Broughty Ferry
    DD5 2FJ Dundee
    British48940240001
    BARTON, Joseph
    2 Union Terrace
    DD3 6JD Dundee
    Administrateur
    2 Union Terrace
    DD3 6JD Dundee
    BritishHotelier39333010001
    BAUM, Michael Allan
    Taigh Na Moine
    White Moss
    EH46 7EN West Linton
    Peeblsshire
    Administrateur
    Taigh Na Moine
    White Moss
    EH46 7EN West Linton
    Peeblsshire
    British1114330001
    BELFIELD, Antony George
    Haymains
    EH55 8RJ West Calder
    West Lothian
    Administrateur
    Haymains
    EH55 8RJ West Calder
    West Lothian
    British189350001
    BELL, Gordon Stephen
    25 Dornoch Way
    Carrickstone
    G68 0JA Cumbernauld
    North Lanarkshire
    Administrateur
    25 Dornoch Way
    Carrickstone
    G68 0JA Cumbernauld
    North Lanarkshire
    ScotlandBritishRegional Sales Director97347260001
    BERGIUS, William Frederick
    68 Crown Road North
    G12 9HW Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    68 Crown Road North
    G12 9HW Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDir473100001
    BETT, Iain Charles Rattray
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    Administrateur
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    ScotlandBritishChairman95179330001
    BEVERIDGE, George
    109 Lethame Road
    ML10 6EF Strathaven
    Lanarkshire
    Administrateur
    109 Lethame Road
    ML10 6EF Strathaven
    Lanarkshire
    British585510001
    BROWN, David Douglas
    372 Ferry Road
    EH5 3QF Edinburgh
    Administrateur
    372 Ferry Road
    EH5 3QF Edinburgh
    BritishSales & Marketing71714790001
    BRUCE, Mark James
    70 Moorfoot Way
    G61 4RL Bearsden
    Lanarkshire
    Administrateur
    70 Moorfoot Way
    G61 4RL Bearsden
    Lanarkshire
    BritishSales Director99935130001
    BRYCE, Shelagh
    Spott Road
    EH42 1RS Dunbar
    Belhaven Brewery
    East Lothian
    Scotland
    Administrateur
    Spott Road
    EH42 1RS Dunbar
    Belhaven Brewery
    East Lothian
    Scotland
    ScotlandBritishDirector Of Customer Services160433090001
    BUCHANAN, Marie Elizabeth Susan, Mrs.
    79 West Regent Street
    Glasgow
    G2 2AW
    Administrateur
    79 West Regent Street
    Glasgow
    G2 2AW
    ScotlandBritishTrading Director - Scotland168531330001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BENEVOLENT SOCIETY OF THE LICENSED TRADE OF SCOTLAND (THE) ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Christina Gardner
    Southbank Business Park,
    Kirkintilloch
    G66 1XQ Glasgow
    Suite 22, Enterprise House,
    East Dunbartonshire
    Scotland
    21 avr. 2016
    Southbank Business Park,
    Kirkintilloch
    G66 1XQ Glasgow
    Suite 22, Enterprise House,
    East Dunbartonshire
    Scotland
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0