IAN SKELLY (GLASGOW) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | IAN SKELLY (GLASGOW) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC059527 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe IAN SKELLY (GLASGOW) LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o WRIGHT, JOHNSTON & MACKENZIE LLP 302 St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de IAN SKELLY (GLASGOW) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour IAN SKELLY (GLASGOW) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 27 juil. 2020
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Bishop en tant que directeur le 01 janv. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David John Muir en tant qu'administrateur le 01 janv. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
legacy | 44 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
legacy | 51 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de IAN SKELLY (GLASGOW) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINCH, Mark | Secrétaire | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 175736790001 | |||||||
| FINCH, Mark Charles | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 175612870001 | |||||
| MUIR, David John | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | 254017640001 | |||||
| HOUSTON, David Oliver | Secrétaire | 3 Eden Park Castlepark Bothwell G71 3NW Glasgow | British | 75910100001 | ||||||
| MACNAMARA, Richard James | Secrétaire | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 149304450001 | |||||||
| MAHAFFEY, Matthew Ian | Secrétaire | 23 St Oswalds Road Fulford YO1 4PF York North Yorkshire | British | 507940001 | ||||||
| WARD, Andrew Ian | Secrétaire | 6 Coniston Way LS22 6TT Wetherby West Yorkshire | British | 360770001 | ||||||
| WATSON, Deirdre Mary Alison | Secrétaire | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | Uk | 74385360001 | ||||||
| MATHESON & CO LIMITED | Secrétaire | 3 Lombard Street EC3V 9AQ London | 1947590001 | |||||||
| ATKIN, John Richard | Administrateur | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | 20102900001 | ||||||
| ATKIN, John Richard | Administrateur | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | 20102900001 | ||||||
| BEATTIE, Craig Alan | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 177627900001 | |||||
| BEYNON, Peter | Administrateur | Stonehurst Elm Lane Copdock IP8 3ET Ipswich Suffolk | England | British | 38504390006 | |||||
| BISHOP, Matthew | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 206755450002 | |||||
| CHAMBERS, Paul Jonathan | Administrateur | 24 Constable Road Ben Rhydding LS29 8RW Ilkley West Yorkshire | British | 1188140001 | ||||||
| HEALEY, Derek John | Administrateur | 5 Tudor Court Prince Of Wales Mansions HG1 1JB Harrogate North Yorkshire | British | 46399230001 | ||||||
| HERBERT, Mark Philip | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | 123285980005 | |||||
| HOPE, John Alexander | Administrateur | Riverside,5 School Brae EH4 6JN Edinburgh Midlothian | British | 71318590002 | ||||||
| HOUSTON, David Oliver | Administrateur | 3 Eden Park Castlepark Bothwell G71 3NW Glasgow | British | 75910100001 | ||||||
| HOUSTON, Samuel George | Administrateur | Flat 59 Medland House 11 Branch Road E14 7JT London | British | 75730290003 | ||||||
| JONES, Alun Morton | Administrateur | Fen Walk IP12 4BG Woodbridge Fen House Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 12785600004 | |||||
| MACNAMARA, Richard James | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 149294820002 | |||||
| O'DONNELL, Joseph Peter | Administrateur | 5 Brodie Park Avenue PA2 6JH Paisley Renfrewshire | British | 18421870001 | ||||||
| POTTS, Derek | Administrateur | 55 East Street Coggeshall CO6 1SJ Colchester Essex | United Kingdom | British | 52485510001 | |||||
| RITCHIE, John Muir | Administrateur | High House Snipe Farm Road IP13 6SL Clopton Suffolk | British | 22325820001 | ||||||
| SKELLY, Ian Barr | Administrateur | Leewood House ML11 9JA Lanark | United Kingdom | British | 9845580001 | |||||
| SKELLY, Margaret Richmond | Administrateur | Leewood House ML11 9JA Lanarkshire | British | 548730001 | ||||||
| STUART, John Morris | Administrateur | Cromdale 26 Foxglove Avenue LS8 2QR Leeds West Yorkshire | British | 507950001 | ||||||
| WATSON, Deirdre Mary Alison | Administrateur | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | England | Uk | 74385360001 | |||||
| WILLIAMS, Steven Wyn | Administrateur | 199 Finchampstead Road RG40 3HE Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 54580940001 | |||||
| WILLIAMSON, Michael Granville | Administrateur | Church Green Old Church Lane Pateley Bridge HG3 5LZ Harrogate North Yorkshire | British | 57360160001 | ||||||
| WITT, John Raymond | Administrateur | 28 Westerfield Road IP4 2YJ Ipswich Suffolk | Canadian | 51303670001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur IAN SKELLY (GLASGOW) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Skelly Group Limited | 06 avr. 2016 | 302 St Vincent Street G2 5RZ Glasgow C/O Wright, Johnston & Mackenzie Llp Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
IAN SKELLY (GLASGOW) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Assignation in security | Créé le 17 janv. 1991 Livré le 21 janv. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All refunds of moneys paid by the company by way of deposit on the acquisition of motor vehicles supplied by v a g and man. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of offset | Créé le 05 juin 1987 Livré le 16 juin 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due by the company and/or others | |
Brèves mentions The balances at credit of any accounts held by the bank in name of the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignation in security | Créé le 20 nov. 1985 Livré le 25 nov. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All monies due to the company by v a g (UK) LTD relating to motor vehicles and other items. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 04 nov. 1985 Livré le 15 nov. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 04 nov. 1985 Livré le 15 nov. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All used vehicles. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of offset | Créé le 07 août 1985 Livré le 13 août 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due by the company and others | |
Brèves mentions All sums due or to become due to the company by the bank on several bank accounts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 24 juil. 1985 Livré le 06 août 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 1815 great western road, glasgow. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignation | Créé le 30 mars 1984 Livré le 05 avr. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All monies which may from time to time be owing to the company by v a g (UK) LTD. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignation | Créé le 18 nov. 1983 Livré le 08 déc. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions A vehicle head lease agreement dated 18/11/83 between the company and united dominions trust LTD. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 27 juil. 1981 Livré le 11 août 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All monies which may from time to time be owing to the company by vag (united kingdom) LTD. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 27 juil. 1981 Livré le 11 août 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All used motor vehicles and the proceeds of any insurance policies effected over such used motor vehicles. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Standard security | Créé le 12 mars 1981 Livré le 19 mars 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions 2 plots of ground in rutherglen, lanark first plot extending 0.36 acres extending 0.686 hectares. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0