WHIRLY BIRD SERVICES LIMITED

WHIRLY BIRD SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWHIRLY BIRD SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC061453
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WHIRLY BIRD SERVICES LIMITED ?

    • Transport aérien de passagers non régulier (51102) / Transports et stockage
    • Activités de soutien au transport aérien (52230) / Transports et stockage

    Où se situe WHIRLY BIRD SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Chc House,Howe Moss Drive
    Kirkhill Industrial Estate
    AB21 0GL Aberdeen
    Aberdeenshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WHIRLY BIRD SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour WHIRLY BIRD SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    5 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Michael Doyle en tant que directeur le 30 juin 2012

    1 pagesTM01

    Nomination de Shaun Stewart en tant qu'administrateur le 30 juin 2012

    2 pagesAP01

    legacy

    3 pagesMG03s

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 juil. 2012

    État du capital au 03 juil. 2012

    • Capital: GBP 2,133
    SH01

    État du capital au 22 mai 2012

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    3 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    3 pagesSH20

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2011

    13 pagesAA

    Cessation de la nomination de Neil Calvert en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Peter Das le 02 août 2011

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2010

    13 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Peter Das le 13 août 2010

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2009

    13 pagesAA

    Cessation de la nomination de Keith Mullett en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Alexia Jena Henriksen en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Dennis Corbett en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    7 pages363a

    Qui sont les dirigeants de WHIRLY BIRD SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HENRIKSEN, Alexia Jena
    Howe Moss Drive
    Kirkhill Industrial Estate
    AB21 0GL Dyce
    C H C House
    Aberdeen
    Secrétaire
    Howe Moss Drive
    Kirkhill Industrial Estate
    AB21 0GL Dyce
    C H C House
    Aberdeen
    British146612400001
    DAS, Peter
    2104 Sw
    Heemstede
    Beatrixplantsoen 5
    Netherlands
    Administrateur
    2104 Sw
    Heemstede
    Beatrixplantsoen 5
    Netherlands
    NetherlandsDutch123724440004
    LANDSNES, Lars Andreas
    15403 33 A Avenue
    V3S 0K6 Surrey, Bc
    V3s 0k6
    Canada
    Administrateur
    15403 33 A Avenue
    V3S 0K6 Surrey, Bc
    V3s 0k6
    Canada
    Norwegian99726240002
    STEWART, Shaun
    Howe Moss Drive
    Kirkhill Industrial Estate
    AB21 0GL Dyce
    Chc House
    Aberdeen
    United Kingdom
    Administrateur
    Howe Moss Drive
    Kirkhill Industrial Estate
    AB21 0GL Dyce
    Chc House
    Aberdeen
    United Kingdom
    United KingdomBritish159792010001
    CORBETT, Dennis Mcgillivray
    15 Park Drive
    AB39 2NW Stonehaven
    Kincardineshire
    Secrétaire
    15 Park Drive
    AB39 2NW Stonehaven
    Kincardineshire
    British120627310001
    JOHNSON, Vikki
    19 Wyness Grove
    AB51 0TA Kintore
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    19 Wyness Grove
    AB51 0TA Kintore
    Aberdeenshire
    British111565940001
    LANDSNES, Lars Andreas
    15403 33 A Avenue
    V3S 0K6 Surrey, Bc
    V3s 0k6
    Canada
    Secrétaire
    15403 33 A Avenue
    V3S 0K6 Surrey, Bc
    V3s 0k6
    Canada
    Norwegian99726240002
    DAVIDSON & GARDEN
    2 Queens Road
    AB1 6YT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    2 Queens Road
    AB1 6YT Aberdeen
    Aberdeenshire
    676460001
    PETERKINS, SOLICITORS
    100 Union Street
    AB10 1QR Aberdeen
    Secrétaire désigné
    100 Union Street
    AB10 1QR Aberdeen
    900006310001
    ALLANACH, Greg Russell
    15 Wyness Grove
    Castlefields
    AB51 0TA Kintore
    Aberdeenshire
    Administrateur
    15 Wyness Grove
    Castlefields
    AB51 0TA Kintore
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish106700640001
    CALVERT, Neil Menzies
    1440 184th Street
    V3S 9RN Surrey
    British Columbia
    Canada
    Administrateur
    1440 184th Street
    V3S 9RN Surrey
    British Columbia
    Canada
    British58995890003
    CALVERT, Neil Menzies
    1440 184th Street
    V3S 9RN Surrey
    British Columbia
    Canada
    Administrateur
    1440 184th Street
    V3S 9RN Surrey
    British Columbia
    Canada
    British58995890003
    DOYLE, Michael
    Broomfield Park
    Portlethen
    AB12 4XT Aberdeen
    54
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Broomfield Park
    Portlethen
    AB12 4XT Aberdeen
    54
    Aberdeenshire
    British131666460001
    GLENARTHUR, Simon Mark, Lord
    Northbrae Farm House
    Crathes
    AB31 3JQ Banchory
    Kincardineshire
    Administrateur
    Northbrae Farm House
    Crathes
    AB31 3JQ Banchory
    Kincardineshire
    British26915110001
    HENDERSON, Alistair
    35 Watt Crescent
    AB51 4RR Inverurie
    Aberdeenshire
    Administrateur
    35 Watt Crescent
    AB51 4RR Inverurie
    Aberdeenshire
    British123703780001
    KORTE, Jens Fokko
    Solvspenneveien 28
    4032 Stavanger
    Norway
    Administrateur
    Solvspenneveien 28
    4032 Stavanger
    Norway
    German116447360002
    MACLEOD, Iain Alan Robert Alasdair
    The Homestead
    Canon Frome
    HR8 2TG Ledbury
    Herefordshire
    Administrateur
    The Homestead
    Canon Frome
    HR8 2TG Ledbury
    Herefordshire
    British57377970001
    MACLEOD, Joanna
    Foucausie
    Grandhome
    AB22 8AR Aberdeen
    Administrateur
    Foucausie
    Grandhome
    AB22 8AR Aberdeen
    British57377490001
    MULLETT, Keith Woodrow
    5 Springdale Road
    Bieldside
    AB15 9FA Aberdeen
    Administrateur
    5 Springdale Road
    Bieldside
    AB15 9FA Aberdeen
    British94332750004
    PIDCOCK, Frederick
    Ghoirtein,
    Balmain, Drumnadrochit
    IV63 6TJ Inverness
    Administrateur
    Ghoirtein,
    Balmain, Drumnadrochit
    IV63 6TJ Inverness
    British94199060001
    REID, William Mitchell
    99 Keithleigh Gardens
    AB41 7GF Pitmedden
    Aberdeenshire
    Administrateur
    99 Keithleigh Gardens
    AB41 7GF Pitmedden
    Aberdeenshire
    British57560860001
    RUSSELL, Dennis
    Kirkstone
    Station Road
    AB21 0YE Hatton Of Fintray
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Kirkstone
    Station Road
    AB21 0YE Hatton Of Fintray
    Aberdeenshire
    British116319280001
    STROMME, Atle
    Auglendsvein 31
    4019
    FOREIGN Stavanger
    Norway
    Administrateur
    Auglendsvein 31
    4019
    FOREIGN Stavanger
    Norway
    Norwegian99726020001
    VEENSTRA, Rune
    Vardekroken 2b
    4050 Sola
    FOREIGN Norway
    Administrateur
    Vardekroken 2b
    4050 Sola
    FOREIGN Norway
    Norwegian105857140001
    WINNING, Bert Tyrie
    26 Forest Road
    AB2 4BS Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    26 Forest Road
    AB2 4BS Aberdeen
    Aberdeenshire
    British199290001

    WHIRLY BIRD SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 23 avr. 2004
    Livré le 05 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Nova Scotia as Administrative Agent and Security Trustee
    Transactions
    • 05 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 17 oct. 1990
    Livré le 07 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease and area of ground aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 20 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 31 août 1990
    Livré le 10 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 19 mai 1989
    Livré le 30 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Office and warehouse accommodation at thistle road, aberdeen airport, dyce, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 30 mai 1989Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 19 mai 1989
    Livré le 30 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Office and warehouse accommodation at thistle road, aberdeen airport, dyce, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 30 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 avr. 1989
    Livré le 12 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    22/24 howemoss dr kirkhill ind estate dyce.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 12 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 26 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 09 mars 1989
    Livré le 13 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank LTD
    Transactions
    • 13 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 09 juin 1987
    Livré le 19 juin 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.200 hectares at kirkhill ind. Est. Dyce at 22/24 howemoss drive, kirkhill.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 19 juin 1987Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 13 juil. 1979
    Livré le 23 juil. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground; dyce, aberdeen extending to nine hundred and twenty three decimal or one thousandth parts of a hectare or thereby at knobhill industrial estate, dyce.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 23 juil. 1979Enregistrement d'une charge
    • 16 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0