TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD.

TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD.
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC061912
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD. ?

    • (4521) /

    Où se situe TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD. ?

    Adresse du siège social
    c/o HASTINGS & CO
    82 Mitchell Street
    G1 3NA Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD. ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    A TULLOCH & SONS LIMITED04 nov. 198604 nov. 1986
    DONALD DAVIDSON (PLUMBING AND HEATING) LIMITED11 mars 197711 mars 1977

    Quels sont les derniers comptes de TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD. ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de réunion finale des créanciers

    3 pages4.17(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 151 st Vincent Street Glasgow G2 5NJ le 28 févr. 2012

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de William Thomas Mackay en tant que directeur le 12 janv. 2010

    2 pagesTM01

    Ordonnance du tribunal avis de liquidation

    1 pagesCO4.2(Scot)

    Avis de liquidation

    1 pages4.2(Scot)

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Garvis Snook en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Sandra Al-Kordi en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Ashley Martin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Sandra Joan Al-Kordi en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de John Mackay en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Julian Turnbull en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    1 pagesAA

    Cessation de la nomination de Scott Alexander en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 mars 2010

    État du capital au 15 mars 2010

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Scott Alexander le 01 mars 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur William Thomas Mackay le 01 mars 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Thomas Macleod en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Grant Lowe en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    1 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AL-KORDI, Sandra Joan
    151 St Vincent Street
    Glasgow
    G2 5NJ
    Secrétaire
    151 St Vincent Street
    Glasgow
    G2 5NJ
    154058120001
    CAMPBELL, Gary Angus
    Clach Na Sanais
    Croy
    IV1 2PG Inverness
    Secrétaire
    Clach Na Sanais
    Croy
    IV1 2PG Inverness
    British44913110001
    STEWART, Katherine M
    22 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RB Inverness
    Inverness Shire
    Secrétaire
    22 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RB Inverness
    Inverness Shire
    British565690001
    SUTHERLAND, Caroline Anne
    Flat 4/1, 255 Clarence Drive
    G11 7JU Glasgow
    Secrétaire
    Flat 4/1, 255 Clarence Drive
    G11 7JU Glasgow
    British87534020001
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Secrétaire
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    British1321720003
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Secrétaire
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    British1321720003
    TRACE, Marjory Bremner
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    Secrétaire
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    British43522850004
    TURNBULL, Julian Patrick
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    Secrétaire
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    English11548360002
    ALEXANDER, Scott
    Ruchlinn
    Camp Road,
    PH6 2HA Comrie
    Perthshire
    Administrateur
    Ruchlinn
    Camp Road,
    PH6 2HA Comrie
    Perthshire
    ScotlandBritish85764980001
    BEVERIDGE, William John
    Drummoyne
    Kiltarlity
    IV4 7HT Beauly
    Inverness Shire
    Administrateur
    Drummoyne
    Kiltarlity
    IV4 7HT Beauly
    Inverness Shire
    British25882680001
    BLACKBURN, Peter
    4 Kinkell
    IV7 8HY Dingwall
    Highland
    Administrateur
    4 Kinkell
    IV7 8HY Dingwall
    Highland
    British25882700001
    CAMERON, Kenneth William
    121 Culduthel Road
    IV2 4EE Inverness
    Administrateur
    121 Culduthel Road
    IV2 4EE Inverness
    ScotlandBritish41410280001
    CAMERON, Neil Stuart
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    Administrateur
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    ScotlandBritish34848670001
    FRASER, George Gabriel
    7 Fairways
    Altonburn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    Administrateur
    7 Fairways
    Altonburn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    ScotlandBritish50219540001
    GRANT, Alexander James
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    British107801990001
    HARRISON, Peter John
    Washington House Viewfield Street
    IV12 4HW Nairn
    Administrateur
    Washington House Viewfield Street
    IV12 4HW Nairn
    British43281820001
    HENDERSON, John Brodie
    5 Drummond Place
    IV2 4JT Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    5 Drummond Place
    IV2 4JT Inverness
    Inverness Shire
    British69260990002
    HILDITCH, Alan Thomas
    3 Craighirst Road
    Milngavie
    G62 7RG Glasgow
    Scotland
    Administrateur
    3 Craighirst Road
    Milngavie
    G62 7RG Glasgow
    Scotland
    British75340740001
    JAMIESON, John Ian
    76 Airyhall Drive
    AB15 7QB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    76 Airyhall Drive
    AB15 7QB Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish68172620001
    LOWE, Grant Barrington
    Glaick Of Kessock
    North Kessock
    IV1 1XG Inverness
    Highland
    Scotland
    Administrateur
    Glaick Of Kessock
    North Kessock
    IV1 1XG Inverness
    Highland
    Scotland
    British49961400001
    MACFARLANE, John
    Riverside
    IV51 9HP Portree
    Isle Of Skye
    Administrateur
    Riverside
    IV51 9HP Portree
    Isle Of Skye
    ScotlandBritish411010001
    MACFARLANE, Neil John
    Rosebank
    Springfield
    IV51 9LX Portree
    Isle Of Skye
    Administrateur
    Rosebank
    Springfield
    IV51 9LX Portree
    Isle Of Skye
    British411020001
    MACKAY, John
    18 Cameron Road
    IV19 1NN Tain
    Ross Shire
    Administrateur
    18 Cameron Road
    IV19 1NN Tain
    Ross Shire
    United KingdomBritish68554680001
    MACKAY, William Thomas
    Strathmore Kilbryde Crescent
    FK15 9BB Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    Strathmore Kilbryde Crescent
    FK15 9BB Dunblane
    Perthshire
    United KingdomBritish31116810002
    MACKAY, William Thomas
    Strathmore Kilbryde Crescent
    FK15 9BB Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    Strathmore Kilbryde Crescent
    FK15 9BB Dunblane
    Perthshire
    United KingdomBritish31116810002
    MACKENZIE, Donald Henry
    Taighe-Na-Coille Dalgrambich
    Croy
    IV2 5PR Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    Taighe-Na-Coille Dalgrambich
    Croy
    IV2 5PR Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritish66483050001
    MACLEOD, Norman
    1 Glebe Lane
    Newton Mearns
    G77 6DS Glasgow
    Administrateur
    1 Glebe Lane
    Newton Mearns
    G77 6DS Glasgow
    British54906040001
    MACLEOD, Thomas
    4 Enrick Crescent
    Glenview, Drumnadrochit
    IV63 6TP Highland
    Administrateur
    4 Enrick Crescent
    Glenview, Drumnadrochit
    IV63 6TP Highland
    British94117610001
    MACMORRAN, James George Harley
    84 Myreside Road
    EH10 5BZ Edinburgh
    Administrateur
    84 Myreside Road
    EH10 5BZ Edinburgh
    British54477250001
    MARTIN, Ashley Graham
    Spencers Farm
    Whelpley Hill
    HP5 3RP Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Spencers Farm
    Whelpley Hill
    HP5 3RP Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish116805870001
    MCLEOD, William Lind
    32 Mansewood Road
    G43 1TN Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    32 Mansewood Road
    G43 1TN Glasgow
    Lanarkshire
    British37035550001
    MCMAHON, Michael
    3 Tinto Drive
    Balloch
    G68 9BF Cumbernauld
    Lanarkshire
    Administrateur
    3 Tinto Drive
    Balloch
    G68 9BF Cumbernauld
    Lanarkshire
    British102736560001
    MCMENAMIN, Joseph
    27 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6SB Glasgow
    Administrateur
    27 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6SB Glasgow
    British42344560001
    MEIKLE, Stewart Robert
    20 Belford Gardens
    EH4 3EW Edinburgh
    Administrateur
    20 Belford Gardens
    EH4 3EW Edinburgh
    ScotlandBritish70911700001
    PHILIP, David Fraser
    27 Wyvis Road
    IV12 5NR Nairn
    Morayshire
    Administrateur
    27 Wyvis Road
    IV12 5NR Nairn
    Morayshire
    British567450001

    TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 12 nov. 1997
    Livré le 19 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 nov. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 25 sept. 1996
    Livré le 04 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 oct. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 juil. 1994
    Livré le 17 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All and whole that roughly triangular shaped piece of ground at sluggans, dunvegan road,portree,isle of skye.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 17 août 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 10 nov. 1993
    Livré le 17 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 nov. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 22 mars 1990
    Livré le 05 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 29 nov. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    TULLOCH CONSTRUCTION GROUP LTD. a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 nov. 2012Dissolved on
    17 janv. 2012Petition date
    31 juil. 2012Conclusion of winding up
    17 janv. 2012Commencement of winding up
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0