DRYDENS FROZEN FOODS LIMITED

DRYDENS FROZEN FOODS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDRYDENS FROZEN FOODS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC062377
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DRYDENS FROZEN FOODS LIMITED ?

    • (5139) /

    Où se situe DRYDENS FROZEN FOODS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    24 Blythswood Square
    G2 4BG Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de DRYDENS FROZEN FOODS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 mars 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour DRYDENS FROZEN FOODS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Andrew Ramsden en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 14 déc. 2009

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    5 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 28 mars 2008

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    Comptes établis au 30 mars 2007

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de DRYDENS FROZEN FOODS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BURRELL, Jayne Katherine
    1 Moat Farm Court
    Pulford Lane Dodleston
    CH4 9NN Chester
    Cheshire
    Secrétaire
    1 Moat Farm Court
    Pulford Lane Dodleston
    CH4 9NN Chester
    Cheshire
    British99547650001
    DHALIWAL, Tarsem Singh
    Ruthin Road
    CH7 4AF Gwernymynydd
    Ty Coch
    Flintshire
    Administrateur
    Ruthin Road
    CH7 4AF Gwernymynydd
    Ty Coch
    Flintshire
    United KingdomBritish151680990001
    AGGARWAL, Amit
    27 St Mary's Mansions
    St Mary's Terrace
    W2 1SQ London
    Secrétaire
    27 St Mary's Mansions
    St Mary's Terrace
    W2 1SQ London
    British113667030001
    ATTWOOD, Paul Gerard
    12 Holborn Drive
    L39 3QL Ormskirk
    Lancashire
    Secrétaire
    12 Holborn Drive
    L39 3QL Ormskirk
    Lancashire
    British72538660001
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    68 Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    Secrétaire
    68 Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    British78255980001
    DRYDEN, Douglas Godfrey
    16 Allan Street
    DD1 3HH Dundee
    Angus
    Secrétaire
    16 Allan Street
    DD1 3HH Dundee
    Angus
    British15128280002
    GRAY, Elizabeth Lamont
    250 Coupar Angus Road
    DD2 5QN Dundee
    Tayside
    Secrétaire
    250 Coupar Angus Road
    DD2 5QN Dundee
    Tayside
    British47809000001
    MOOREHEAD, Simon Charles Wheeler
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British101873090001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    Secrétaire
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    British48949090001
    SHEARER, James Addison
    Heathfield 6 Oldfold Walk
    AB13 0JG Milltimber
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    Heathfield 6 Oldfold Walk
    AB13 0JG Milltimber
    Aberdeenshire
    British61887100001
    SF SECRETARIES LIMITED
    80 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    80 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Midlothian
    101875740003
    BERRY, John Graham
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Administrateur
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    WalesBritish10711650001
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    Administrateur
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    United KingdomBritish135246350001
    CROWE, William
    16 Lochinver Crescent
    DD2 4UG Dundee
    Angus
    Administrateur
    16 Lochinver Crescent
    DD2 4UG Dundee
    Angus
    British698700002
    DRYDEN, Douglas Godfrey
    Smeaton Road
    Wester Gourdie Ind Estate
    DD2 4UT Dundee
    Administrateur
    Smeaton Road
    Wester Gourdie Ind Estate
    DD2 4UT Dundee
    British15128280003
    DRYDEN, Douglas Scott
    Jakers Acre
    Losset Road
    PH11 8BU Alyth
    Perthshire
    Scotland
    Administrateur
    Jakers Acre
    Losset Road
    PH11 8BU Alyth
    Perthshire
    Scotland
    British698680002
    DRYDEN, Elizabeth Boyd Donalson
    4 Shorehead
    KY16 9RG St Andrews
    Fife
    Administrateur
    4 Shorehead
    KY16 9RG St Andrews
    Fife
    British698690001
    GRAY, Elizabeth Lamont
    250 Coupar Angus Road
    DD2 5QN Dundee
    Tayside
    Administrateur
    250 Coupar Angus Road
    DD2 5QN Dundee
    Tayside
    British47809000001
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    HOWARTH, David
    Cherry Bank
    Church Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EW Chester
    Cheshire
    Administrateur
    Cherry Bank
    Church Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EW Chester
    Cheshire
    British107155000001
    HUSTAD, Hans Kristian
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Administrateur
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Norwegian103594230001
    HYSLOP, Edward James
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritish127371260001
    HYSLOP, Edward James
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritish127371260001
    MILNE, Peter Gordon
    17 Hatton View
    PH2 7DA Perth
    Administrateur
    17 Hatton View
    PH2 7DA Perth
    British49203360001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    Administrateur
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    United KingdomBritish48949090001
    PRITCHARD, Andrew Simon
    Kidnal Grange
    Kidnal
    SY14 7DJ Malpas
    Cheshire
    Administrateur
    Kidnal Grange
    Kidnal
    SY14 7DJ Malpas
    Cheshire
    United KingdomBritish42467790003
    RAMSDEN, Andrew Nicholas
    The Farmhouse
    Wood Lea Farm Shepley
    HD8 8ES Huddersfield
    Administrateur
    The Farmhouse
    Wood Lea Farm Shepley
    HD8 8ES Huddersfield
    EnglandBritish122765080001
    THAIN, John Robert
    38 Corse Wynd
    Kingswells
    AB15 8TP Aberdeen
    Administrateur
    38 Corse Wynd
    Kingswells
    AB15 8TP Aberdeen
    5813510002
    WOODWARD, Jeremy Alan
    Troon House Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Clwyd
    Administrateur
    Troon House Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Clwyd
    United KingdomBritish57016650004
    WOODWARD, Jeremy Alan
    Troon House Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Clwyd
    Administrateur
    Troon House Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Clwyd
    United KingdomBritish57016650004

    DRYDENS FROZEN FOODS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 30 mars 1992
    Livré le 17 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Tayside Regional Council
    Transactions
    • 17 avr. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 déc. 1990
    Livré le 21 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.5 acres of ground in dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 12 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 nov. 1983
    Livré le 06 déc. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground in the seagate in dundee, angus.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 déc. 1983Enregistrement d'une charge
    • 12 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 15 avr. 1983
    Livré le 05 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 mai 1983Enregistrement d'une charge
    • 17 avr. 1992Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 12 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 20 févr. 1981
    Livré le 05 mars 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 mars 1981Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0