CALA PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCALA PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC062671
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CALA PROPERTIES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CALA PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CALA PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CALA PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED31 déc. 198531 déc. 1985
    CALA PROPERTIES LIMITED06 juil. 197706 juil. 1977

    Quels sont les derniers comptes de CALA PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour CALA PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    9 pages4.26(Scot)

    Satisfaction de la charge SC0626710014 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0626710015 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de John Graham Gunn Reid en tant que directeur le 07 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan Duke Brown en tant que directeur le 07 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 01 juin 2016

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Robert James Millar en tant que directeur le 11 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 déc. 2015

    État du capital au 04 déc. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015

    4 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 nov. 2014

    État du capital au 11 nov. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    5 pagesAA

    Inscription de la charge 0626710014

    32 pagesMR01

    Inscription de la charge 0626710015

    30 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 nov. 2013

    État du capital au 13 nov. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012

    5 pagesAA

    legacy

    8 pagesMG01s

    legacy

    8 pagesMG01s

    Qui sont les dirigeants de CALA PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEDGE SERVICES LIMITED
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Secrétaire
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    42504200004
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Secrétaire
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    73896680003
    AITKEN, Keith
    46 Rhodes Park
    EH39 5NA North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    46 Rhodes Park
    EH39 5NA North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish141684340001
    BALL, Geoffrey Arthur
    Champunzie
    26 Hermitage Drive
    EH10 6BY Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Champunzie
    26 Hermitage Drive
    EH10 6BY Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish246030002
    BALL, Geoffrey Arthur
    Hollywood 34 Colinton Road
    EH10 5DG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Hollywood 34 Colinton Road
    EH10 5DG Edinburgh
    Midlothian
    British246030001
    BROPHY, John Francis
    St Ronans Terrace
    Innerleithen
    EH44 6RB Tweeddale
    38
    Administrateur
    St Ronans Terrace
    Innerleithen
    EH44 6RB Tweeddale
    38
    United KingdomBritish133189190001
    BROWN, Alan Duke
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Administrateur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    EnglandBritish32640750005
    DEVINE, Paul John
    Little Garth 33 Marmion Road
    EH39 4PF North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Little Garth 33 Marmion Road
    EH39 4PF North Berwick
    East Lothian
    British43368870002
    DICK, Robert John Westwater
    Grant Avenue
    EH13 0DS Edinburgh
    8
    Administrateur
    Grant Avenue
    EH13 0DS Edinburgh
    8
    UkBritish138046660001
    DICK, Robert John Westwater
    5 Wester Coates Terrace
    EH12 5LR Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 Wester Coates Terrace
    EH12 5LR Edinburgh
    Midlothian
    British246770001
    HANNA, Ronald George
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish8506940001
    KELLEY, Anthony John
    Broadlands
    27 Ralliwood Road
    KT21 1DD Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    Broadlands
    27 Ralliwood Road
    KT21 1DD Ashtead
    Surrey
    British34076900001
    KNIGHT, Alan Kenneth
    Kelford
    12 Chapel Street
    DY 0NL West Hagley
    Worcestershire
    Administrateur
    Kelford
    12 Chapel Street
    DY 0NL West Hagley
    Worcestershire
    British77274710001
    MACCONNELL, Alasdair Murray
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Administrateur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    ScotlandBritish54405740002
    MACKAY, Donald Stewart
    Barnshalloch 30 Gillespie Road
    EH13 0NN Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    Barnshalloch 30 Gillespie Road
    EH13 0NN Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British246760001
    MCKINLAY, Andrew David
    29 Mid Steil
    EH10 5XB Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    29 Mid Steil
    EH10 5XB Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish86545310001
    MILLAR, Robert James
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Administrateur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    United KingdomBritish3211980007
    MORE, Gerry Campbell
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Administrateur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    ScotlandBritish177944940001
    NAYSMITH, Karen Linda
    28 Ashburnham Gardens
    EH30 9LB South Queensferry
    West Lothian
    Administrateur
    28 Ashburnham Gardens
    EH30 9LB South Queensferry
    West Lothian
    United KingdomBritish178861820001
    NAYSMITH, Karen Linda
    78 South Trinity Road
    EH5 3PW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    78 South Trinity Road
    EH5 3PW Edinburgh
    Midlothian
    British102349010001
    REID, David Ian
    Orsaig 10 Greenlaw Drive
    PA1 3RU Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    Orsaig 10 Greenlaw Drive
    PA1 3RU Paisley
    Renfrewshire
    British770870001
    REID, John Graham Gunn
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Administrateur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    ScotlandBritish54537790003
    ROSS, James Morgan
    5 Mayfield Road
    EH9 2NG Edinburgh
    Administrateur
    5 Mayfield Road
    EH9 2NG Edinburgh
    British54405640001

    CALA PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 18 déc. 2013
    Livré le 24 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Senior Creditors (As Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01).
    Transactions
    • 24 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 21 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 18 déc. 2013
    Livré le 24 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Senior Creditors (As Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01).
    Transactions
    • 24 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 21 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    English deed of confirmation
    Créé le 18 mars 2013
    Livré le 22 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The company irrevocably and unconditionally confirms that the security documents remain in full force. See form for further details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 21 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Scottish deed of confirmation
    Créé le 18 mars 2013
    Livré le 22 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The company irrevocably and unconditionally confirms that the security documents remain in full force. See form for further details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 21 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 29 juin 2010
    Livré le 07 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 01 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 2009
    Livré le 23 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 01 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 21 déc. 2009
    Livré le 23 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 21 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 14 déc. 1999
    Livré le 29 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 déc. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 19 janv. 1984
    Livré le 03 févr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All and whole area of ground baillieswells rd baldside aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank LTD
    Transactions
    • 03 févr. 1984Enregistrement d'une charge
    • 10 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Equitable charge
    Créé le 15 déc. 1981
    Livré le 05 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land adjoining sovereign way, tonbridge, kent.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank LTD
    Transactions
    • 05 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    • 16 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 24 déc. 1980
    Livré le 06 janv. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    21 carden place aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 06 janv. 1981Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 24 déc. 1980
    Livré le 06 janv. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    48 queen's road aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 06 janv. 1981Enregistrement d'une charge
    • 29 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 févr. 1980
    Livré le 19 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Office premises at 5 albyn terrace, aberdeen, in the county of aberdeen with the sdum thereof and ground attached.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 19 févr. 1980Enregistrement d'une charge

    CALA PROPERTIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 juin 2016Commencement of winding up
    19 déc. 2017Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0