SEAENERGY PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSEAENERGY PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société SC062845
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SEAENERGY PLC ?

    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication

    Où se situe SEAENERGY PLC ?

    Adresse du siège social
    c/o KPMG LLP
    37 Albyn Place
    AB10 1JB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SEAENERGY PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RAMCO ENERGY PLC01 juil. 199401 juil. 1994
    RAMCO OIL SERVICES PLC05 août 197705 août 1977

    Quels sont les derniers comptes de SEAENERGY PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour SEAENERGY PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Ordonnance du tribunal

    Order of court - dissolution void
    1 pagesOC-DV

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de passage de l'administration à la dissolution

    22 pages2.26B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    22 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    19 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    21 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    24 pages2.20B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.13B(Scot)

    36 pages2.15B(Scot)

    Proposition réputée de l'administrateur

    1 pages2.16BZ(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    35 pages2.16B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Britannia House Endeavour Drive Arnhall Business Park Westhill Aberdeenshire AB32 6UF à C/O Kpmg Llp 37 Albyn Place Aberdeen Aberdeenshire AB10 1JB le 17 juin 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC0628450008

    29 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC0628450007

    29 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC0628450006

    31 pages466(Scot)

    Inscription de la charge SC0628450008, créée le 24 nov. 2015

    17 pagesMR01

    Inscription de la charge SC0628450007, créée le 24 nov. 2015

    17 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 mai 2015 sans liste des membres

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 juin 2015

    État du capital au 12 juin 2015

    • Capital: GBP 5,636,482.3
    SH01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2014

    62 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11

    Cessation de la nomination de Michael Brendan Comerford en tant que directeur le 06 févr. 2015

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge SC0628450006, créée le 10 juil. 2014

    19 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de SEAENERGY PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BERTRAM, Steven
    Endeavour Drive
    Arnhall Business Park
    AB32 6UF Aberdeen
    Britainia House
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Endeavour Drive
    Arnhall Business Park
    AB32 6UF Aberdeen
    Britainia House
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    British179346360001
    ALDERSEY-WILLIAMS, John Hosmer
    Endeavour Drive, Arnhall Business Park
    Westhill
    AB32 6UF Aberdeenshire
    Brittania House
    Grampian
    Administrateur
    Endeavour Drive, Arnhall Business Park
    Westhill
    AB32 6UF Aberdeenshire
    Brittania House
    Grampian
    ScotlandBritish78544470001
    BERTRAM, Steven Ross
    Abergeldie Road
    AB10 6ED Aberdeen
    41
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Abergeldie Road
    AB10 6ED Aberdeen
    41
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish1133580007
    LAING, David Kemlo
    Endeavor Drive
    Arnhall Business Park
    AB32 6UF Westhill
    Britannia House
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Endeavor Drive
    Arnhall Business Park
    AB32 6UF Westhill
    Britannia House
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish1372980011
    LAMPE, Steven George
    Apartment 10 F
    40 East 88th Street
    NY 10128 New York
    United States
    Administrateur
    Apartment 10 F
    40 East 88th Street
    NY 10128 New York
    United States
    United StatesAmerican124939520001
    SIGSWORTH, David, Prof.
    9 Station Road
    EH30 9HY South Queensferry
    West Lothian
    Administrateur
    9 Station Road
    EH30 9HY South Queensferry
    West Lothian
    United KingdomBritish4582280001
    BERTRAM, Steven
    41 Hamilton Place
    AB15 4AX Aberdeen
    Secrétaire
    41 Hamilton Place
    AB15 4AX Aberdeen
    British1133580002
    MOAR, Christopher Gilbert
    11 Fintray Road
    AB15 8HL Aberdeen
    Secrétaire
    11 Fintray Road
    AB15 8HL Aberdeen
    British39099740002
    R & R URQUHART
    121 High Street
    IV36 1AB Forres
    Morayshire
    Secrétaire
    121 High Street
    IV36 1AB Forres
    Morayshire
    38270001
    BAXTER, Normile Elliot
    House Of Aquahorities
    Inverurie
    Aberdeenshire
    Administrateur
    House Of Aquahorities
    Inverurie
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish38280001
    BOYLE, David Thomas Alan
    Fairstead Hall
    Fairstead Hall Road, Fairstead
    CM3 2AT Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Fairstead Hall
    Fairstead Hall Road, Fairstead
    CM3 2AT Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish90334420001
    BURCHELL, Michael Norman
    Aventine Downs Lane
    KT22 8JW Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Aventine Downs Lane
    KT22 8JW Leatherhead
    Surrey
    British41531410001
    COMERFORD, Michael Brendan
    Endeavour Drive
    Arnhall Business Park
    AB32 6UF Westhill
    Britannia House
    Aberdeenshire
    Scotland
    Administrateur
    Endeavour Drive
    Arnhall Business Park
    AB32 6UF Westhill
    Britannia House
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritish57843660001
    CUMMING, Norman Stewart
    21 Kings Gate
    AB15 4EL Aberdeen
    Scotland
    Administrateur
    21 Kings Gate
    AB15 4EL Aberdeen
    Scotland
    United KingdomBritish36540003
    DENTON, Herbert Anderson
    48 West 86th Street No 4
    New York
    FOREIGN New York 10024
    Usa
    Administrateur
    48 West 86th Street No 4
    New York
    FOREIGN New York 10024
    Usa
    American30427230001
    EVERETT, Peter
    Cluain
    Castleton Road
    PH3 1JW Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    Cluain
    Castleton Road
    PH3 1JW Auchterarder
    Perthshire
    British17567290001
    GROVES GIDNEY, Mark Nicholas
    Vine Cottage
    Church Road Kilndown
    TN17 2RU Cranbrook
    Kent
    Administrateur
    Vine Cottage
    Church Road Kilndown
    TN17 2RU Cranbrook
    Kent
    British122705590001
    HARRISON, Iain Victor Robinson
    Craighat
    Killearn
    G63 9QL Glasgow
    Administrateur
    Craighat
    Killearn
    G63 9QL Glasgow
    ScotlandBritish38290001
    HAY, Malcolm Charles
    Glass
    AB54 4XD Huntly
    Edinglassie
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Glass
    AB54 4XD Huntly
    Edinglassie
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish132935630001
    LALL, Vikram
    Newmains House
    EH39 5BL Drem
    East Lothian
    Administrateur
    Newmains House
    EH39 5BL Drem
    East Lothian
    United KingdomBritish38750001
    MOAR, Christopher Gilbert
    11 Fintray Road
    AB15 8HL Aberdeen
    Administrateur
    11 Fintray Road
    AB15 8HL Aberdeen
    ScotlandBritish39099740002
    PATERSON, Dennis Michael
    Prior House
    19 Ethorpe Close
    SL9 8PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Prior House
    19 Ethorpe Close
    SL9 8PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandCanadian105390630001
    REMP, Stephen Edward
    Kirklands Of Cluny
    AB51 7RS Sauchen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Kirklands Of Cluny
    AB51 7RS Sauchen
    Aberdeenshire
    ScotlandAmerican112388710001
    RIFKIND, Malcolm Leslie, Sir
    Eskgrove House
    Inveresk
    EH21 7TD Musselburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Eskgrove House
    Inveresk
    EH21 7TD Musselburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish57730880001
    SEYMOUR, Michael Denys
    The Old School House High Street
    Streatley
    RG8 9JD Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Old School House High Street
    Streatley
    RG8 9JD Reading
    Berkshire
    EnglandBritish44883120002
    STAADECKER, Joel Bonnar
    Elm Park Road
    SW3 6AU London
    1,60
    Administrateur
    Elm Park Road
    SW3 6AU London
    1,60
    United KingdomAmerican131505730001
    STOVER, Daniel Frederick
    Auchnagathle House
    AB33 8BQ Keig
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Auchnagathle House
    AB33 8BQ Keig
    Aberdeenshire
    United KingdomAmerican76919110004
    WHITTLE, Colin Douglas Richardson
    121 High Street
    IV36 1AB Forres
    Administrateur
    121 High Street
    IV36 1AB Forres
    United KingdomBritish536270001
    ZELL, Samuel
    161 East Chicago Avenue
    60611 Chicago
    Illinois
    Usa
    Administrateur
    161 East Chicago Avenue
    60611 Chicago
    Illinois
    Usa
    British48807800002

    SEAENERGY PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 24 nov. 2015
    Livré le 01 déc. 2015
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Davies Newman Property Limited
    Transactions
    • 01 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 déc. 2015Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 24 nov. 2015
    Livré le 01 déc. 2015
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lc Capital Master Fund, LTD
    Transactions
    • 01 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 déc. 2015Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 10 juil. 2014
    Livré le 15 juil. 2014
    En cours
    Brève description
    A floating charge over all assets and undertaking.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 déc. 2015Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 11 avr. 2003
    Livré le 25 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 avr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 sept. 1992
    Livré le 30 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground extending to 14.5 acres at part of badentoy industrial estate, portlethen, kincardine as relative to disposition by g & j investments (aberdeen) limited in favour of ramco oil services PLC.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 30 sept. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 17 janv. 1978
    Livré le 25 nov. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    4.22 acres at athens industrial estate aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 25 nov. 1978Enregistrement d'une charge
    • 02 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 01 nov. 1977
    Livré le 11 nov. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 11 nov. 1977Enregistrement d'une charge
    • 09 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 15 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    SEAENERGY PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    2
    DateType
    02 juin 2016Administration started
    31 mai 2018Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Blair Carnegie Nimmo
    37 Albyn Place
    Aberdeen
    AB10 1JB
    practitioner
    37 Albyn Place
    Aberdeen
    AB10 1JB
    Geoffrey Isaac Jacobs
    1 Marischal Square
    Broad Street
    AB10 1DD Aberdeen
    practitioner
    1 Marischal Square
    Broad Street
    AB10 1DD Aberdeen
    Gerard Anthony Friar
    37 Albyn Place
    AB10 1JB Aberdeen
    practitioner
    37 Albyn Place
    AB10 1JB Aberdeen

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0