ORKNEY COACHES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ORKNEY COACHES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC062985 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ORKNEY COACHES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Perthshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ORKNEY COACHES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 avr. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ORKNEY COACHES LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour ORKNEY COACHES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Steven Walker en tant que directeur le 15 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Montgomery en tant que directeur le 15 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Gervase Andrew en tant que directeur le 15 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Samuel Derek Greer en tant que directeur le 15 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 avr. 2014 | 24 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Samuel Derek Greer le 09 juin 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael John Vaux le 20 mars 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 avr. 2013 | 23 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Leslie Warneford en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires | 10 pages | AR01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Steven Walker le 19 sept. 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 avr. 2012 | 25 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Samuel Derek Greer le 19 mars 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires | 10 pages | AR01 | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | MG03s | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 avr. 2011 | 23 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 7 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de ORKNEY COACHES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUX, Michael John | Secrétaire | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | British | 137383880001 | ||||||
| BROWN, Colin | Administrateur | Dunkeld Road PH1 5TW Perth 10 Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | 85970020003 | |||||
| VAUX, Michael John | Administrateur | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire | United Kingdom | British | 137383880003 | |||||
| LORNIE, John Derek | Secrétaire | 11 Drumsmittal Road North Kessock IV1 3JU Inverness Inverness Shire | British | 1294630004 | ||||||
| MITCHELL, Warren Stanley | Secrétaire | Marren Highfield Park Conon Bridge IV7 8AP Dingwall Ross Shire | British | 208140002 | ||||||
| WHITNALL, Alan Leonard | Secrétaire | 25 Millhill Drive Greenloaning FK15 0LS Dunblane Perthshire | British | 54184420002 | ||||||
| YOUNG, Alan | Secrétaire | Broch House,Upper Scalloway Scalloway ZE1 0UP Shetland | British | 5096340003 | ||||||
| LEDINGHAM CHALMERS | Secrétaire | Kintail House Beechwood Business Park IV2 3BW Inverness | 84459760001 | |||||||
| LEDINGHAM CHALMERS LLP | Secrétaire | Johnstone House 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen | 112938080001 | |||||||
| ANDREW, Robert Gervase | Administrateur | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire | United Kingdom | British | 54172700004 | |||||
| GREER, Samuel Derek | Administrateur | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire | United Kingdom | British | 140386230006 | |||||
| LORNIE, John Derek | Administrateur | 11 Drumsmittal Road North Kessock IV1 3JU Inverness Inverness Shire | British | 1294630004 | ||||||
| MACDONALD, William Alasdair | Administrateur | 13 Kestrel Place IV2 3YH Inverness Highland | British | 63115140001 | ||||||
| MONTGOMERY, Robert | Administrateur | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire | United Kingdom | British | 122403240002 | |||||
| MORRISON, Andrew George Scott | Administrateur | Dykes Wormadale Whiteness ZE2 9LJ Shetland Isle Of Shetland | Scotland | British | 684730001 | |||||
| RAPSON, Alexander Henderson | Administrateur | Bannockburn House 34a Bellfield Road IV1 3XU North Kessock Inverness | Scotland | British | 79523200001 | |||||
| RAPSON, Freda Mae | Administrateur | Drumdevan Lodge Torbreck IV2 6DJ Inverness | British | 53142150003 | ||||||
| RENILSON, Neil John | Administrateur | Flat 7 7 High Riggs EH3 9BW Edinburgh | British | 42889750002 | ||||||
| SHARP, Gilbert William | Administrateur | Valendale Cauldhame, Trondra ZE1 0XL Scalloway Shetland | British | 74125370001 | ||||||
| WALKER, Steven | Administrateur | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire | United Kingdom | British | 134753580002 | |||||
| WARNEFORD, Leslie Brian | Administrateur | Dunkeld Road PH1 5TW Perth 10 Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | 49771140004 | |||||
| YOUNG, Alan | Administrateur | Broch House,Upper Scalloway Scalloway ZE1 0UP Shetland | British | 5096340003 |
ORKNEY COACHES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Créé le 11 oct. 1999 Livré le 15 oct. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 19 juil. 1993 Livré le 03 août 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Area of ground at strip, brae, shetland islands area, zetland as relative to disposition by rubina sutherland in fovour of shalder coaches limited. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 23 févr. 1989 Livré le 06 mars 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Area of land at swinister, sandwick, shetland including garage & other buildings. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 26 mai 1986 Livré le 09 juin 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti £42,500 | |
Brèves mentions 2055 square metres at garson industrial estate, stromness and county of orkney. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 14 déc. 1984 Livré le 24 déc. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Ground and garage property thereon at lower scord, utnabrake, near scalloway, shetland. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 23 juil. 1984 Livré le 27 juil. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 04 juin 1984 Livré le 22 juin 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Ground at utnabrake, near scalloway, shetland. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 05 juil. 1979 Livré le 13 juil. 1979 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Garages at gibblestoner road, scalloway, shetland. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 09 mai 1978 Livré le 26 mai 1978 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0