CAPE CLADDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CAPE CLADDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC063029 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CAPE CLADDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | KPMG RESTRUCTURING Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CAPE CLADDINGS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour CAPE CLADDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rachel Nancye Amey en tant que directeur le 08 mars 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire | 3 pages | 4.26(Scot) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2 Blythswood Square Glasgow G2 4AD le 09 oct. 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Dépôt d'insolvabilité INSOLVENCY:Form 600 Notice of Appointment of Liquidator | 1 pages | LIQ MISC | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Christopher Francis Judd en tant que secrétaire le 23 mai 2012 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jeremy Philip Gorman en tant que secrétaire le 23 mai 2012 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 1 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lucy Turner en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Jeremy Philip Gorman en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Rachel Nancye Carr le 01 déc. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 1 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 16 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Lucy Finch Turner le 23 déc. 2009 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Victoria Anne George le 18 déc. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Rachel Nancye Carr le 18 déc. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2007 | 1 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CAPE CLADDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUDD, Christopher Francis | Secrétaire | Millenia Tower One Temasek Avenue 039192 Singapore #09-03 Singapore | 169521610001 | |||||||
| GEORGE, Victoria Anne | Administrateur | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 134024500001 | |||||
| CRAIGIE, Claire Louise | Secrétaire | 15 Marlborough Square LS29 8PU Ilkley West Yorkshire | British | 82905830001 | ||||||
| GORMAN, Jeremy Philip | Secrétaire | 2 Blythswood Square Glasgow G2 4AD | 160675450001 | |||||||
| PITT-PAYNE, Michael George | Secrétaire | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | British | 829660002 | ||||||
| RHODES, Jeremy | Secrétaire | Grevel Lane GL55 6HS Chipping Campden Kelmscott Gloucestershire | British | 129206660001 | ||||||
| SMITH, Stephen Harry | Secrétaire | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | 64449570001 | ||||||
| TURNER, Lucy Finch | Secrétaire | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | British | 133976740001 | ||||||
| WHITWORTH, Benjamin Warwick | Secrétaire | Raskelf YO61 3LW York Sam House Farm | British | 99402260002 | ||||||
| AMEY, Rachel Nancye | Administrateur | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 133976650005 | |||||
| ASHCROFT, Anthony | Administrateur | The Long House Great Addington NN14 4BA Kettering Northamptonshire | British | 31111580001 | ||||||
| BINGHAM, Richard Keith | Administrateur | Church Road Brasted TN16 1HZ Westerham Beechcroft Kent | British | 131046090001 | ||||||
| CARTWRIGHT, Paul Ian | Administrateur | 195 Highbury Quadrant N5 2TE London | British | 40873830002 | ||||||
| CRAIGIE, Claire Louise | Administrateur | 15 Marlborough Square LS29 8PU Ilkley West Yorkshire | British | 82905830001 | ||||||
| FARRELL, John Patrick | Administrateur | Broadcroft Little Hallingbury CM22 7RT Bishops Stortford Herts | United Kingdom | British | 702300001 | |||||
| GILLESPIE, Andrew James | Administrateur | 5 White Moss Close Ackworth WF7 7QT Pontefract West Yorkshire | England | British | 89560440001 | |||||
| HOPWOOD, Geoffrey Alan | Administrateur | 22 Blackpot Lane Oundle Peterborough | British | 829710001 | ||||||
| JACKSON, Francis Keith John | Administrateur | The Artists House Station Road Goring On Thames RG8 9HA Reading Berkshire | England | British | 15469790001 | |||||
| MCKAIN, Thomas Morrison | Administrateur | Horseshoe Ridge St George's Hill Weybridge Surrey | British | 829670001 | ||||||
| MOSCROP, Anthony | Administrateur | 17 Brook Court Horton NN7 2BL Northampton Northamptonshire | British | 829680001 | ||||||
| PITT-PAYNE, Michael George | Administrateur | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 829660002 | |||||
| SMITH, Stephen Harry | Administrateur | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | 64449570001 | ||||||
| SPARKES, John Leslie | Administrateur | High House Bell Hill Lamarsh CO8 5EP Bures Suffolk | United Kingdom | British | 1291070001 | |||||
| WHITWORTH, Benjamin Warwick | Administrateur | Raskelf YO61 3LW York Sam House Farm | England | British | 99402260002 | |||||
| WIDDOWSON, Ian Richard | Administrateur | 49 Eghams Wood Road HP9 1JX Beaconsfield Buckinghamshire | British | 16941000001 | ||||||
| CAPE CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Administrateur | Red Hall Avenue WF1 2UL Wakefield Cape House, 3 West Yorkshire United Kingdom | 131421100001 |
CAPE CLADDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Créé le 20 juil. 2001 Livré le 03 août 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over all real property; fixed charges over assets; floating charge over same. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 18 juil. 2001 Livré le 03 août 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 27 nov. 1985 Livré le 17 déc. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 15 oct. 1985 Livré le 21 oct. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due by the company and others | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 29 janv. 1985 Livré le 14 févr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All securities or other property of the company held by any of the banks whether for safe custody or otherwise. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 29 janv. 1985 Livré le 14 févr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All rights, moneys or property accruing, all stocks, shares and other securities belonging to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 29 janv. 1985 Livré le 14 févr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Any financial obligation to or any sum held, received or receivable on behalf of the company by any of the banks. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 29 janv. 1985 Livré le 14 févr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All book debts and other debts due or owing to the company at the date of debenture. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 29 janv. 1985 Livré le 14 févr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Present and future goodwill of the company and the benefit of any licences, trade marks, copyrights, designs and other intellectual property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 29 janv. 1985 Livré le 14 févr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 29 janv. 1985 Livré le 14 févr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All estates or interests in any freehold and leasehold property together with all fixtures and fittings. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
CAPE CLADDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0