OFFSHORE DESIGN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOFFSHORE DESIGN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC063080
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OFFSHORE DESIGN LIMITED ?

    • Activités de soutien à l'extraction de pétrole et de gaz naturel (09100) / Exploitation de mines et carrières

    Où se situe OFFSHORE DESIGN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o WOOD GROUP
    15 Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de OFFSHORE DESIGN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour OFFSHORE DESIGN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Revocation of resolution passed on 16 oct 2019. dividend in specie on the ordinary shares. 19/11/2019
    RES13

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    État du capital au 16 oct. 2019

    • Capital: GBP 1.00
    5 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    legacy

    2 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Dividend in specie/be declared and the dividend will be paid on such date as the directors of the company may determine 16/10/2019
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    24 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 janv. 2016

    État du capital au 13 janv. 2016

    • Capital: GBP 25,500
    SH01

    Nomination de Mr Iain Angus Jones en tant que secrétaire le 18 déc. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Robert Muirhead Birnie Brown en tant que secrétaire le 18 déc. 2015

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de John Wood House, Greenwell Road East Tullos Industrial Estate Aberdeen AB12 3AX à C/O Wood Group 15 Justice Mill Lane Aberdeen AB11 6EQ le 01 sept. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    25 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 janv. 2015

    État du capital au 05 janv. 2015

    • Capital: GBP 25,500
    SH01

    Nomination de Mr Patrick Charles Delany en tant qu'administrateur le 17 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Docherty en tant que directeur le 17 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    25 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 déc. 2013

    État du capital au 31 déc. 2013

    • Capital: GBP 25,500
    SH01

    Qui sont les dirigeants de OFFSHORE DESIGN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JONES, Iain Angus
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Secrétaire
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    203975450001
    BROWN, George Alexander
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Administrateur
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    ScotlandBritish108641360001
    DELANY, Patrick Charles
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Administrateur
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    ScotlandBritish46157950001
    BROWN, Robert Muirhead Birnie
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Secrétaire
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    153900870001
    CASHER, James Thomas
    25 Albert Terrace
    AB10 1XY Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    25 Albert Terrace
    AB10 1XY Aberdeen
    Aberdeenshire
    British23380004
    JOHNSON, Ian
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    Secrétaire
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    British102664100004
    MCGREGOR, David
    4 Rowan Tree Road
    AB31 5NT Banchory
    Kincardineshire
    Secrétaire
    4 Rowan Tree Road
    AB31 5NT Banchory
    Kincardineshire
    British74860210003
    IAIN SMITH & COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Secrétaire désigné
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    900000570001
    BLACKWOOD, Derek Stuart
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    Administrateur
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    United StatesBritish37448730003
    BROWN, Charles Nicholas
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    Administrateur
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    ScotlandBritish36752260001
    CASHER, James Thomas
    25 Albert Terrace
    AB10 1XY Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    25 Albert Terrace
    AB10 1XY Aberdeen
    Aberdeenshire
    British23380004
    COCHRANE, William
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    Administrateur
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    UsaBritish152873520001
    DOCHERTY, Mark William
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    Administrateur
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    ScotlandBritish171301960001
    GLASS, Kathleen Lesley Anne
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    Administrateur
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    ScotlandBritish136071360001
    HOGG, Alan Cecil
    16 Middleton Crescent
    Bridge Of Don
    AB22 8HY Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    16 Middleton Crescent
    Bridge Of Don
    AB22 8HY Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish105030340001
    JOY, Ian Sclater
    Bridgefield House
    64 Balgownie Road, Bridge Of Don
    AB23 8JR Aberdeen
    Administrateur
    Bridgefield House
    64 Balgownie Road, Bridge Of Don
    AB23 8JR Aberdeen
    ScotlandUnited Kingdom102821890002
    LEVETT-PRINSEP, Graham Rodney
    2702 Autumn Lake Drive
    77450 Katy
    Texas
    United States
    Administrateur
    2702 Autumn Lake Drive
    77450 Katy
    Texas
    United States
    UsaAmerican111919750001
    MATHER, Ivan Andrew
    21 Inveralmond Drive
    EH4 6JX Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    21 Inveralmond Drive
    EH4 6JX Edinburgh
    Midlothian
    British23400001
    MCGREGOR, David
    4 Rowan Tree Road
    AB31 5NT Banchory
    Kincardineshire
    Administrateur
    4 Rowan Tree Road
    AB31 5NT Banchory
    Kincardineshire
    British74860210003
    MURRAY, Ian James
    Fairways
    St Eunans Road
    AB34 5HH Aboyne
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Fairways
    St Eunans Road
    AB34 5HH Aboyne
    Aberdeenshire
    British308510001
    RASMUSSEN, Alan Lee
    6443 Old Hickory Street
    Katy
    Texas
    77449
    Administrateur
    6443 Old Hickory Street
    Katy
    Texas
    77449
    American105030840001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur OFFSHORE DESIGN LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wood Group Engineering & Operations Support Limited
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    06 avr. 2016
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegster Of Companies In Scotland
    Numéro d'enregistrementSc159149
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    OFFSHORE DESIGN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 07 mars 2001
    Livré le 09 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 mars 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 16 juin 1982
    Livré le 06 juil. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 juil. 1982Enregistrement d'une charge
    • 30 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0