PARK'S OF HAMILTON (CROFTHEAD GARAGE) LIMITED

PARK'S OF HAMILTON (CROFTHEAD GARAGE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPARK'S OF HAMILTON (CROFTHEAD GARAGE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC063779
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PARK'S OF HAMILTON (CROFTHEAD GARAGE) LIMITED ?

    • Vente de voitures neuves et de véhicules légers (45111) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe PARK'S OF HAMILTON (CROFTHEAD GARAGE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PARK'S OF HAMILTON (CROFTHEAD GARAGE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour PARK'S OF HAMILTON (CROFTHEAD GARAGE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 10 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2018

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Alasdair George Noble en tant qu'administrateur le 17 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gerard Donnachie en tant que directeur le 03 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2017

    12 pagesAA

    Nomination de Mr Alasdair George Noble en tant que secrétaire le 06 oct. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Gerard Donnachie en tant que secrétaire le 06 oct. 2017

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 10 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juin 2016

    État du capital au 16 juin 2016

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Nomination de Mr Graeme Thomas Park en tant qu'administrateur le 01 nov. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Douglas Ireland Park en tant qu'administrateur le 01 nov. 2015

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    11 pagesAA

    Cessation de la nomination de Douglas Ireland Park en tant que directeur le 23 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 juil. 2015

    État du capital au 07 juil. 2015

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 juin 2014

    État du capital au 10 juin 2014

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de PARK'S OF HAMILTON (CROFTHEAD GARAGE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NOBLE, Alasdair George
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    Secrétaire
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    238722190001
    BRYCE, Alexander Stewart
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    United KingdomBritish150803460001
    CUMMING, William
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    ScotlandBritish112830750002
    MACKAY, Ian Barron
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    ScotlandBritish406430001
    NOBLE, Alasdair George
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    ScotlandBritish240301140001
    PARK, Douglas Ireland
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    SwitzerlandBritish202387330001
    PARK, Graeme Thomas
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    ScotlandBritish172685990001
    PARK, Ross William
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    ScotlandBritish93072080001
    DONNACHIE, Gerard
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    Secrétaire
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    British602380003
    BROWN, Steve
    8 Snead View
    ML1 5GL Motherwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    8 Snead View
    ML1 5GL Motherwell
    Lanarkshire
    British112830890001
    COLE, Ian Edward
    5 Meadowbank
    DG10 9LR Moffat
    Dumfries & Galloway
    Administrateur
    5 Meadowbank
    DG10 9LR Moffat
    Dumfries & Galloway
    British79462900002
    COLE, Ian Edward
    26 Pinewood Walk
    ML10 6UL Strathaven
    Lanarkshire
    Administrateur
    26 Pinewood Walk
    ML10 6UL Strathaven
    Lanarkshire
    British602400001
    DONNACHIE, Gerard
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    United KingdomBritish602380003
    HEATH, David
    39 Polwarth Street
    Hyndland
    G12 9UE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    39 Polwarth Street
    Hyndland
    G12 9UE Glasgow
    Lanarkshire
    British64815190001
    KERR, Alastair Monteith
    53 Ochilmount
    Bannockburn
    FK7 8PF Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    53 Ochilmount
    Bannockburn
    FK7 8PF Stirling
    Stirlingshire
    British4008980001
    MILLER, John
    13 Rogerhill Gait
    Blackwood
    ML11 9XR Lanark
    Lanarkshire
    Administrateur
    13 Rogerhill Gait
    Blackwood
    ML11 9XR Lanark
    Lanarkshire
    British45748630001
    MILTON, Robert William
    44 Colinhill Road
    ML10 6HF Strathaven
    Lanarkshire
    Administrateur
    44 Colinhill Road
    ML10 6HF Strathaven
    Lanarkshire
    British602390001
    PARK, Douglas Ireland
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Lanarkshire
    GibraltarBritish333600008
    WYPER, Robert Littlejohn
    70 London Road
    KA3 7DD Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    70 London Road
    KA3 7DD Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandScottish6579320001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PARK'S OF HAMILTON (CROFTHEAD GARAGE) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Parks Of Hamilton (Holdings) Limited
    Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    14
    Scotland
    06 avr. 2016
    Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    14
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUk Register Of Companies
    Numéro d'enregistrementSc066568
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    PARK'S OF HAMILTON (CROFTHEAD GARAGE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 13 avr. 1983
    Livré le 21 avr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Renault Loan LTD
    Transactions
    • 21 avr. 1983Enregistrement d'une charge
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 13 avr. 1983
    Livré le 21 avr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • North West Securities LTD
    Transactions
    • 21 avr. 1983Enregistrement d'une charge
    • 23 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 08 avr. 1983
    Livré le 19 avr. 1983
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2.003 and 0.277 acres of ground as described in disposition by john semple dykes in favour of james arneil recorded g r s (lanark) 8/4/1954.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 avr. 1983Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 29 mars 1983
    Livré le 07 avr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • N W S Trust
    Transactions
    • 07 avr. 1983Enregistrement d'une charge
    • 23 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 11 févr. 1983
    Livré le 18 févr. 1983
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 févr. 1983Enregistrement d'une charge
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0