COCKBURN CONSERVATION TRUST (THE)

COCKBURN CONSERVATION TRUST (THE)

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOCKBURN CONSERVATION TRUST (THE)
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société SC066739
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COCKBURN CONSERVATION TRUST (THE) ?

    • Construction de bâtiments commerciaux (41201) / Construction

    Où se situe COCKBURN CONSERVATION TRUST (THE) ?

    Adresse du siège social
    Caledonian Exchange
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de COCKBURN CONSERVATION TRUST (THE) ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour COCKBURN CONSERVATION TRUST (THE) ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mai 2013 sans liste des membres

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John David Campbell le 04 mai 2013

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Caledonian Exchange 19a Canning Street Edinburgh EH3 8HE Scotland le 16 mai 2013

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2012

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mai 2012 sans liste des membres

    8 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de Caledonian Exchange 19a Canning Street Edinburgh EH3 8HE Scotland le 22 mai 2012

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées du secrétaire Lindsays le 04 mai 2012

    2 pagesCH04

    Comptes annuels établis au 30 juin 2011

    20 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mai 2011 sans liste des membres

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Lindsays le 04 mai 2011

    2 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de Caledonian Exchange 19a Canning Street Edinburgh EH3 8HE Scotland le 08 juin 2011

    1 pagesAD01

    legacy

    3 pagesMG02s

    Comptes annuels établis au 30 juin 2010

    20 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mai 2010 sans liste des membres

    6 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de Caledonian Exchange 19a Canning Street Edinburgh EH3 8HE le 18 mai 2010

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées du secrétaire Lindsays Ws le 04 mai 2010

    2 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur David John Black le 04 mai 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Patrick Lowrey le 04 mai 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Colin Bryce le 04 mai 2010

    2 pagesCH01

    legacy

    5 pagesMG01s

    Comptes annuels établis au 30 juin 2009

    20 pagesAA

    legacy

    5 pagesMG01s

    Qui sont les dirigeants de COCKBURN CONSERVATION TRUST (THE) ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LINDSAYS
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    United Kingdom
    Secrétaire
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    United Kingdom
    Forme juridiqueSCOTTISH PARTNERSHIP
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleLAW OF SCOTLAND
    Numéro d'enregistrementNOT APPLICABLE
    110222460002
    BLACK, David John
    17 Lennox Street
    EH4 1PY Edinburgh
    Administrateur
    17 Lennox Street
    EH4 1PY Edinburgh
    ScotlandBritish58713330002
    BRYCE, Colin
    126 Willowbrae Road
    EH8 7HW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    126 Willowbrae Road
    EH8 7HW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish1355350001
    CAMPBELL, John David
    Catcune Steading
    EH23 4RN Gorebridge
    Midlothian
    Administrateur
    Catcune Steading
    EH23 4RN Gorebridge
    Midlothian
    ScotlandBritish111497450001
    LOWREY, John Patrick
    10 (2f1) Montagu Terrace
    Goldenacre
    EH3 5QX Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    10 (2f1) Montagu Terrace
    Goldenacre
    EH3 5QX Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish104393910002
    MARRIAN, Ian Frederic Young
    Walled Garden
    Bowerhouse
    EH42 1RE Dunbar
    East Lothian
    Scotland
    Administrateur
    Walled Garden
    Bowerhouse
    EH42 1RE Dunbar
    East Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish47630100003
    WRIGHT, Margaret Anne
    177 Braid Road
    EH10 6JA Edinburgh
    Administrateur
    177 Braid Road
    EH10 6JA Edinburgh
    ScotlandBritish75785560001
    BARRATT, Oliver William
    Cowmire Hall
    Crosthwaite
    LA8 8JJ Kendal
    Cumbria
    Secrétaire
    Cowmire Hall
    Crosthwaite
    LA8 8JJ Kendal
    Cumbria
    British38411650001
    REITH, David Stewart
    Woodside House
    EH33 2AL Gladsmuir
    East Lothian
    Secrétaire
    Woodside House
    EH33 2AL Gladsmuir
    East Lothian
    British84195850001
    BARRATT, Oliver William
    1 London Street
    EH3 6LZ Edinburgh
    Administrateur
    1 London Street
    EH3 6LZ Edinburgh
    United KingdomBritish38411650002
    BURRELL, Andrew William Lawrence
    34 Reid Terrace
    EH3 5JH Edinburgh
    Administrateur
    34 Reid Terrace
    EH3 5JH Edinburgh
    ScotlandBritish70737480002
    BUTTERS, John Anthony Howard
    30 Moray Place
    EH3 6BX Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    30 Moray Place
    EH3 6BX Edinburgh
    Midlothian
    British3221150001
    CLARE, John Andrew
    Vennel Cottage Goose Green Road
    EH31 2BA Gullane
    East Lothian
    Administrateur
    Vennel Cottage Goose Green Road
    EH31 2BA Gullane
    East Lothian
    British85730001
    CONNELLY, David
    8 Palmerston Road
    EH9 1TN Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    8 Palmerston Road
    EH9 1TN Edinburgh
    Midlothian
    British3221140001
    EMERSON, Anne Grenfell
    52 Blacket Place
    EH9 1RJ Edinburgh
    Administrateur
    52 Blacket Place
    EH9 1RJ Edinburgh
    British58230920001
    FIDDES, James Angus Gordon
    178 Mayfield Road
    EH9 3AX Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    178 Mayfield Road
    EH9 3AX Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish292890002
    GRIMSON, James Thompson Dermot
    3 Dorney House
    Rivermead Close
    TW1 9NL Teddington
    Middlesex
    Administrateur
    3 Dorney House
    Rivermead Close
    TW1 9NL Teddington
    Middlesex
    British99366620002
    LEVEN, David Bruce
    40 Brighton Place
    EH15 1LT Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    40 Brighton Place
    EH15 1LT Edinburgh
    Midlothian
    British112151880001
    LEVINTHAL, Terrence Scott
    2a Albany Street
    EH1 3QB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    2a Albany Street
    EH1 3QB Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish68053340001
    MANN, Rosemary
    St Mary's Street
    EH1 1SU Edinburgh
    2
    Administrateur
    St Mary's Street
    EH1 1SU Edinburgh
    2
    British195810002
    MCALLISTER, Eleanor Catherine Mary
    Flat 3/2
    47 Greendyke Street
    G1 5PX Glasgow
    Administrateur
    Flat 3/2
    47 Greendyke Street
    G1 5PX Glasgow
    ScotlandBritish9120440002
    MCKEAN, Charles Alexander, Professor
    10 Hillpark Road
    EH4 7AW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    10 Hillpark Road
    EH4 7AW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish415020001
    MCNEILL, George Andrew
    Hiltly
    EH49 6PJ Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    Hiltly
    EH49 6PJ Linlithgow
    West Lothian
    ScotlandBritish85810001
    MILNE, Diana Rosemary
    Barondale House
    Newbattle
    EH22 3LX Dalkeith
    Midlothian
    Administrateur
    Barondale House
    Newbattle
    EH22 3LX Dalkeith
    Midlothian
    British22820001
    NEWIS, Kenneth
    11 Abbotsford Park
    EH10 5DZ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    11 Abbotsford Park
    EH10 5DZ Edinburgh
    Midlothian
    British30590001
    REITH, David Stewart
    Woodside House
    EH33 2AL Gladsmuir
    East Lothian
    Administrateur
    Woodside House
    EH33 2AL Gladsmuir
    East Lothian
    ScotlandBritish84195850001
    RUSSELL, Thomas Andrew Sillavan
    6a Regent Terrace
    EH7 5BN Edinburgh
    Administrateur
    6a Regent Terrace
    EH7 5BN Edinburgh
    British479990001
    RUSSELL, Thomas Andrew Sillavan
    6a Regent Terrace
    EH7 5BN Edinburgh
    Administrateur
    6a Regent Terrace
    EH7 5BN Edinburgh
    British479990001
    SIMPSON, Patrick William
    23 Moray Place
    EH3 6DA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    23 Moray Place
    EH3 6DA Edinburgh
    Midlothian
    British76130001
    SMITH, Robert Lupton
    14 Napier Road
    EH10 5AY Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    14 Napier Road
    EH10 5AY Edinburgh
    Midlothian
    British195820001
    SUTHERLAND, Duncan
    Apt 606 Old Sedgewick Mill
    Royal Mills, 2 Cotton Street
    M4 5BW Manchester
    Administrateur
    Apt 606 Old Sedgewick Mill
    Royal Mills, 2 Cotton Street
    M4 5BW Manchester
    EnglandBritish78226760002
    WEIR, Hilary Beatrice
    37 Lansdowne Gardens
    SW8 2EL London
    Administrateur
    37 Lansdowne Gardens
    SW8 2EL London
    British23315700001

    COCKBURN CONSERVATION TRUST (THE) a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 23 mars 2010
    Livré le 26 mars 2010
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Blackburn house blackburn west lothian wln 36056.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of the National Heritage Memorial Fund
    Transactions
    • 26 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 07 déc. 2009
    Livré le 23 déc. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Blackburn house, redhouse road, seafield, bathgate WLN36056.
    Personnes ayant droit
    • West Lothian Council
    Transactions
    • 23 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 29 déc. 2005
    Livré le 17 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects known as and forming blackburn house, blackburn wln 36056.
    Personnes ayant droit
    • The Scottish Ministers
    Transactions
    • 17 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 07 déc. 2005
    Livré le 09 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of a personal bond dated 1 december 2005
    Brèves mentions
    Blackburn house, blackburn, west lothian and the ground pertaining thereto (title number WLN36056).
    Personnes ayant droit
    • The Architectural Heritage Fund
    Transactions
    • 09 déc. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 25 mai 2005
    Livré le 13 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop premises, 51-53 high street, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 juin 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 févr. 2003
    Livré le 08 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop premises, 51-53 high street, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 juil. 1998
    Livré le 30 juil. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    St ninians manse & the granary, quayside street, leith, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Secretary of State for Scotland
    Transactions
    • 30 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mai 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 20 janv. 2000Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 26 juil. 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    Standard security
    Créé le 28 août 1997
    Livré le 08 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground on south side of quayside street,leith,edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Mcgregor & Co (Leith) Limited
    Transactions
    • 08 sept. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mai 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 20 janv. 2000Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 26 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 août 1997
    Livré le 08 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground on the south side of quayside street,leith,edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Architectural Heritage Fund
    Transactions
    • 08 sept. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mai 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 20 janv. 2000Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 26 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 août 1997
    Livré le 08 sept. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground on the south side of quayside street,leith,edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Lothian and Edinburgh Enterprise Limited
    Transactions
    • 08 sept. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mai 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 20 janv. 2000Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 26 juil. 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    Standard security
    Créé le 28 mars 1991
    Livré le 05 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Former independent congregational church, barony street, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 févr. 1983
    Livré le 16 févr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    9 flatted dwellinghouses forming the 1ST, 2ND and 3RD flats above the street or pavement of the tenement known as 2 glanville place, stockbridge, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 févr. 1983Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 21 janv. 1983
    Livré le 28 janv. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    9 flatted dwellinghouses forming the 1ST, 2ND and 3RD flats above the street or pavement of the tenement known as 2 glanville place, stockbridge, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Architectural Heritage Fund
    Transactions
    • 28 janv. 1983Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 20 juil. 1981
    Livré le 07 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    16 & 18 calton hill edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Architectural Heritage Fund
    Transactions
    • 07 août 1981Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0