NORTH BRITISH PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED

NORTH BRITISH PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORTH BRITISH PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC066798
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORTH BRITISH PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe NORTH BRITISH PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    110 Queen Street
    G1 3BX Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de NORTH BRITISH PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour NORTH BRITISH PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 80 George Street Edinburgh EH2 3BU à 110 Queen Street Glasgow G1 3BX le 19 déc. 2016

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 12 déc. 2016

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Graham Stephen Long en tant que directeur le 14 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Pierre Alain Biscay en tant que directeur le 14 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Steven Blackwell en tant que directeur le 14 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Clair Louise Marshall en tant qu'administrateur le 14 nov. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr David Rowley Rose en tant qu'administrateur le 14 nov. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    4 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 25 août 2016

    • Capital: GBP 561,801
    4 pagesSH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 avr. 2016

    État du capital au 06 avr. 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de Yang Song en tant que directeur le 23 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Steven Blackwell en tant qu'administrateur le 23 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Graham Stephen Long en tant qu'administrateur le 16 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Groves en tant que directeur le 21 août 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    8 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 mars 2015

    État du capital au 26 mars 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mr Robert Groves en tant qu'administrateur le 25 sept. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jin-Wee Tan en tant que directeur le 26 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Robert Kipling en tant que directeur le 26 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Yang Song en tant qu'administrateur le 25 sept. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Pierre Alain Biscay en tant qu'administrateur le 25 sept. 2014

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de NORTH BRITISH PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FRIENDS LIFE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Pixham End
    RH4 1QA Dorking
    Surrey
    Secrétaire
    Pixham End
    RH4 1QA Dorking
    Surrey
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement07350629
    154788970001
    MARSHALL, Clair Louise
    YO90 1WR York
    Wellington Row
    United Kingdom
    Administrateur
    YO90 1WR York
    Wellington Row
    United Kingdom
    United KingdomBritish200178890001
    ROSE, David Rowley
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish89567200001
    DRISCOLL, Caroline Mary
    Flat 3, 16 Kidbrooke Grove
    Blackheath
    SE3 0LF London
    Secrétaire
    Flat 3, 16 Kidbrooke Grove
    Blackheath
    SE3 0LF London
    British35886380001
    HERBERT, Anthony James
    21d Tite Street
    SW3 4JT London
    Secrétaire
    21d Tite Street
    SW3 4JT London
    British29028830002
    MORGAN, David John
    Apsley House
    Park Road
    SM7 3DN Banstead
    Surrey
    Secrétaire
    Apsley House
    Park Road
    SM7 3DN Banstead
    Surrey
    British457080001
    RICHARDSON, Ian David Lea
    Gatehouse Farm
    Dinedor
    SE1 3RF Hereford
    Secrétaire
    Gatehouse Farm
    Dinedor
    SE1 3RF Hereford
    British73820300001
    SMALL, Jeremy Peter
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Secrétaire
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    British67168210001
    WALLWORK, Janet Irwin
    51 Eglantine Road
    SW18 2DE London
    Secrétaire
    51 Eglantine Road
    SW18 2DE London
    British32917080002
    WEBSTER, John Dudley
    10 Merrydown Way
    BR7 5RS Chislehurst
    Kent
    Secrétaire
    10 Merrydown Way
    BR7 5RS Chislehurst
    Kent
    British457110001
    AWFORD, Robert Francis
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Administrateur
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    United KingdomBritish89525200002
    BISCAY, Pierre Alain
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Administrateur
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    United KingdomFrench191345190001
    BLACKWELL, David Steven
    EC2R 8EJ London
    No. 1 Poultry
    United Kingdom
    Administrateur
    EC2R 8EJ London
    No. 1 Poultry
    United Kingdom
    United KingdomBritish202271880001
    FAULKNER, Anthony
    7 Weston Close
    Upton Grey
    RG25 2RX Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    7 Weston Close
    Upton Grey
    RG25 2RX Basingstoke
    Hampshire
    British457090001
    FAULKNER, Anthony
    7 Weston Close
    Upton Grey
    RG25 2RX Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    7 Weston Close
    Upton Grey
    RG25 2RX Basingstoke
    Hampshire
    British457090001
    GALLOWAY, Richard William
    6 Comforts Farm Avenue
    Hurst Green
    RH8 9DH Oxted
    Surrey
    Administrateur
    6 Comforts Farm Avenue
    Hurst Green
    RH8 9DH Oxted
    Surrey
    British8013540001
    GROVES, Robert
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Administrateur
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    United KingdomBritish191386770001
    KIPLING, Michael Robert
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Administrateur
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    EnglandBritish89585620002
    LONG, Graham Stephen
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Administrateur
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    United KingdomBritish201016770001
    NICHOLLS, John Michael
    25 Starling Lane
    Cuffley
    EN6 4JX Potters Bar
    Hertfordshire
    Administrateur
    25 Starling Lane
    Cuffley
    EN6 4JX Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandUnited Kingdom457100001
    PARRIS, Stephen Michael
    81 Wentworth Drive
    MK41 8QD Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    81 Wentworth Drive
    MK41 8QD Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish28404670001
    PINNOCK, Richard Mark
    16 Chaucer Road
    MK40 2AJ Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    16 Chaucer Road
    MK40 2AJ Bedford
    Bedfordshire
    British100959840001
    SMITH, Stephen Paul
    Yester Road
    BR7 5HN Chislehurst
    65
    Kent
    Administrateur
    Yester Road
    BR7 5HN Chislehurst
    65
    Kent
    EnglandBritish148183670001
    SONG, Yang
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Administrateur
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    United KingdomBritish191346160001
    TAN, Jin-Wee
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Administrateur
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    United KingdomBritish155013280001
    VERSEY, Mark Richard Beavis
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Administrateur
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    United KingdomBritish154710020001
    WEBSTER, John Dudley
    10 Merrydown Way
    BR7 5RS Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    10 Merrydown Way
    BR7 5RS Chislehurst
    Kent
    British457110001
    YATES, Stephen Richard
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Administrateur
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    British44988640001
    YATES, Stephen Richard
    37 Colebrooke Avenue
    W13 8JZ London
    Administrateur
    37 Colebrooke Avenue
    W13 8JZ London
    British44988640001

    NORTH BRITISH PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 09 déc. 1982
    Livré le 17 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 déc. 1982Enregistrement d'une charge

    NORTH BRITISH PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    25 oct. 2017Dissolved on
    12 déc. 2016Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0