TAYBURN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTAYBURN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC067241
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TAYBURN LIMITED ?

    • Activités de conception spécialisées (74100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TAYBURN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TAYBURN LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TAYBURN DESIGN LIMITED14 juil. 198914 juil. 1989
    TAYBURN LIMITED05 mars 197905 mars 1979

    Quels sont les derniers comptes de TAYBURN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2023

    Quels sont les derniers dépôts pour TAYBURN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Steven Watson Clark en tant que secrétaire le 25 avr. 2024

    1 pagesTM02

    Nomination de David Ross Lewis en tant qu'administrateur le 25 avr. 2024

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 mars 2023

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022

    12 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2021

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020

    8 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 15 Kittle Yards Causewayside Edinburgh EH9 1PJ à 1 Lochrin Square 92-98 Fountainbridge Edinburgh EH3 9QA le 29 sept. 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Malcolm Neil Stewart le 01 mars 2020

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard David Simpson le 01 mars 2020

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2018

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de TAYBURN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEWIS, David Ross
    Vicar Street
    FK1 1LL Falkirk
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Vicar Street
    FK1 1LL Falkirk
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish323760240001
    SIMPSON, Richard David
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    1 Lochrin Square
    Scotland
    Administrateur
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    1 Lochrin Square
    Scotland
    ScotlandBritish140467110002
    STEWART, Malcolm Neil
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    1 Lochrin Square
    Scotland
    Administrateur
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    1 Lochrin Square
    Scotland
    ScotlandBritish79120080003
    CARRUTHERS, Lynn Duncan
    8 Blackwood Green
    Pitreavie Castle
    KY11 8QG Dunfermline
    Secrétaire
    8 Blackwood Green
    Pitreavie Castle
    KY11 8QG Dunfermline
    British47631880004
    CLARK, Steven Watson
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    1 Lochrin Square
    Scotland
    Secrétaire
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    1 Lochrin Square
    Scotland
    186532430001
    DAVIDSON, William Dow
    42 Cameron Street
    KY12 8DP Dunfermline
    Fife
    Secrétaire
    42 Cameron Street
    KY12 8DP Dunfermline
    Fife
    British815790001
    DAVIDSON, William Dow
    42 Cameron Street
    KY12 8DP Dunfermline
    Fife
    Secrétaire
    42 Cameron Street
    KY12 8DP Dunfermline
    Fife
    British815790001
    MONTGOMERY, Sheila Ann
    12 Pumpherston Road
    Mid Calder
    EH53 0AY Livingston
    West Lothian
    Scotland
    Secrétaire
    12 Pumpherston Road
    Mid Calder
    EH53 0AY Livingston
    West Lothian
    Scotland
    British5026880001
    BROWN, Alastair Neil Grant
    2 Queens Crescent
    EH9 2AZ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    2 Queens Crescent
    EH9 2AZ Edinburgh
    Midlothian
    British194090001
    CADBURY, Nicholas Andrew
    46 Swanston Avenue
    EH10 7BZ Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    46 Swanston Avenue
    EH10 7BZ Edinburgh
    Lothian
    United KingdomBritish79122770001
    CASSIDY, Kenneth Vincent
    19a Hazel Avenue
    G66 4RR Lenzie
    Administrateur
    19a Hazel Avenue
    G66 4RR Lenzie
    UkBritish92741650001
    DAVIDSON, Erick
    25a Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    25a Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish26100001
    DAVIDSON, William Dow
    42 Cameron Street
    KY12 8DP Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    42 Cameron Street
    KY12 8DP Dunfermline
    Fife
    ScotlandBritish815790001
    ERDAL, David Edward
    West Court
    Hepburn Gardens
    KY16 9LN St Andrews
    Fife
    Administrateur
    West Court
    Hepburn Gardens
    KY16 9LN St Andrews
    Fife
    United KingdomBritish8000001
    FARRELL, Simon Wilson
    39 Clermiston Road
    Corstorphine
    EH12 6XD Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    39 Clermiston Road
    Corstorphine
    EH12 6XD Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish106463780002
    FORTUNE-SMITH, Gary James
    Drumcrannog
    3b Trinity Park
    TD11 3HN Duns
    Berwickshire
    Administrateur
    Drumcrannog
    3b Trinity Park
    TD11 3HN Duns
    Berwickshire
    United KingdomBritish99342170001
    GIBSON, Archibald Turner
    Gowrie
    8 Succoth Avenue
    EH12 6BT Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Gowrie
    8 Succoth Avenue
    EH12 6BT Edinburgh
    Midlothian
    British120070001
    HAIN, Ronald Baird
    7 Bishop Terrace
    Kinnesswood
    KY13 7JW Kinross
    Fife
    Administrateur
    7 Bishop Terrace
    Kinnesswood
    KY13 7JW Kinross
    Fife
    British338520001
    HODGSON, Robert James
    The Hunting Lodge
    Wadhurst Park
    TN5 6NT Wadhurst
    East Sussex
    Administrateur
    The Hunting Lodge
    Wadhurst Park
    TN5 6NT Wadhurst
    East Sussex
    EnglandBritish54501880002
    HUNTER, Andrew
    Kinloch House 1 Market Street
    EH41 3JL Haddington
    East Lothian
    Administrateur
    Kinloch House 1 Market Street
    EH41 3JL Haddington
    East Lothian
    British559720001
    LAIRD, Campbell Doull
    6 Havens Edge
    KY11 3LJ Limekilns
    Fife
    Administrateur
    6 Havens Edge
    KY11 3LJ Limekilns
    Fife
    ScotlandBritish46830610001
    MCCOLL, Alexander Brendan
    27 Eglinton Crescent
    EH12 5BY Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    27 Eglinton Crescent
    EH12 5BY Edinburgh
    Midlothian
    British338510001
    MITCHELL, Steven
    33 Northumberland Street
    EH3 6LR Edinburgh
    Administrateur
    33 Northumberland Street
    EH3 6LR Edinburgh
    ScotlandBritish40722030002
    NICOLSON, David
    Cluan House
    Dunira
    PH6 2JY Comrie
    Perthshire
    Administrateur
    Cluan House
    Dunira
    PH6 2JY Comrie
    Perthshire
    ScotlandBritish84155610001
    NORRIS, Simon
    4 Orchard Terrace
    EH4 2HA Edinburgh
    Administrateur
    4 Orchard Terrace
    EH4 2HA Edinburgh
    British338530004
    RUSSELL, Graham Lamont
    17a Morningside Road
    EH10 4DP Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    17a Morningside Road
    EH10 4DP Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish338550001
    SCOTT, Andrew Neale
    12 Highbury Hill
    N5 1AL London
    Administrateur
    12 Highbury Hill
    N5 1AL London
    British65030230001
    SKAKEL, Andrew Douglas
    Beech House
    Main Street
    EH35 5HT Ormiston
    East Lothian
    Administrateur
    Beech House
    Main Street
    EH35 5HT Ormiston
    East Lothian
    British38648260001
    SKAKEL, Richard
    10 Forres Street
    EH3 6BJ Edinburgh
    Administrateur
    10 Forres Street
    EH3 6BJ Edinburgh
    British44679350001
    SLATER, John
    43 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    43 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish338270001
    SMITH, Kay Edwina
    43 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    43 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    Midlothian
    British338540001
    WHITEHORN, William Elliott
    31 Dents Road
    SW11 6JA London
    Administrateur
    31 Dents Road
    SW11 6JA London
    United KingdomBritish46878420002
    WOLFFE, Andrew John Antony
    3 Lennox St Lane
    EH4 1PZ Edinburgh
    Administrateur
    3 Lennox St Lane
    EH4 1PZ Edinburgh
    Scottish8985620004

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TAYBURN LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Tayburn Holdings Ltd
    Kittle Yards
    EH9 1PJ Edinburgh
    15
    Scotland
    06 avr. 2016
    Kittle Yards
    EH9 1PJ Edinburgh
    15
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueTayburn Holdings Ltd
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementScotland
    Numéro d'enregistrementSc112753
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    TAYBURN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 01 oct. 2003
    Livré le 07 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 oct. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 mai 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    Letter of offset
    Créé le 06 nov. 1987
    Livré le 19 nov. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by tayburn design group LTD and/or others
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 nov. 1987Enregistrement d'une charge
    • 03 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Letter of offset
    Créé le 17 avr. 1985
    Livré le 01 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by tayburn interior design LTD
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 mai 1985Enregistrement d'une charge
    • 03 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Letter of offset
    Créé le 07 juin 1983
    Livré le 16 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by cockburn taylor holdings LTD and/or others
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts of any accounts held by the bank of scotland in name of tayburn LTD.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 juin 1983Enregistrement d'une charge
    • 03 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 11 mai 1979
    Livré le 23 mai 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 mai 1979Enregistrement d'une charge
    • 03 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0