MERPRO GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMERPRO GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC067714
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MERPRO GROUP LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe MERPRO GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    National Oilwell Varco Badentoy Crescent, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    Aberdeenshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MERPRO GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MERPRO LIMITED27 avr. 197927 avr. 1979

    Quels sont les derniers comptes de MERPRO GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour MERPRO GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    legacy

    2 pagesAC93

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Nomination de Christopher Paul O'neil en tant qu'administrateur le 31 déc. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Simon Scott Reid en tant que directeur le 31 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019

    6 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Alastair James Fleming en tant que directeur le 31 août 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Simon Scott Reid en tant qu'administrateur le 09 juil. 2018

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 nov. 2015

    État du capital au 19 nov. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Christopher Paul O'neil en tant que directeur le 30 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Robbert Oudendijk en tant qu'administrateur le 30 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher Paul O'neil le 22 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de MERPRO GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SLOAN, Alison May
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Secrétaire
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    180812090001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Administrateur
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    United KingdomBritish162062160001
    OUDENDIJK, Robbert
    2806 Hh Gouda
    Tobias Asserstraat 1
    Netherlands
    Administrateur
    2806 Hh Gouda
    Tobias Asserstraat 1
    Netherlands
    NetherlandsDutch201609020001
    FIDDES, Carole
    88 Castle Street
    DD10 8AG Montrose
    Secrétaire
    88 Castle Street
    DD10 8AG Montrose
    British82920570002
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Secrétaire
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    163563190001
    GALLACHER, Kevin Terence, Mr.
    Badentoy Crescent, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    National Oilwell Varco
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    Badentoy Crescent, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    National Oilwell Varco
    Aberdeenshire
    British71782100001
    GALLACHER, Kevin Terence, Mr.
    38 Loraine Road
    DD4 7DZ Dundee
    Angus
    Secrétaire
    38 Loraine Road
    DD4 7DZ Dundee
    Angus
    British71782100001
    O'NEIL, Christopher
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    U.K.
    Secrétaire
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    U.K.
    British159904500001
    TAYLOR, Colin Harwood
    Powis House
    Barnhead
    DD10 9LL Montrose
    Angus
    Secrétaire
    Powis House
    Barnhead
    DD10 9LL Montrose
    Angus
    British1340290001
    ADAMS, John Edward
    Braehead, Kirkton
    St.Cyrus
    DD10 0BW Montrose
    Angus
    Administrateur
    Braehead, Kirkton
    St.Cyrus
    DD10 0BW Montrose
    Angus
    ScotlandBritish988200001
    ADAMS, Margaret
    Braehead, Kirkton
    St Cyrus
    DD10 0BW Montrose
    Angus
    Administrateur
    Braehead, Kirkton
    St Cyrus
    DD10 0BW Montrose
    Angus
    British9495940001
    BOYLE, Thomas Douglas
    Old Inn Road, Findon
    Portlethen
    AB12 3RT Aberdeen
    Lanark
    U.K.
    Administrateur
    Old Inn Road, Findon
    Portlethen
    AB12 3RT Aberdeen
    Lanark
    U.K.
    UkBritish61611910001
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Administrateur
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    ScotlandBritish180854890001
    FUDGE, Sydney Robert
    Brent Avenue
    DD10 9PB Montrose
    Merpro
    Angus
    United Kingdom
    Administrateur
    Brent Avenue
    DD10 9PB Montrose
    Merpro
    Angus
    United Kingdom
    ScotlandBritish10630480001
    GALLACHER, Kevin Terence, Mr.
    Badentoy Crescent, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    National Oilwell Varco
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Badentoy Crescent, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    National Oilwell Varco
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish71782100001
    KEENER, David James
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Oranjestraat 33
    Netherlands
    Administrateur
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Oranjestraat 33
    Netherlands
    NetherlandsUsa161469350001
    MURRAY, Michael Alexander
    2 Palmerston Street
    DD10 8HR Montrose
    Angus
    Administrateur
    2 Palmerston Street
    DD10 8HR Montrose
    Angus
    British988800001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish162062160001
    PARKINSON, David John
    Arodene
    Walton Down
    BS21 7AR Walton In Gordano
    North Somerset
    Administrateur
    Arodene
    Walton Down
    BS21 7AR Walton In Gordano
    North Somerset
    EnglandBritish160406000001
    REID, Simon Scott
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Administrateur
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    ScotlandBritish248254430001
    SMITH, David Robert, Mr.
    Badentoy Crescent, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    National Oilwell Varco
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Badentoy Crescent, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    National Oilwell Varco
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish124662860001
    SMITH, Jennifer Margaret
    Badentoy Crescent, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    National Oilwell Varco
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Badentoy Crescent, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    National Oilwell Varco
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish124662820001
    SMITH, Margaret
    Badentoy Crescent, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    National Oilwell Varco
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Badentoy Crescent, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    National Oilwell Varco
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish9495950001
    SMITH, Robert Melville, Mr.
    Badentoy Crescent, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    National Oilwell Varco
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Badentoy Crescent, Badentoy Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    National Oilwell Varco
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish353890001
    TAYLOR, Colin Harwood
    Powis House
    Barnhead
    DD10 9LL Montrose
    Angus
    Administrateur
    Powis House
    Barnhead
    DD10 9LL Montrose
    Angus
    British1340290001
    VALENTINE, Steven Grenville
    Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    4
    Administrateur
    Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    4
    EnglandBritish92773870002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MERPRO GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Oldends Lane Industrial Estate
    GL10 3RQ Stonehouse
    Stonedale Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Oldends Lane Industrial Estate
    GL10 3RQ Stonehouse
    Stonedale Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00873028
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MERPRO GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 17 juin 1992
    Livré le 01 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The building and ground comprising the former angus workwear premises, forties road, montrose, angus.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 juil. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 06 mars 1985
    Livré le 11 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.06 hectare at brent avenue, montrose, angus with factory, office building and other erections thereon.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 mars 1985Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 06 mars 1985
    Livré le 13 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.06 hectare at brent avenue, montrose, angus with factory, office building and other erection.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry
    Transactions
    • 13 mars 1985Enregistrement d'une charge
    • 23 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 27 févr. 1985
    Livré le 07 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry
    Transactions
    • 07 mars 1985Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 11 avr. 1984
    Livré le 30 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground extending to 908 1/1000TH parts of a hectare and second plot extending 87 1/1000TH parts of a hectare in montrose, angus.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 11 avr. 1984
    Livré le 18 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground extending to 908 1/1000TH parts of a hectare known as brent avenue, montrose in angus.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 18 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    • 23 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 22 déc. 1983
    Livré le 06 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground in angus extending to 2 acres lying on or towards the west of forties road montrose.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 06 janv. 1984Enregistrement d'une charge
    • 23 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 08 déc. 1983
    Livré le 23 déc. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1983Enregistrement d'une charge
    • 30 déc. 1992Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Standard security
    Créé le 05 févr. 1982
    Livré le 12 févr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot of ground in angus extending to 2 acres lying on or towards forties road montrose.
    Personnes ayant droit
    • Industrial and Commercial Finance Corporation LTD
    Transactions
    • 12 févr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 23 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 févr. 1982
    Livré le 19 févr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground in angus extending to 2 acres lying on or towards forties road, montrose.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 févr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 08 déc. 1981
    Livré le 17 déc. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Industrial & Commercial Finance Corporation LTD
    Transactions
    • 17 déc. 1981Enregistrement d'une charge
    • 30 déc. 1992Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 17 juin 1980
    Livré le 26 juin 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 juin 1980Enregistrement d'une charge
    • 08 janv. 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 26 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0