MERPRO GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MERPRO GROUP LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC067714 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MERPRO GROUP LIMITED ?
| Adresse du siège social | National Oilwell Varco Badentoy Crescent, Badentoy Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen Aberdeenshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MERPRO GROUP LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour MERPRO GROUP LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 2 pages | AC93 | ||||||||||
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomination de Christopher Paul O'neil en tant qu'administrateur le 31 déc. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Scott Reid en tant que directeur le 31 déc. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019 | 6 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alastair James Fleming en tant que directeur le 31 août 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Scott Reid en tant qu'administrateur le 09 juil. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Paul O'neil en tant que directeur le 30 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Robbert Oudendijk en tant qu'administrateur le 30 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher Paul O'neil le 22 juil. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MERPRO GROUP LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOAN, Alison May | Secrétaire | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 180812090001 | |||||||
| O'NEIL, Christopher Paul | Administrateur | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | United Kingdom | British | 162062160001 | |||||
| OUDENDIJK, Robbert | Administrateur | 2806 Hh Gouda Tobias Asserstraat 1 Netherlands | Netherlands | Dutch | 201609020001 | |||||
| FIDDES, Carole | Secrétaire | 88 Castle Street DD10 8AG Montrose | British | 82920570002 | ||||||
| FLEMING, Alastair James | Secrétaire | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 163563190001 | |||||||
| GALLACHER, Kevin Terence, Mr. | Secrétaire | Badentoy Crescent, Badentoy Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen National Oilwell Varco Aberdeenshire | British | 71782100001 | ||||||
| GALLACHER, Kevin Terence, Mr. | Secrétaire | 38 Loraine Road DD4 7DZ Dundee Angus | British | 71782100001 | ||||||
| O'NEIL, Christopher | Secrétaire | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire U.K. | British | 159904500001 | ||||||
| TAYLOR, Colin Harwood | Secrétaire | Powis House Barnhead DD10 9LL Montrose Angus | British | 1340290001 | ||||||
| ADAMS, John Edward | Administrateur | Braehead, Kirkton St.Cyrus DD10 0BW Montrose Angus | Scotland | British | 988200001 | |||||
| ADAMS, Margaret | Administrateur | Braehead, Kirkton St Cyrus DD10 0BW Montrose Angus | British | 9495940001 | ||||||
| BOYLE, Thomas Douglas | Administrateur | Old Inn Road, Findon Portlethen AB12 3RT Aberdeen Lanark U.K. | Uk | British | 61611910001 | |||||
| FLEMING, Alastair James | Administrateur | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | 180854890001 | |||||
| FUDGE, Sydney Robert | Administrateur | Brent Avenue DD10 9PB Montrose Merpro Angus United Kingdom | Scotland | British | 10630480001 | |||||
| GALLACHER, Kevin Terence, Mr. | Administrateur | Badentoy Crescent, Badentoy Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen National Oilwell Varco Aberdeenshire | Scotland | British | 71782100001 | |||||
| KEENER, David James | Administrateur | 4819 Xp Rijsbergen Oranjestraat 33 Netherlands | Netherlands | Usa | 161469350001 | |||||
| MURRAY, Michael Alexander | Administrateur | 2 Palmerston Street DD10 8HR Montrose Angus | British | 988800001 | ||||||
| O'NEIL, Christopher Paul | Administrateur | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire United Kingdom | United Kingdom | British | 162062160001 | |||||
| PARKINSON, David John | Administrateur | Arodene Walton Down BS21 7AR Walton In Gordano North Somerset | England | British | 160406000001 | |||||
| REID, Simon Scott | Administrateur | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | 248254430001 | |||||
| SMITH, David Robert, Mr. | Administrateur | Badentoy Crescent, Badentoy Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen National Oilwell Varco Aberdeenshire | Scotland | British | 124662860001 | |||||
| SMITH, Jennifer Margaret | Administrateur | Badentoy Crescent, Badentoy Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen National Oilwell Varco Aberdeenshire | Scotland | British | 124662820001 | |||||
| SMITH, Margaret | Administrateur | Badentoy Crescent, Badentoy Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen National Oilwell Varco Aberdeenshire | Scotland | British | 9495950001 | |||||
| SMITH, Robert Melville, Mr. | Administrateur | Badentoy Crescent, Badentoy Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen National Oilwell Varco Aberdeenshire | Scotland | British | 353890001 | |||||
| TAYLOR, Colin Harwood | Administrateur | Powis House Barnhead DD10 9LL Montrose Angus | British | 1340290001 | ||||||
| VALENTINE, Steven Grenville | Administrateur | Barnes Close Haslington CW1 5ZG Crewe 4 | England | British | 92773870002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MERPRO GROUP LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Oilwell Varco Uk Limited | 06 avr. 2016 | Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse Stonedale Road Gloucestershire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
MERPRO GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Créé le 17 juin 1992 Livré le 01 juil. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The building and ground comprising the former angus workwear premises, forties road, montrose, angus. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 06 mars 1985 Livré le 11 mars 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 1.06 hectare at brent avenue, montrose, angus with factory, office building and other erections thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 06 mars 1985 Livré le 13 mars 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 1.06 hectare at brent avenue, montrose, angus with factory, office building and other erection. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 27 févr. 1985 Livré le 07 mars 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 11 avr. 1984 Livré le 30 avr. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Ground extending to 908 1/1000TH parts of a hectare and second plot extending 87 1/1000TH parts of a hectare in montrose, angus. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 11 avr. 1984 Livré le 18 avr. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Ground extending to 908 1/1000TH parts of a hectare known as brent avenue, montrose in angus. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 22 déc. 1983 Livré le 06 janv. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Area of ground in angus extending to 2 acres lying on or towards the west of forties road montrose. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 08 déc. 1983 Livré le 23 déc. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Standard security | Créé le 05 févr. 1982 Livré le 12 févr. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Plot of ground in angus extending to 2 acres lying on or towards forties road montrose. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 05 févr. 1982 Livré le 19 févr. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Area of ground in angus extending to 2 acres lying on or towards forties road, montrose. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 08 déc. 1981 Livré le 17 déc. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 17 juin 1980 Livré le 26 juin 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0