SWANKIE'S FOOD PRODUCTS LIMITED

SWANKIE'S FOOD PRODUCTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSWANKIE'S FOOD PRODUCTS LIMITED
    Statut de la sociétéReceveur désigné
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC068571
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SWANKIE'S FOOD PRODUCTS LIMITED ?

    • (1520) /
    • (1533) /

    Où se situe SWANKIE'S FOOD PRODUCTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bishops Court
    29 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SWANKIE'S FOOD PRODUCTS LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2001
    Date d'échéance des prochains comptes31 oct. 2002
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2000

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SWANKIE'S FOOD PRODUCTS LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au31 déc. 2016
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 janv. 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SWANKIE'S FOOD PRODUCTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour SWANKIE'S FOOD PRODUCTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    1 pages287

    Avis du rapport du séquestre

    15 pages3.5(Scot)

    Avis de cessation d'activité en tant que séquestre ou gérant

    3 pages3(Scot)

    legacy

    1 pages287

    Avis de la nomination d'un séquestre par un détenteur d'une sûreté flottante

    4 pages1(Scot)

    legacy

    9 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2000

    16 pagesAA

    legacy

    5 pages419a(Scot)

    legacy

    5 pages419a(Scot)

    legacy

    5 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    État des affaires

    28 pagesSA

    legacy

    2 pages88(2)R

    legacy

    2 pages88(2)R

    legacy

    2 pages88(2)R

    legacy

    6 pages363s
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    annual-return27 févr. 2001

    legacy

    363(353)
    annual-return27 févr. 2001

    legacy

    363(288)
    annual-return27 févr. 2001

    legacy

    363(190)

    legacy

    5 pages419a(Scot)

    legacy

    1 pages225

    Statuts

    8 pagesMEM/ARTS

    legacy

    1 pages123

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution spéciale

    SRES13

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution spéciale

    SRES13

    Qui sont les dirigeants de SWANKIE'S FOOD PRODUCTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    A C MORRISON & RICHARDS
    18 Bon-Accord Crescent
    AB11 6XY Aberdeen
    Grampian
    Secrétaire
    18 Bon-Accord Crescent
    AB11 6XY Aberdeen
    Grampian
    37220001
    FAULKNER, John Aylmer
    Delamere Apartments
    Vale Royal Abbey Whitegate
    CW8 2BA Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    Delamere Apartments
    Vale Royal Abbey Whitegate
    CW8 2BA Northwich
    Cheshire
    British91895570001
    LAW, John Allan
    8 Stronsay Drive
    AB2 6EA Aberdeen
    Administrateur
    8 Stronsay Drive
    AB2 6EA Aberdeen
    ScotlandBritish46210960002
    ROBERTSON, James
    Dundonnachaidh
    AB13 0NQ Milltimber
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Dundonnachaidh
    AB13 0NQ Milltimber
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish1402600002
    SHAND, Alan Graham
    Tutties Neuk Flat
    Dundee Road
    DD11 2PT Arbroath
    Angus
    Secrétaire
    Tutties Neuk Flat
    Dundee Road
    DD11 2PT Arbroath
    Angus
    British42360790002
    HANCOCK, Geoffrey Charles
    The Grange
    LE17 6NE North Kilwortth
    Leicestershire
    Administrateur
    The Grange
    LE17 6NE North Kilwortth
    Leicestershire
    United KingdomBritish28516220001
    MARNOCH, William Berry
    Cairnwood
    Hartree
    ML12 6JJ Biggar
    Lanarkshire
    Administrateur
    Cairnwood
    Hartree
    ML12 6JJ Biggar
    Lanarkshire
    British779840001
    ROBERTSON, Michael
    Highview House
    Cults
    AB15 9BE Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Highview House
    Cults
    AB15 9BE Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish55729810002
    SHAND, Alan Graham
    Tutties Neuk Flat
    Dundee Road
    DD11 2PT Arbroath
    Angus
    Administrateur
    Tutties Neuk Flat
    Dundee Road
    DD11 2PT Arbroath
    Angus
    British42360790002
    SHAND, Alastair Adams
    Inverusan
    Montrose
    Angus
    Administrateur
    Inverusan
    Montrose
    Angus
    British673090001
    SHAND, Jean
    Inverusan
    Montrose
    Angus
    Administrateur
    Inverusan
    Montrose
    Angus
    British673100001
    SHAND, Ronald Adams
    Old School House Crosshill
    Guthrie
    DD11 1BT Forfar
    Angus
    Administrateur
    Old School House Crosshill
    Guthrie
    DD11 1BT Forfar
    Angus
    British27224830001

    SWANKIE'S FOOD PRODUCTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 29 janv. 2001
    Livré le 31 janv. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 janv. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 janv. 2002Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (1 Scot)
    • 09 avr. 2002Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (3 Scot)
      • Numéro de dossier 1
    Floating charge
    Créé le 29 déc. 1999
    Livré le 11 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Euro Sales Finance PLC
    Transactions
    • 11 janv. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 janv. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 29 mai 1998
    Livré le 05 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kellock Limited
    Transactions
    • 05 juin 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 sept. 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 févr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 06 juin 1997
    Livré le 20 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Tsb Asset Finance Limited
    Transactions
    • 20 juin 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 janv. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 06 juin 1997
    Livré le 20 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 20 juin 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 janv. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 05 déc. 1989
    Livré le 21 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2 areas of ground at west kirkton, arbroath (5098.55 and 7019.85 square metres).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 04 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 mai 1986
    Livré le 27 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.10 hectares or thereby at west john street, arbroath, angus.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 mai 1986Enregistrement d'une charge
    • 04 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 03 août 1983
    Livré le 16 août 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 août 1983Enregistrement d'une charge
    • 30 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 28 avr. 1981
    Livré le 30 avr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 30 avr. 1981Enregistrement d'une charge

    SWANKIE'S FOOD PRODUCTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 janv. 2001Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gordon Malcolm Maclure
    Hlb Kidsons
    11 Albyn Place
    AB10 1YE Aberdeen
    practitioner
    Hlb Kidsons
    11 Albyn Place
    AB10 1YE Aberdeen
    Maureen Elizabeth Leslie
    23 Queen Street
    Edinburgh
    EH2 1JX
    practitioner
    23 Queen Street
    Edinburgh
    EH2 1JX
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0