SPEEDY LCH GENERATORS LIMITED

SPEEDY LCH GENERATORS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSPEEDY LCH GENERATORS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC068997
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SPEEDY LCH GENERATORS LIMITED ?

    • Location et location d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (77390) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe SPEEDY LCH GENERATORS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    13 Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SPEEDY LCH GENERATORS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LCH GENERATORS LIMITED01 juin 198901 juin 1989
    L. C. H. DIESELS LIMITED01 août 197901 août 1979

    Quels sont les derniers comptes de SPEEDY LCH GENERATORS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2025
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SPEEDY LCH GENERATORS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au30 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au30 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour SPEEDY LCH GENERATORS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2024

    8 pagesAA
    ADFC5LIH

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XD6XEAYY

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023

    8 pagesAA
    ACIS5XH4

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XC74AQBU

    Nomination de Mr Paul Adrian Rayner en tant qu'administrateur le 09 déc. 2022

    2 pagesAP01
    XBJ918WY

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    8 pagesAA
    SBIY2YMX

    Cessation de la nomination de James Richard Bunn en tant que directeur le 09 déc. 2022

    1 pagesTM01
    XBIVICQH

    Nomination de Daniel John Evans en tant qu'administrateur le 01 oct. 2022

    2 pagesAP01
    XBEED28Y

    Cessation de la nomination de Russell Down en tant que directeur le 30 sept. 2022

    1 pagesTM01
    XBEECA54

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XB798PP4

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04
    AAYMOHRF

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    4 pagesMR04
    AAYMOHR7

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    4 pagesMR04
    AAY7F7UZ

    Satisfaction de la charge SC0689970026 en totalité

    4 pagesMR04
    AAY7F7SJ

    Satisfaction de la charge 17 en totalité

    4 pagesMR04
    AAY7F7V7

    Satisfaction de la charge SC0689970025 en totalité

    4 pagesMR04
    AAY7F7SR

    Satisfaction de la charge SC0689970023 en totalité

    4 pagesMR04
    AAY7F7SB

    Satisfaction de la charge SC0689970020 en totalité

    4 pagesMR04
    AAY7F7RF

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    4 pagesMR04
    AAY7F7RN

    Satisfaction de la charge SC0689970021 en totalité

    4 pagesMR04
    AAY7F7QG

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    4 pagesMR04
    AAY7F7RV

    Satisfaction de la charge SC0689970024 en totalité

    4 pagesMR04
    AAY7F7I9

    Satisfaction de la charge SC0689970022 en totalité

    4 pagesMR04
    AAY7F7R7

    Satisfaction de la charge SC0689970019 en totalité

    4 pagesMR04
    AAY7F7QW

    Satisfaction de la charge 18 en totalité

    4 pagesMR04
    AAY7F7QO

    Qui sont les dirigeants de SPEEDY LCH GENERATORS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HUNT, Neil John
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Secrétaire
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    238485930001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    EVANS, Daniel John
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive272760890001
    RAYNER, Paul Adrian
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant45628680002
    BLAIR, James Edward
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Secrétaire
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    168697390001
    KONCAREVIC, Suzana
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Secrétaire
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    British139800190001
    MCGRATH, Michael Andrew
    Abbey Barn
    Macclesfield Road
    SK11 9AH Chelford
    Cheshire
    Secrétaire
    Abbey Barn
    Macclesfield Road
    SK11 9AH Chelford
    Cheshire
    BritishDirector82005890002
    O'BRIEN, Neil Christopher
    7a The Crescent
    CW8 1QS Hartford
    Cheshire
    Secrétaire
    7a The Crescent
    CW8 1QS Hartford
    Cheshire
    BritishDirector58219210002
    PIRRIE, James
    11 Milverton Avenue
    Bearsden
    G61 4BE Glasgow
    Secrétaire
    11 Milverton Avenue
    Bearsden
    G61 4BE Glasgow
    BritishDirector578000003
    RAWNSLEY, Patrick James
    Grove Avenue
    LS29 9PL Ilkley
    The Ghyll
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Grove Avenue
    LS29 9PL Ilkley
    The Ghyll
    West Yorkshire
    Other108571170002
    ANDERSON, Thomas
    56 Glen Dochart Drive
    Saint Andrews Gate
    G68 0FJ Graigmarloch
    Cumbernauld
    Administrateur
    56 Glen Dochart Drive
    Saint Andrews Gate
    G68 0FJ Graigmarloch
    Cumbernauld
    BritishEngineer48776940002
    ATKIN, Tracey Maria
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Assets & Information Director191937420001
    BELL, David Robert
    Kelvingrove
    Garelochhead
    G84 0EL Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Kelvingrove
    Garelochhead
    G84 0EL Helensburgh
    Dunbartonshire
    ScotlandBritishCompany Director127655660001
    BENNETT, Antony
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Development Officer131483020001
    BOWIE, William James
    Fullarton Drive
    Cambuslang Investment Park
    G32 8FE Glasgow
    85
    United Kingdom
    Administrateur
    Fullarton Drive
    Cambuslang Investment Park
    G32 8FE Glasgow
    85
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director204819630001
    BRIGHOUSE, David John
    1 Oak Drive
    Burscough
    L40 5BQ Ormskirk
    Lancashire
    Administrateur
    1 Oak Drive
    Burscough
    L40 5BQ Ormskirk
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director110538850001
    BUNN, James Richard
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer274171570001
    CAREY, Marianne
    11 Milverton Avenue
    Bearsden
    G61 4BE Glasgow
    Administrateur
    11 Milverton Avenue
    Bearsden
    G61 4BE Glasgow
    BritishWriter578030003
    CARTER, Andrew David
    15 Comberbach Drive
    CW5 7GS Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    15 Comberbach Drive
    CW5 7GS Nantwich
    Cheshire
    BritishCompany Director68422570002
    CORCORAN, Steven James
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector39358260003
    DOWN, Russell
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive253603400001
    EVANS, Daniel John
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Operating Officer272760890001
    KRIGE, Lynette Gillian
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector90566820002
    MCGRATH, Michael Andrew
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector82005890002
    MORGAN, Thomas Christopher
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector168031500001
    O'BRIEN, Neil Christopher
    7a The Crescent
    CW8 1QS Hartford
    Cheshire
    Administrateur
    7a The Crescent
    CW8 1QS Hartford
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector58219210002
    PIRRIE, Glynis Milner Palman
    10 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    Administrateur
    10 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    BritishBank Clerk578020002
    PIRRIE, James
    11 Milverton Avenue
    Bearsden
    G61 4BE Glasgow
    Administrateur
    11 Milverton Avenue
    Bearsden
    G61 4BE Glasgow
    BritishDirector578000003
    PIRRIE, John
    60 Douglas Muir Drive
    Milngavie
    G62 7RJ Glasgow
    Administrateur
    60 Douglas Muir Drive
    Milngavie
    G62 7RJ Glasgow
    BritishDirector93939170001
    READ, Justin Richard
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director67023680001
    ROGERSON, Mark
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Operating Officer168247970001
    SUTHERLAND, Andrew Campbell
    Fairways, 28 Gadloch Avenue
    Lenzie
    G66 5NP Glasgow
    Administrateur
    Fairways, 28 Gadloch Avenue
    Lenzie
    G66 5NP Glasgow
    ScotlandBritishChartered Accountant86050600001
    VERITIERO, Claudio
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    16 The Parks
    WA12 0JQ Newton-Le-Willows
    Chase House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director120476150001
    WHITWORTH, Mark
    2 Old Beechfield Gardens
    WN6 0UR Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    2 Old Beechfield Gardens
    WN6 0UR Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director120679580001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SPEEDY LCH GENERATORS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    2 1/2 Devonshire Square
    EC2M 4BA London
    Premier Place
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    2 1/2 Devonshire Square
    EC2M 4BA London
    Premier Place
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom (England And Wales)
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02459831
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0